ABSOLUTE RADIO LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéABSOLUTE RADIO LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02674136
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ABSOLUTE RADIO LIMITED ?

    • Radiodiffusion (60100) / Information et communication

    Où se situe ABSOLUTE RADIO LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Media House Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ABSOLUTE RADIO LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    TIML RADIO LIMITED12 sept. 200812 sept. 2008
    VIRGIN RADIO LIMITED18 déc. 199218 déc. 1992
    INDEPENDENT MUSIC RADIO LIMITED 31 janv. 199231 janv. 1992
    ROCK 1215 LIMITED21 janv. 199221 janv. 1992
    MARK 2179 LIMITED24 déc. 199124 déc. 1991

    Quels sont les derniers comptes de ABSOLUTE RADIO LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2019

    Quels sont les derniers dépôts pour ABSOLUTE RADIO LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 déc. 2019

    23 pagesAA

    legacy

    38 pagesPARENT_ACC

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2019 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 03 déc. 2019

    • Capital: GBP 1
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2018

    28 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des coordonnées du secrétaire Bauer Group Secretariat Limited le 25 sept. 2018

    1 pagesCH04

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Sarah Jane Vickery le 25 sept. 2018

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Paul Keenan le 25 sept. 2018

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2017

    41 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    legacy

    1 pagesSH20

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Cancellation of share premium account 13/12/2017
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    État du capital au 14 déc. 2017

    • Capital: GBP 5,959,750
    5 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Qui sont les dirigeants de ABSOLUTE RADIO LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BAUER GROUP SECRETARIAT LIMITED
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    England
    Secrétaire
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    England
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement00944753
    159023720001
    FORD, Deidre Ann
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    Administrateur
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    United KingdomBritish109666380002
    KEENAN, Paul Anthony
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    Administrateur
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    EnglandBritish243390510001
    VICKERY, Sarah Jane
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    Administrateur
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    EnglandBritish119137220004
    CLARKE, Sara
    Old Stable Cottage
    Old Barn Farm, Uplawmoor
    G78 4AZ Glasgow
    Secrétaire
    Old Stable Cottage
    Old Barn Farm, Uplawmoor
    G78 4AZ Glasgow
    British77963580002
    DAVIDSON, Dawn
    Langhaugh
    Carmichael
    ML12 6PQ Biggar
    Lanarkshire
    Secrétaire
    Langhaugh
    Carmichael
    ML12 6PQ Biggar
    Lanarkshire
    British51065860001
    FLYNN, Roger Patrick
    4 Doneraile Street
    Fulham
    SW6 6EN London
    Secrétaire
    4 Doneraile Street
    Fulham
    SW6 6EN London
    British66703670003
    LEGGE, Diana Patricia
    24a Enderby Street
    SE10 9PF London
    Secrétaire
    24a Enderby Street
    SE10 9PF London
    British66675910001
    ROBINSON, Adrian Mervyn
    6 Glenard Hall
    Goatstown Road
    IRISH Clonskeagh
    Dublin 14
    Ireland
    Secrétaire
    6 Glenard Hall
    Goatstown Road
    IRISH Clonskeagh
    Dublin 14
    Ireland
    Irish77585790001
    TAMES, Jane Elizabeth Anne
    5 Hatfield Drive
    Kelvinside
    G12 0XZ Glasgow
    Secrétaire
    5 Hatfield Drive
    Kelvinside
    G12 0XZ Glasgow
    British118367070001
    ZAMET, Naomi Rae
    Flat 1 Merlin House Oak Hill Park
    Frognal Hampstead
    NW3 7LJ London
    Secrétaire
    Flat 1 Merlin House Oak Hill Park
    Frognal Hampstead
    NW3 7LJ London
    British42158970002
    ZIPRIN, Geoffrey Charles
    The Old Carters House
    53 Chenies Village
    WD3 6EQ Bucks
    Secrétaire désigné
    The Old Carters House
    53 Chenies Village
    WD3 6EQ Bucks
    British900001590001
    AUMONIER, John Martin
    Little Heath Nyetimber Lane
    West Chiltington
    RH20 2ND Pulborough
    West Sussex
    Administrateur
    Little Heath Nyetimber Lane
    West Chiltington
    RH20 2ND Pulborough
    West Sussex
    Other63227690001
    BLACKABY, Oliver Guy
    Cholmeley Crescent
    Highgate
    N6 5EX London
    47
    Administrateur
    Cholmeley Crescent
    Highgate
    N6 5EX London
    47
    United KingdomBritish131001170001
    CAMPBELL, David Lachlan
    GU28
    Administrateur
    GU28
    EnglandBritish58507320001
    DEVEREUX, Robert Harold Ferrers
    5 Ladbroke Terrace
    W11 3PG London
    Administrateur
    5 Ladbroke Terrace
    W11 3PG London
    EnglandBritish68747470001
    DHARIWAL, Ravindra
    Oopp Nv Farms, Khasra No 1523
    Sub Po S P School
    110030 Bhatti Mines
    Ashray Farms
    Asola Village New Delhi
    India
    Administrateur
    Oopp Nv Farms, Khasra No 1523
    Sub Po S P School
    110030 Bhatti Mines
    Ashray Farms
    Asola Village New Delhi
    India
    IndiaIndian137478960001
    EMSLIE, Donald Gordon
    32 Drumsheugh Gardens
    EH3 7RN Edinburgh
    Administrateur
    32 Drumsheugh Gardens
    EH3 7RN Edinburgh
    ScotlandBritish61177720002
    FLANAGAN, Andrew Henry
    7 Collylinn Road
    Bearsden
    G61 4PN Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    7 Collylinn Road
    Bearsden
    G61 4PN Glasgow
    Lanarkshire
    United KingdomBritish42787120004
    FLYNN, Roger Patrick
    4 Doneraile Street
    Fulham
    SW6 6EN London
    Administrateur
    4 Doneraile Street
    Fulham
    SW6 6EN London
    EnglandBritish66703670003
    GYNGELL, Bruce
    57 Oakley Street
    SW3 5HB London
    Administrateur
    57 Oakley Street
    SW3 5HB London
    Australian25950350001
    HAZLITT, Frances
    73 Finlay Street
    SW6 6HF London
    Administrateur
    73 Finlay Street
    SW6 6HF London
    British110554850001
    HUGHES, Gary William
    64 Crown Road North
    Dowanhill
    G12 9HW Glasgow
    Administrateur
    64 Crown Road North
    Dowanhill
    G12 9HW Glasgow
    UkBritish72256160002
    HUNTINGFORD, Richard Norman Legh
    11 Baronsmead Road
    Barnes
    SW13 9RR London
    Administrateur
    11 Baronsmead Road
    Barnes
    SW13 9RR London
    United KingdomBritish3297910006
    IBBETT, Kenneth Richard Andre
    31 Aldridge Road Villas
    W11 1BN London
    Administrateur
    31 Aldridge Road Villas
    W11 1BN London
    United KingdomBritish34929900001
    JACKSON, Paul
    Geeta
    London Road
    SL5 9RY Sunningdale
    Berkshire
    Administrateur
    Geeta
    London Road
    SL5 9RY Sunningdale
    Berkshire
    British117927650001
    LEVISON, Charles John Cuthbertson
    40 Kensington Park Gardens
    W11 2QT London
    Administrateur
    40 Kensington Park Gardens
    W11 2QT London
    British76794220002
    MANFREY, Barbara Louise
    55 Palace Gardens Terrace
    W8 4RU London
    Administrateur
    55 Palace Gardens Terrace
    W8 4RU London
    American34084460002
    MOLLETT, Andrew
    4 White Heron Mews
    Park Lane
    TW11 0JQ Teddington
    Middlesex
    Administrateur
    4 White Heron Mews
    Park Lane
    TW11 0JQ Teddington
    Middlesex
    British47101600001
    PARIGI, Amba Preetham
    10th Floor, Flat 102, A Wing
    66 Napean Sea Road
    400 036 Mumbai
    Petit Hall Tahnee Heights Chsl
    Mumbai
    India
    Administrateur
    10th Floor, Flat 102, A Wing
    66 Napean Sea Road
    400 036 Mumbai
    Petit Hall Tahnee Heights Chsl
    Mumbai
    India
    IndiaIndian134398470002
    PEARSON, Anthony John
    Scamells Corner Red Lane
    Blackbrook
    RH5 4DU Dorking
    Surrey
    Administrateur
    Scamells Corner Red Lane
    Blackbrook
    RH5 4DU Dorking
    Surrey
    UkBritish44001900002
    PEARSON, Anthony John
    Scamells Corner Red Lane
    Blackbrook
    RH5 4DU Dorking
    Surrey
    Administrateur
    Scamells Corner Red Lane
    Blackbrook
    RH5 4DU Dorking
    Surrey
    UkBritish44001900002
    PHIPPEN, Peter Sangster
    Templewood Lane
    Stoke Poges
    SL2 4BG Slough
    "Oak Acre"
    England
    Administrateur
    Templewood Lane
    Stoke Poges
    SL2 4BG Slough
    "Oak Acre"
    England
    EnglandBritish32688550001
    POTTER, Irene
    55 Peel Place
    Clayhall Avenue
    IG5 0PT Ilford
    Essex
    Administrateur désigné
    55 Peel Place
    Clayhall Avenue
    IG5 0PT Ilford
    Essex
    British900001600001
    SHAH, Sanjeev
    Next To Maulya Centre, Senapati Bapat Marg,
    Lower Parel
    400 013 Mumbai
    A/203 2nd Floor Casea Grande Tower
    India
    Administrateur
    Next To Maulya Centre, Senapati Bapat Marg,
    Lower Parel
    400 013 Mumbai
    A/203 2nd Floor Casea Grande Tower
    India
    IndiaIndian148788520001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur ABSOLUTE RADIO LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Bauer Ar Holdings Limited
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    England
    06 avr. 2016
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleUnited Kingdom (England)
    Lieu d'enregistrementComapnies House
    Numéro d'enregistrement03359692
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    ABSOLUTE RADIO LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Corporate loan agreement
    Créé le 14 déc. 2009
    Livré le 23 déc. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The assets, both moveable and immoveable see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Timl Global Limited
    Transactions
    • 23 déc. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 07 août 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Supplemental security agreement
    Créé le 16 févr. 2004
    Livré le 03 mars 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The trademarks and design rights specified next to its name in schedule 2 of the agreement under the heading specific intellectual property rights; any copyright or other intellectual property monopoly right in any of the above; or any interest (including by way of licence) in any of the above. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 03 mars 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 nov. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Security agreement
    Créé le 04 avr. 2003
    Livré le 16 avr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company or any other of the obligors to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC as Agent on Trust for the Finance Parties (The Security Trustee)
    Transactions
    • 16 avr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 nov. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Security agreement
    Créé le 18 juil. 2002
    Livré le 24 juil. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (The Security Trustee)
    Transactions
    • 24 juil. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 avr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Hedging debenture
    Créé le 30 avr. 1998
    Livré le 18 mai 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each of the obligors (as defined) to banque paribas (as security trustee for itself and the hedge provider) and to the hedge provider under the hedging documents together with all costs,charges and expenses incurred by the hedge provder and/or the security trustee in connection with the protection,preservation or enforcement of it's respective rights under the hedging documents
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Banque Paribas
    Transactions
    • 18 mai 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 mai 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 08 déc. 1997
    Livré le 24 déc. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each of the obligors to the secured creditors(or any of them) under each of the senior facility documents
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Banque Paribas(As Security Trustee)
    Transactions
    • 24 déc. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 mai 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 20 mars 1997
    Livré le 27 mars 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys obligations and liabilities now due or to become due from the company to the chargees pursuant to the terms of the facility documents and/or this debenture
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over land (as defined) broadcasting licences all rights of the company uner or in respect of the broadcasting licences. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bankers Trust Company as Security Trustee for the Beneficiaries (As Defined)
    Transactions
    • 27 mars 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 déc. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 06 janv. 1995
    Livré le 13 janv. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 13 janv. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 avr. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    An issue of secured debentures in a series
    Créé le 13 déc. 1993
    Livré le 23 déc. 1993
    Totalement satisfaite
    Transactions
    • 23 déc. 1993Enregistrement d'une émission de débentures sécurisées en série (397a)
    • 09 déc. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A registered charge
    Créé le 31 août 1993
    Livré le 02 sept. 1993
    Totalement satisfaite
    Transactions
    • 02 sept. 1993Enregistrement d'une émission de débentures sécurisées en série (397a)
    • 09 déc. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A registered charge
    Créé le 24 août 1993
    Livré le 02 sept. 1993
    Totalement satisfaite
    Transactions
    • 02 sept. 1993Enregistrement d'une émission de débentures sécurisées en série (397a)
    • 09 déc. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A registered charge
    Créé le 05 juil. 1993
    Livré le 23 juil. 1993
    Totalement satisfaite
    Personnes ayant droit
    • Not Known.
    Transactions
    • 23 juil. 1993Enregistrement d'une émission de débentures sécurisées en série (397a)
    • 09 déc. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A registered charge
    Créé le 28 juin 1993
    Livré le 29 juin 1993
    Totalement satisfaite
    Transactions
    • 29 juin 1993Enregistrement d'une émission de débentures sécurisées en série (397a)
    • 09 déc. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Issue of secured debentures
    Créé le 21 juin 1993
    Livré le 25 juin 1993
    Totalement satisfaite
    Transactions
    • 25 juin 1993Enregistrement d'une émission de débentures sécurisées en série (397a)
    • 09 déc. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Series of debentures
    Créé le 21 mai 1993
    Livré le 01 juin 1993
    Totalement satisfaite
    Personnes ayant droit
    • None
    Transactions
    • 01 juin 1993Enregistrement d'une émission de débentures sécurisées en série (397a)
    • 09 déc. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Issue
    Créé le 23 avr. 1993
    Livré le 10 mai 1993
    Totalement satisfaite
    Personnes ayant droit
    • None
    Transactions
    • 10 mai 1993Enregistrement d'une émission de débentures sécurisées en série (397a)
    • 09 déc. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Series of debentures
    Créé le 08 mars 1993
    Livré le 12 mars 1993
    Totalement satisfaite
    Personnes ayant droit
    • Virgin Communications Limited
    Transactions
    • 12 mars 1993Enregistrement d'une émission de débentures sécurisées en série (397a)
    • 03 mai 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Series of debentures
    Créé le 08 mars 1993
    Livré le 12 mars 1993
    Date de l'acte de garantie 08 mars 1993
    Totalement satisfaite
    Personnes ayant droit
    • Virgin Communications Limited
    Transactions
    • 12 mars 1993Enregistrement d'une charge pour garantir une série de débentures (397)
    • 09 déc. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of rent deposit
    Créé le 19 janv. 1993
    Livré le 27 janv. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Forsecuring £50,000.00 due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    Pursuant to clause 2 (f) of the deed of rent deposit referred to virgin radio limited agreed to charge £50,000 to trafalgar house developments limited as security for the performance of its obligation in a lease dated 19/1/93 relating to the 2ND 3RD and 4TH floors 1 golden square london W1 and performance of its obligation in the rent deposit deed of the aforesaid date.
    Personnes ayant droit
    • Trafalgar House Developments Limited
    Transactions
    • 27 janv. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 avr. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0