WORLD MARKET INTELLIGENCE LIMITED

WORLD MARKET INTELLIGENCE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéWORLD MARKET INTELLIGENCE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02676810
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de WORLD MARKET INTELLIGENCE LIMITED ?

    • Autres activités de services d'information n.c.a. (63990) / Information et communication

    Où se situe WORLD MARKET INTELLIGENCE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    John Carpenter House
    John Carpenter Street
    EC4Y 0AN London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de WORLD MARKET INTELLIGENCE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    PROGRESSIVE MEDIA PUBLISHING LIMITED10 août 200910 août 2009
    PROGRESSIVE MEDIA MARKETS LIMITED29 oct. 200729 oct. 2007
    WILMINGTON MEDIA LIMITED01 juin 200101 juin 2001
    WILMINGTON PUBLISHING LIMITED16 avr. 199216 avr. 1992
    GRADEBRAVE LIMITED13 janv. 199213 janv. 1992

    Quels sont les derniers comptes de WORLD MARKET INTELLIGENCE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2021

    Quels sont les derniers dépôts pour WORLD MARKET INTELLIGENCE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    État du capital au 03 juil. 2023

    • Capital: GBP 0.10
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Share premium account cancelled/amount credited to a reserve 23/06/2023
    RES13

    Cessation de la nomination de Michael Thomas Danson en tant que directeur le 31 mai 2023

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Robert James Hooper en tant que secrétaire le 08 févr. 2023

    2 pagesAP03

    Déclaration de confirmation établie le 13 janv. 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Inscription de la charge 026768100014, créée le 08 août 2022

    63 pagesMR01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2021

    27 pagesAA

    Inscription de la charge 026768100013, créée le 21 juin 2022

    61 pagesMR01

    Cessation de la nomination de Charles Eugene Shackleton Strickland en tant que secrétaire le 21 janv. 2022

    1 pagesTM02

    Déclaration de confirmation établie le 13 janv. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Inscription de la charge 026768100012, créée le 15 déc. 2021

    61 pagesMR01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2020

    31 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Graham Charles Lilley le 20 nov. 2020

    2 pagesCH01

    Déclaration de confirmation établie le 13 janv. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré Anchor House the Maltings Silvester Street Hull East Yorkshire HU1 3HD

    1 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à Anchor House the Maltings Silvester Street Hull East Yorkshire HU1 3HD

    1 pagesAD02

    Qui sont les dirigeants de WORLD MARKET INTELLIGENCE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HOOPER, Robert James
    c/o Globaldata Plc
    The Maltings, Silvester Street
    HU1 3HD Hull
    Anchor House
    Yorkshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    c/o Globaldata Plc
    The Maltings, Silvester Street
    HU1 3HD Hull
    Anchor House
    Yorkshire
    United Kingdom
    305366970001
    LILLEY, Graham Charles
    John Carpenter Street
    EC4Y 0AN London
    John Carpenter House
    Administrateur
    John Carpenter Street
    EC4Y 0AN London
    John Carpenter House
    United KingdomBritishCompany Director239319020002
    APPIAH, Kenneth Kurankyi
    John Carpenter Street
    EC4Y 0AN London
    John Carpenter House
    England
    Secrétaire
    John Carpenter Street
    EC4Y 0AN London
    John Carpenter House
    England
    150647630001
    BLAKE, Jonathan Elazar
    Queen Street Place
    EC4R 1BE London
    10
    Secrétaire
    Queen Street Place
    EC4R 1BE London
    10
    BritishSolicitor115055710001
    BROOKES, Richard Basil
    34 Oakhill Drive
    AL6 9NW Welwyn
    Hertfordshire
    Secrétaire
    34 Oakhill Drive
    AL6 9NW Welwyn
    Hertfordshire
    BritishChartered Accountant3170900001
    CHARD, Julie
    38 Oakhouse Road
    DA6 7NA Bexleyheath
    Kent
    Secrétaire
    38 Oakhouse Road
    DA6 7NA Bexleyheath
    Kent
    British125969790001
    JACKSON, Michael Francis
    Higham House
    TN32 5PS Salehurst
    East Sussex
    Secrétaire
    Higham House
    TN32 5PS Salehurst
    East Sussex
    BritishCompany Director25066620001
    LILLEY, Graham Charles
    John Carpenter Street
    EC4Y 0AN London
    John Carpenter House
    Secrétaire
    John Carpenter Street
    EC4Y 0AN London
    John Carpenter House
    245937240001
    MARCUS, Robert John
    John Carpenter Street
    EC4Y 0AN London
    John Carpenter House
    England
    Secrétaire
    John Carpenter Street
    EC4Y 0AN London
    John Carpenter House
    England
    146969080001
    PYPER, Simon John
    53 St Peter's Street
    N1 8JR London
    Secrétaire
    53 St Peter's Street
    N1 8JR London
    BritishDirector153726090001
    STRICKLAND, Charles Eugene Shackleton
    John Carpenter Street
    EC4Y 0AN London
    John Carpenter House
    Secrétaire
    John Carpenter Street
    EC4Y 0AN London
    John Carpenter House
    272595960001
    ZAHEDIEH, Ahmed
    310 Liverpool Road
    N7 8PU London
    Secrétaire
    310 Liverpool Road
    N7 8PU London
    British29478960002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    APPIAH, Kenneth
    John Carpenter Street
    EC4Y 0AN London
    John Carpenter House
    Administrateur
    John Carpenter Street
    EC4Y 0AN London
    John Carpenter House
    EnglandBritishAccountant91575310001
    BAILEY WOOD, Colin Mcrobert
    75 Woodwarde Road
    Dulwich
    SE22 8UL London
    Administrateur
    75 Woodwarde Road
    Dulwich
    SE22 8UL London
    BritishDirector108852250001
    BENNETT, Norma
    39 Southcote Way
    Penn
    HP10 8JG High Wycombe
    Buckinghamshire
    Administrateur
    39 Southcote Way
    Penn
    HP10 8JG High Wycombe
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishCo Director17016400001
    BLAKE, Jonathan Elazar
    Queen Street Place
    EC4R 1BE London
    10
    Administrateur
    Queen Street Place
    EC4R 1BE London
    10
    United KingdomBritishSolicitor115055710001
    BROOKES, Richard Basil
    34 Oakhill Drive
    AL6 9NW Welwyn
    Hertfordshire
    Administrateur
    34 Oakhill Drive
    AL6 9NW Welwyn
    Hertfordshire
    United KingdomBritishDirector3170900001
    DANSON, Michael Thomas
    John Carpenter Street
    EC4Y 0AN London
    John Carpenter House
    Administrateur
    John Carpenter Street
    EC4Y 0AN London
    John Carpenter House
    EnglandBritishCompany Director153592810001
    DANSON, Michael Thomas
    10 Courtney Avenue
    N6 4LA London
    Ridgemount
    Administrateur
    10 Courtney Avenue
    N6 4LA London
    Ridgemount
    EnglandEnglishDirector153950570001
    DANSON, Peter John, Mr.
    John Carpenter Street
    EC4Y 0AN London
    John Carpenter House
    England
    Administrateur
    John Carpenter Street
    EC4Y 0AN London
    John Carpenter House
    England
    EnglandBritishDirector171824760001
    DANSON, Peter John
    6 The Woodlands
    Lostock
    BL6 4JD Bolton
    Lancashire
    Administrateur
    6 The Woodlands
    Lostock
    BL6 4JD Bolton
    Lancashire
    EnglandBritishDirector78798270002
    DICKINSON, Alan Geoffrey
    Little Manor
    Lavant
    PO18 0BQ Chichester
    West Sussex
    Administrateur
    Little Manor
    Lavant
    PO18 0BQ Chichester
    West Sussex
    United KingdomBritishChartered Accountant13113610001
    GILBERT, Brian David
    15 Prince Albert Road
    Regents Park
    NW1 7SR London
    Administrateur
    15 Prince Albert Road
    Regents Park
    NW1 7SR London
    BritishCompany Director25364690001
    HARRINGTON, Michael Thompson
    3 Novara Row
    Calabria Road
    N5 1JL London
    Administrateur
    3 Novara Row
    Calabria Road
    N5 1JL London
    United KingdomBritishDirector101631250001
    HUDSON, Matthew Donald Jeremy
    236 Grays Inn Road
    WC1X 8HB London
    Administrateur
    236 Grays Inn Road
    WC1X 8HB London
    BritishSolicitor72420070001
    JACKSON, Michael Francis
    Higham House
    TN32 5PS Salehurst
    East Sussex
    Administrateur
    Higham House
    TN32 5PS Salehurst
    East Sussex
    BritishCompany Director25066620001
    MILLER, Nicholas John
    Thames Lodge
    3a Cross Deep
    TW1 4QJ Twickenham
    Middlesex
    Administrateur
    Thames Lodge
    3a Cross Deep
    TW1 4QJ Twickenham
    Middlesex
    United KingdomBritishCompany Director25066630003
    PYPER, Simon John
    John Carpenter Street
    EC4Y 0AN London
    John Carpenter House
    Administrateur
    John Carpenter Street
    EC4Y 0AN London
    John Carpenter House
    EnglandBritishDirector153726090001
    WRIGHT, Douglas Barclay
    Lodge Drive
    Loudwater
    WD3 4PT Rickmansworth
    Clarinsh
    Hertfordshire
    Administrateur
    Lodge Drive
    Loudwater
    WD3 4PT Rickmansworth
    Clarinsh
    Hertfordshire
    EnglandBritishCompany Director134618260001
    ZAHEDIEH, Ahmed
    310 Liverpool Road
    N7 8PU London
    Administrateur
    310 Liverpool Road
    N7 8PU London
    BritishDirector29478960002
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur désigné
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur WORLD MARKET INTELLIGENCE LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Progressive Media Ventures Limited
    John Carpenter Street
    EC4Y 0AN London
    John Carpenter House
    England
    13 janv. 2017
    John Carpenter Street
    EC4Y 0AN London
    John Carpenter House
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act
    Lieu d'enregistrementEngland And Wales
    Numéro d'enregistrement06178882
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    WORLD MARKET INTELLIGENCE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 08 août 2022
    Livré le 23 août 2022
    En cours
    Brève description
    N/A.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 23 août 2022Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 21 juin 2022
    Livré le 24 juin 2022
    En cours
    Brève description
    Not applicable.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Natwest Markets PLC as Security Trustee for the Finance Parties
    Transactions
    • 24 juin 2022Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 15 déc. 2021
    Livré le 20 déc. 2021
    En cours
    Brève description
    Not applicable.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Natwest Markets PLC as Security Trustee for the Finance Parties
    Transactions
    • 20 déc. 2021Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 19 mai 2020
    Livré le 21 mai 2020
    En cours
    Brève description
    Not applicable.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Natwest Markets PLC as Security Trustee for the Finance Parties (Security Agent)
    Transactions
    • 21 mai 2020Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 02 oct. 2018
    Livré le 08 oct. 2018
    En cours
    Brève description
    Not applicable.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Natwest Markets PLC as Security Trustee for the Finance Parties (Security Agent)
    Transactions
    • 08 oct. 2018Enregistrement d'une charge (MR01)
    Debenture
    Créé le 09 mars 2010
    Livré le 13 mars 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 13 mars 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 09 mars 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Créé le 12 juin 2009
    Livré le 15 juin 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 15 juin 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 oct. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Supplemental legal charge to the debenture
    Créé le 23 avr. 2001
    Livré le 30 avr. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under each finance document (as defined)
    Brèves mentions
    Full time guarantee as continuing security for the payment of all the secured liabilities hereby assigns and agrees to assign to the security trustee all rent income or other sums in connection with any lease tenancy or licence. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (As Agent and Trustee for the Finance Parties)
    Transactions
    • 30 avr. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 avr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite debenture
    Créé le 09 juin 1999
    Livré le 24 juin 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    In favour of the chargee all present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of the obligors (as defined) to the finance parties under each finance document (as defined) except for any obligation which, if it were so included, would result in the debenture contravening section 151 of the companies act 1985
    Brèves mentions
    F/H paulton house (8 shepherdess walk and 2 nile street) london N1-NGL444508..f/h wilmington house church hill wilmington dartford kent-K383319..l/h 6-14 (even) underwood street london N1-NGL175211. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 24 juin 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 juil. 2002Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 27 mai 2003Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 26 avr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 29 févr. 1996
    Livré le 19 mars 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 19 mars 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 août 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Créé le 28 juil. 1994
    Livré le 09 août 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from limerent limited to the chargee on any account whatsoever provided that the total sum recoverable under the security shall not exceed the amount of the deposit(s) together with all interest for the time being accrued thereon
    Brèves mentions
    The charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to form 395 see form 395 for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 09 août 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 nov. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Créé le 28 juil. 1994
    Livré le 09 août 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from limerent limited to the chargee on any account whatsoever provided that the total amount recoverable under the security shall not exceed the amount of the deposit(s) together with all interest for the time being accrued thereon
    Brèves mentions
    A fixed charge over all the deposit(s)referred to in the schedule to form 395 see form 395 for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 09 août 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 nov. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 09 mars 1992
    Livré le 17 mars 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Wilmington house, church hill, wilmington, dartford, kent t/no. K383319.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 17 mars 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 août 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 09 mars 1992
    Livré le 17 mars 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    For full details see form 395 tc ref: M418C. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 17 mars 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 août 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0