TRANQUILLITY LEASING LIMITED

TRANQUILLITY LEASING LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTRANQUILLITY LEASING LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02677724
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TRANQUILLITY LEASING LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe TRANQUILLITY LEASING LIMITED ?

    Adresse du siège social
    25 Gresham Street
    EC2V 7HN London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de TRANQUILLITY LEASING LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    HALIFAX TREASURY SERVICES LIMITED17 mars 199317 mars 1993
    LOOKUNION LIMITED15 janv. 199215 janv. 1992

    Quels sont les derniers comptes de TRANQUILLITY LEASING LIMITED ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le22 août 2025
    Date d'échéance des prochains comptes22 mai 2026
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au22 août 2024

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour TRANQUILLITY LEASING LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au15 janv. 2026
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation29 janv. 2026
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au15 janv. 2025
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour TRANQUILLITY LEASING LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Déclaration de confirmation établie le 15 janv. 2025 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 22 août 2024

    20 pagesAA

    Comptes annuels établis au 22 août 2023

    20 pagesAA

    Cessation de la nomination de John Robert Turner en tant que directeur le 30 janv. 2024

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Paul Clarke en tant qu'administrateur le 24 janv. 2024

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Greig Albert James Sharratt en tant qu'administrateur le 24 janv. 2024

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 15 janv. 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Colin Graham Dowsett en tant que directeur le 22 nov. 2023

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 22 août 2022

    19 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 15 janv. 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 22 août 2021

    20 pagesAA

    Nomination de Mr John Robert Turner en tant qu'administrateur le 13 janv. 2022

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Gerard Ashley Fox en tant que directeur le 13 janv. 2022

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 15 janv. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 22 août 2020

    16 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 15 janv. 2021 avec mises à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 22 août 2019

    17 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 15 janv. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des coordonnées du secrétaire Alyson Elizabeth Mulholland le 04 mars 2019

    1 pagesCH03

    Comptes annuels établis au 22 août 2018

    16 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 15 janv. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Ms Laura Frances Dorey le 04 janv. 2019

    2 pagesCH01

    Nomination de Ms Laura Frances Dorey en tant qu'administrateur le 28 juin 2018

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Andrew John Kemp en tant que directeur le 28 juin 2018

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 22 août 2017

    16 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de TRANQUILLITY LEASING LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MULHOLLAND, Alyson Elizabeth
    Chester Business Park
    CH4 9FB Chester
    Cawley House
    United Kingdom
    Secrétaire
    Chester Business Park
    CH4 9FB Chester
    Cawley House
    United Kingdom
    241174220001
    CLARKE, Paul
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    Administrateur
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director318888510001
    DOREY, Laura Frances Christabel
    Gresham Street
    EC2V 7AE London
    10
    United Kingdom
    Administrateur
    Gresham Street
    EC2V 7AE London
    10
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector230255280001
    SHARRATT, Greig Albert James
    2nd Floor, Princes Exchange
    1 Earl Grey Street
    EH3 9BN Edinburgh
    Lloyds Banking Group
    United Kingdom
    Administrateur
    2nd Floor, Princes Exchange
    1 Earl Grey Street
    EH3 9BN Edinburgh
    Lloyds Banking Group
    United Kingdom
    United KingdomBritishNone301096670001
    GITTINS, Paul
    House
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    Tower
    United Kingdom
    Secrétaire
    House
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    Tower
    United Kingdom
    British45660860003
    JOHNSON, Michelle Antoinette Angela
    Floor East
    Tower House Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    1st
    England
    England
    Secrétaire
    Floor East
    Tower House Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    1st
    England
    England
    181117150001
    LODGE, Matthew Sebastian
    Rose Cottage Dog Lane
    Stainland
    HX4 9QF Halifax
    West Yorkshire
    Secrétaire
    Rose Cottage Dog Lane
    Stainland
    HX4 9QF Halifax
    West Yorkshire
    British32609030001
    LODGE, Matthew Sebastian
    Rose Cottage Dog Lane
    Stainland
    HX4 9QF Halifax
    West Yorkshire
    Secrétaire
    Rose Cottage Dog Lane
    Stainland
    HX4 9QF Halifax
    West Yorkshire
    British32609030001
    HALIFAX SECRETARIES LIMITED
    Trinity Road
    HX1 2RG Halifax
    West Yorkshire
    Secrétaire
    Trinity Road
    HX1 2RG Halifax
    West Yorkshire
    73512200001
    AITKEN, Joe
    19 Kettilstoun Crescent
    EH49 6PR Linlithgow
    West Lothian
    Administrateur
    19 Kettilstoun Crescent
    EH49 6PR Linlithgow
    West Lothian
    BritishBanker123316840001
    CUMMING, Andrew John
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    Administrateur
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector46297770002
    DOWSETT, Colin Graham
    Aldershot Road
    Fleet
    GU51 3NN Hampshire
    26a
    England
    England
    Administrateur
    Aldershot Road
    Fleet
    GU51 3NN Hampshire
    26a
    England
    England
    EnglandBritishChartered Accountant152332230001
    FLOYD, Kevin Graham
    12 Shelf Moor Road
    Shelf
    HX3 7PQ Halifax
    West Yorkshire
    Administrateur
    12 Shelf Moor Road
    Shelf
    HX3 7PQ Halifax
    West Yorkshire
    BritishSolicitor23556980002
    FOX, Gerard Ashley
    London Wall
    EC2Y 5AJ London
    125
    United Kingdom
    Administrateur
    London Wall
    EC2Y 5AJ London
    125
    United Kingdom
    EnglandBritishBanker179100520001
    GLASSCOE, Keith Roderick
    18 Stanmore Chase
    AL4 0EZ St Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    18 Stanmore Chase
    AL4 0EZ St Albans
    Hertfordshire
    BritishBanker126272230001
    GLEDHILL, Simon Christopher
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    England
    England
    Administrateur
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    England
    England
    United KingdomBritishBank Manager191439050001
    ISAACS, Robin Alexander
    Gresham Street
    EC2V 7AE London
    10
    United Kingdom
    Administrateur
    Gresham Street
    EC2V 7AE London
    10
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector115548350001
    JUKES, Anthony Wilfrid
    Potts Farm Chennell Park Lane
    TN30 6XA Tenterden
    Kent
    Administrateur
    Potts Farm Chennell Park Lane
    TN30 6XA Tenterden
    Kent
    BritishCompany Director50640090001
    KEMP, Andrew John
    Canons House
    Canons Way
    BS1 5LL Bristol
    Ground Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    Canons House
    Canons Way
    BS1 5LL Bristol
    Ground Floor
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector222042280001
    KRAG, Stephen Rosenstjerne
    Lee House 40 Pinkneys Drive
    SL6 6QE Maidenhead
    Berkshire
    Administrateur
    Lee House 40 Pinkneys Drive
    SL6 6QE Maidenhead
    Berkshire
    BritishChartered Accountant70638390003
    LODGE, Matthew Sebastian
    Rose Cottage Dog Lane
    Stainland
    HX4 9QF Halifax
    West Yorkshire
    Administrateur
    Rose Cottage Dog Lane
    Stainland
    HX4 9QF Halifax
    West Yorkshire
    BritishChartered Secretary32609030001
    MCPHERSON, Donald James
    17 Cross Bank
    BD23 6AH Skipton
    North Yorkshire
    Administrateur
    17 Cross Bank
    BD23 6AH Skipton
    North Yorkshire
    BritishChartered Secretary40519810003
    MORRISSEY, John Michael
    66 Selborne Road
    Southgate
    N14 7DG London
    Administrateur
    66 Selborne Road
    Southgate
    N14 7DG London
    EnglandBritishChartered Accountant94094650001
    PETERS, Stephen John
    Old Swan Cottage
    9 London Road
    TN16 1BB Westerham
    Kent
    Administrateur
    Old Swan Cottage
    9 London Road
    TN16 1BB Westerham
    Kent
    BritishBanker56296720007
    RICHARDS, Ceri
    Level 7 Bishopsgate Exchange
    155 Bishopsgate
    EC2M 3YB London
    Administrateur
    Level 7 Bishopsgate Exchange
    155 Bishopsgate
    EC2M 3YB London
    BritishAccountant70624480004
    SHARP, Yvonne Easton
    11 Earl Grey Street
    EH3 9BN Edinburgh
    New Uberior House
    Midlothian
    Scotland
    Administrateur
    11 Earl Grey Street
    EH3 9BN Edinburgh
    New Uberior House
    Midlothian
    Scotland
    United KingdomBritishAccountant126272440001
    SHINDLER, David Lawrence
    4 Berkeley Close
    WD6 3JN Elstree
    Hertfordshire
    Administrateur
    4 Berkeley Close
    WD6 3JN Elstree
    Hertfordshire
    BritishChartered Accountant92235400001
    SMALLWOOD, James Douglas Mortimer
    4 Chestnuts
    SG13 8AQ Hertford
    Hertfordshire
    Administrateur
    4 Chestnuts
    SG13 8AQ Hertford
    Hertfordshire
    EnglandBritishManager110517930001
    TOWN, Lindsay John
    10 Ferndale
    TN2 3PB Tunbridge Wells
    Kent
    Administrateur
    10 Ferndale
    TN2 3PB Tunbridge Wells
    Kent
    EnglandBritishManaging Director64287260001
    TURNER, John Robert
    Gresham Street
    EC2V 7AE London
    10
    United Kingdom
    Administrateur
    Gresham Street
    EC2V 7AE London
    10
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector76185650001
    VELDHUIZEN, Lambertus Hendrik
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    England
    England
    Administrateur
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    England
    England
    United KingdomDutchHead Of Ship Finance152683120001
    WILLIAMS, Richard Owen
    London Wall
    EC2Y 5AJ London
    125
    United Kingdom
    Administrateur
    London Wall
    EC2Y 5AJ London
    125
    United Kingdom
    EnglandBritishHead Of Leasing Structured Finance164554190001
    HALIFAX SECRETARIES LIMITED
    Trinity Road
    HX1 2RG Halifax
    West Yorkshire
    Administrateur
    Trinity Road
    HX1 2RG Halifax
    West Yorkshire
    73512200001
    HBOS DIRECTORS LIMITED
    Trinity Road
    HX1 2RG Halifax
    West Yorkshire
    Administrateur
    Trinity Road
    HX1 2RG Halifax
    West Yorkshire
    73510890001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur TRANQUILLITY LEASING LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement02279167
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0