CAPITA BROKER SERVICES LIMITED

CAPITA BROKER SERVICES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCAPITA BROKER SERVICES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02680234
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CAPITA BROKER SERVICES LIMITED ?

    • Assurance non-vie (65120) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe CAPITA BROKER SERVICES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    The Registry
    34 Beckenham Road
    BR3 4TU Beckenham
    Kent
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CAPITA BROKER SERVICES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    INDEPENDENT CLAIMS SERVICES LTD.23 janv. 199223 janv. 1992

    Quels sont les derniers comptes de CAPITA BROKER SERVICES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour CAPITA BROKER SERVICES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital27 janv. 2012

    État du capital au 27 janv. 2012

    • Capital: GBP 2
    SH01

    legacy

    3 pagesMG02

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré

    1 pagesAD03

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2010

    11 pagesAA

    Démission de l'auditeur

    2 pagesAUD

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Démission de l'auditeur

    3 pagesAUD

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 12 nov. 2010

    • Capital: GBP 2
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    6 pagesAA

    Nomination de Mr Richard John Shearer en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de John King en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Résolutions

    Resolutions
    15 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2009 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Capita Corporate Director Limited le 01 oct. 2009

    1 pagesCH02

    Modification des coordonnées du secrétaire Capita Group Secretary Limited le 01 oct. 2009

    1 pagesCH04

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré

    1 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée

    1 pagesAD02

    Qui sont les dirigeants de CAPITA BROKER SERVICES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CAPITA GROUP SECRETARY LIMITED
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    Secrétaire
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement2376959
    138426340001
    SHEARER, Richard John
    Rochester Row
    Westminster
    SW1P 1QT London
    17
    England
    Administrateur
    Rochester Row
    Westminster
    SW1P 1QT London
    17
    England
    United KingdomBritish132651920002
    CAPITA CORPORATE DIRECTOR LIMITED
    Rochester Row
    Westminster
    SW1P 1QT London
    17
    Administrateur
    Rochester Row
    Westminster
    SW1P 1QT London
    17
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement5641516
    129795770003
    FONTANA, Tina Maria
    3 Glanfield Road
    BR3 3JS Beckenham
    Kent
    Secrétaire
    3 Glanfield Road
    BR3 3JS Beckenham
    Kent
    British55869510002
    GODDARD, Peter
    Fernmead
    Glebe Road, Fernhurst
    GU27 3EQ Haslemere
    Surrey
    Secrétaire
    Fernmead
    Glebe Road, Fernhurst
    GU27 3EQ Haslemere
    Surrey
    British73067120001
    HURST, Gordon Mark
    The Manor House
    Reading Road Padworth Common
    RG7 4QG Reading
    Berkshire
    Secrétaire
    The Manor House
    Reading Road Padworth Common
    RG7 4QG Reading
    Berkshire
    British60918000001
    MAGGS, Roger Philip
    Sky Hall Cottage
    Boxted
    CO4 5TF Colchester
    Essex
    Secrétaire
    Sky Hall Cottage
    Boxted
    CO4 5TF Colchester
    Essex
    British16031570002
    CAPITA COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    The Registry
    34 Beckenham Road
    BR3 4TU Beckenham
    Kent
    Secrétaire
    The Registry
    34 Beckenham Road
    BR3 4TU Beckenham
    Kent
    102944500001
    CITY INITIATIVE LIMITED
    27 Holywell Hill
    AL1 1EZ St Albans
    Hertfordshire
    Secrétaire désigné
    27 Holywell Hill
    AL1 1EZ St Albans
    Hertfordshire
    900001140001
    EASTGATE INSURANCE SERVICES LIMITED
    Pullman Place
    Great Western Road
    GL1 3EA Gloucester
    Secrétaire
    Pullman Place
    Great Western Road
    GL1 3EA Gloucester
    84326030002
    CRAWFORD, Robert Gammie
    9 London House
    Avenue Road
    NW8 7PX London
    Administrateur
    9 London House
    Avenue Road
    NW8 7PX London
    United KingdomBritish613370001
    DOHERTY, Christopher
    33 Morley Drive
    Horsmoden
    TN12 8JD Tonbridge
    Kent
    Administrateur
    33 Morley Drive
    Horsmoden
    TN12 8JD Tonbridge
    Kent
    British39794350002
    JEWELL, David Raymond
    17 Fitzwalter Road
    CO3 3SY Colchester
    Essex
    Administrateur
    17 Fitzwalter Road
    CO3 3SY Colchester
    Essex
    EnglandBritish15781330001
    KING, John Bryan
    Rochester Row
    Westminster
    SW1P 1QT London
    17
    Administrateur
    Rochester Row
    Westminster
    SW1P 1QT London
    17
    EnglandBritish261883440001
    KNIGHT, Maxwell Luke
    141 Westmount Road
    SE9 1XX London
    Administrateur
    141 Westmount Road
    SE9 1XX London
    British35934460001
    MAGGS, Roger Philip
    Sky Hall Cottage
    Boxted
    CO4 5TF Colchester
    Essex
    Administrateur
    Sky Hall Cottage
    Boxted
    CO4 5TF Colchester
    Essex
    United KingdomBritish16031570002
    MCCANN, Peter John
    14 Ross Way
    Langdon Hills
    SS16 6LX Basildon
    Essex
    Administrateur
    14 Ross Way
    Langdon Hills
    SS16 6LX Basildon
    Essex
    United KingdomBritish39976250001
    MCCOY, Robin Edward
    14 Brayburne Avenue
    SW4 6AA London
    Administrateur
    14 Brayburne Avenue
    SW4 6AA London
    British51429940001
    PEARSON, David Gay
    31 Osmond Gardens
    SM6 8SX Wallington
    Surrey
    Administrateur
    31 Osmond Gardens
    SM6 8SX Wallington
    Surrey
    United KingdomBritish146048900001
    PEARSON, David Gay
    31 Osmond Gardens
    SM6 8SX Wallington
    Surrey
    Administrateur
    31 Osmond Gardens
    SM6 8SX Wallington
    Surrey
    United KingdomBritish146048900001
    PEEL, John William
    99 Elm Road
    Earley
    RG6 5TB Reading
    Berkshire
    Administrateur
    99 Elm Road
    Earley
    RG6 5TB Reading
    Berkshire
    British38254720002
    QUILTER, Alan Kevin
    Badgers Rest
    Lee Chapel Lane, Langdon Hills
    SS16 5PW Basildon
    Essex
    Administrateur
    Badgers Rest
    Lee Chapel Lane, Langdon Hills
    SS16 5PW Basildon
    Essex
    EnglandBritish13145680001
    RING, Geoffrey
    46 Merleburgh Drive
    Kemsley
    ME10 2RN Sittingbourne
    Kent
    Administrateur
    46 Merleburgh Drive
    Kemsley
    ME10 2RN Sittingbourne
    Kent
    British78079080002
    RING, Sarah Jane
    16 Ewan Way
    SS9 3RA Leigh On Sea
    Essex
    Administrateur
    16 Ewan Way
    SS9 3RA Leigh On Sea
    Essex
    British25931550001
    SAWARD, Mark Alan Geoffrey
    Pooks Hill Woodland Way
    Kingswood
    KT20 6NX Tadworth
    Surrey
    Administrateur
    Pooks Hill Woodland Way
    Kingswood
    KT20 6NX Tadworth
    Surrey
    British44496480001
    SHEARER, Richard John
    6 The Heronry
    Burwood Park
    KT12 5AT Walton On Thames
    Surrey
    Administrateur
    6 The Heronry
    Burwood Park
    KT12 5AT Walton On Thames
    Surrey
    United KingdomBritish132651920002
    TOTTY, Steve
    Stoupe Brown Farm
    Ravenscar
    YO13 0NQ Scarborough
    North Yorkshire
    Administrateur
    Stoupe Brown Farm
    Ravenscar
    YO13 0NQ Scarborough
    North Yorkshire
    British74844280001
    TRAINER, Martin John
    6 Stone Pine Road
    MK43 8GG Bromham
    Bedfordshire
    Administrateur
    6 Stone Pine Road
    MK43 8GG Bromham
    Bedfordshire
    EnglandBritish124180840001
    C I NOMINEES LIMITED
    27 Holywell Hill
    AL1 1EZ St Albans
    Hertfordshire
    Administrateur désigné
    27 Holywell Hill
    AL1 1EZ St Albans
    Hertfordshire
    900001130001

    CAPITA BROKER SERVICES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Guarantee & debenture
    Créé le 30 nov. 1998
    Livré le 16 déc. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    In favour of national westminster bank PLC as security trustee for the secured parties (as defined) the actual, contingent, present and/or future obligations and liabilities of the company to any of the secured parties under or pursuant to any of the financing documents (as defined) (including this guarantee and debenture) (the "secured obligations")
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage all estates or interests in the f/h, l/h and other immovable property described in the schedule below being none; by way of fixed charge all estates in any f/h, l/h and other immovable property as at the date of this debenture, all plant machinery vehicles computers and other office equipment, all book and other debts, the goodwill and uncalled capital; by way of floating charge the undertaking and all its property assets and rights whatsoever and wheresoever present and future.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 16 déc. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 déc. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Trust and security deed in favour of the society of lloyd's as trustee for all persons to whom the company owes debts and obligations in respect of the collection of claims monies and who are underwriting members of lloyd's
    Créé le 04 juil. 1996
    Livré le 17 juil. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies to the credit of or required to be paid into the british pound sterling account and the united states dollar account maintained by the company at the national westminster bank PLC, 21 lombard street, london and the canadian dollar account maintained by the company at the royal bank of canada, montreal, canada (but excluding any monies held by the company in such accounts as trustee for any person or persons)
    Brèves mentions
    First floating charge over all its insurance transactions assets (meaning all monies standing to the credit of or required to be paid into the british pound sterling account or us dollar account).. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Society of Lloyd's
    Transactions
    • 17 juil. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 janv. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 26 juin 1996
    Livré le 04 juil. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lombard North Central PLC
    Transactions
    • 04 juil. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 déc. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage debenture
    Créé le 06 juin 1996
    Livré le 14 juin 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 14 juin 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 janv. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0