TESTACTIVE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTESTACTIVE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02681169
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TESTACTIVE LIMITED ?

    • Autres activités liées à la santé humaine (86900) / Activités de santé humaine et d'action sociale

    Où se situe TESTACTIVE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Pinsent Masons Llp
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de TESTACTIVE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour TESTACTIVE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    8 pagesLIQ13

    Changement d'adresse du siège social de Part Ground Floor & First Floor Two Parklands, Great Park Rubery, Rednal Birmingham B45 9PZ à C/O Pinsent Masons Llp 1 Park Row Leeds LS1 5AB le 20 déc. 2017

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Patricia Lesley Lee en tant que directeur le 31 juil. 2017

    1 pagesTM01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 23 juin 2017

    LRESSP

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2016

    7 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 27 janv. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 27 janv. 2016 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital07 mars 2016

    État du capital au 07 mars 2016

    • Capital: GBP 750
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2015

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 27 janv. 2015 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital09 mars 2015

    État du capital au 09 mars 2015

    • Capital: GBP 750
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2014

    8 pagesAA

    Nomination de Ms Patricia Lesley Lee en tant qu'administrateur le 22 oct. 2014

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Albert Edward Smith en tant que directeur le 22 oct. 2014

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2013

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 27 janv. 2014 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital29 janv. 2014

    État du capital au 29 janv. 2014

    • Capital: GBP 750
    SH01

    Cessation de la nomination de Katharine Kandelaki en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Divers

    Auditor resignation sec 519
    2 pagesMISC

    Période comptable précédente prolongée du 31 déc. 2012 au 30 juin 2013

    1 pagesAA01

    Déclaration annuelle jusqu'au 27 janv. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2011

    5 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de * 28 Welbeck Street London W1G 8EW* le 06 sept. 2012

    1 pagesAD01

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    Qui sont les dirigeants de TESTACTIVE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MANSON, David Lindsay
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    C/O Pinsent Masons Llp
    England
    Administrateur
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    C/O Pinsent Masons Llp
    England
    United KingdomBritishDirector167628190001
    AMLANI, Pritesh
    Birling Road
    Ryarsh
    ME19 5LS West Malling
    Ryarsh Oast House
    Kent
    United Kingdom
    Secrétaire
    Birling Road
    Ryarsh
    ME19 5LS West Malling
    Ryarsh Oast House
    Kent
    United Kingdom
    BritishAccountant125206220002
    KANDELAKI, Katharine Amelia Christabel
    Two Parklands, Great Park
    Rubery, Rednal
    B45 9PZ Birmingham
    Part Ground Floor & First Floor
    United Kingdom
    Secrétaire
    Two Parklands, Great Park
    Rubery, Rednal
    B45 9PZ Birmingham
    Part Ground Floor & First Floor
    United Kingdom
    160355230001
    PARRY, Simon Michael
    The Rhondda Care Home
    Tyntyla Avenue
    CF41 7SU Ystrad
    Mid Glamorgan
    Secrétaire
    The Rhondda Care Home
    Tyntyla Avenue
    CF41 7SU Ystrad
    Mid Glamorgan
    BritishAccountant26540200002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    AMLANI, Pritesh
    Birling Road
    Ryarsh
    ME19 5LS West Malling
    Ryarsh Oast House
    Kent
    United Kingdom
    Administrateur
    Birling Road
    Ryarsh
    ME19 5LS West Malling
    Ryarsh Oast House
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritishAccountant125206220002
    BENNETT, Christopher
    62 Penydre
    Rhiwbina
    CF4 Cardiff
    Administrateur
    62 Penydre
    Rhiwbina
    CF4 Cardiff
    BritishBuilder29495310001
    CATRIS, Michael Benedict
    20 Saint Andrews Crescent
    CF10 3DD Cardiff
    Administrateur
    20 Saint Andrews Crescent
    CF10 3DD Cardiff
    BritishEngineer-Consulting Civil Stru25850740004
    JONES, Peter Nicholson
    4 Llanthewy Road
    NP9 4JR Newport
    Gwent
    Administrateur
    4 Llanthewy Road
    NP9 4JR Newport
    Gwent
    BritishCivil Engineer25850730003
    LEE, Patricia Lesley
    Two Parklands, Great Park
    Rubery, Rednal
    B45 9PZ Birmingham
    Part Ground Floor & First Floor
    Administrateur
    Two Parklands, Great Park
    Rubery, Rednal
    B45 9PZ Birmingham
    Part Ground Floor & First Floor
    United KingdomBritishChief Executive192233540001
    PARRY, Simon Michael
    The Rhondda Care Home
    Tyntyla Avenue
    CF41 7SU Ystrad
    Mid Glamorgan
    Administrateur
    The Rhondda Care Home
    Tyntyla Avenue
    CF41 7SU Ystrad
    Mid Glamorgan
    BritishChartered Management Accountan26540200002
    PERRY, David William
    Welbeck Street
    W1G 8EW London
    28
    Administrateur
    Welbeck Street
    W1G 8EW London
    28
    EnglandBritishDirector33988060002
    SMITH, Albert Edward
    Two Parklands, Great Park
    Rubery, Rednal
    B45 9PZ Birmingham
    Part Ground Floor & First Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    Two Parklands, Great Park
    Rubery, Rednal
    B45 9PZ Birmingham
    Part Ground Floor & First Floor
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector77631340001
    TREON, Anoup
    Apt 1, Cambridge Gate
    Regents Park
    NW1 4JX London
    Administrateur
    Apt 1, Cambridge Gate
    Regents Park
    NW1 4JX London
    United KingdomBritishDirector152212470001
    TREON, Jaynee Sunita
    Welbeck Street
    W1G 8EW London
    28
    Administrateur
    Welbeck Street
    W1G 8EW London
    28
    United KingdomBritishDirector42532090004
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur désigné
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur TESTACTIVE LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Embrace Realty (Central) Ltd
    Parklands
    Rednal
    B45 9PZ Birmingham
    Two Parklands
    England
    06 avr. 2016
    Parklands
    Rednal
    B45 9PZ Birmingham
    Two Parklands
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Company Limited Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act
    Lieu d'enregistrementEngland
    Numéro d'enregistrement05064765
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    TESTACTIVE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Guarantee & debenture
    Créé le 25 mars 2011
    Livré le 06 avr. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the lenders or any of them on any account whatsoever and to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge and all monies due or to become due from each other chargor and each other member of the group to the lenders or any of them on any account whatsoever and to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Security Agent
    Transactions
    • 06 avr. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 01 août 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Guarantee & debenture
    Créé le 09 août 2007
    Livré le 18 août 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 18 août 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 mars 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignment of life policies
    Créé le 22 mars 2004
    Livré le 01 avr. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    The life policy, 212851 dated 02/02/04 on the life of simon m parry and issued by lutine assurance services limited , along with all moneys secured by or to become under policy. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 01 avr. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 août 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 19 déc. 2003
    Livré le 06 janv. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Property k/a porth hospital porth and district general hospital cemetary road porth t/n WA751196 and tyntala hospital lywynpia t/n WA635186. And all buildings structures fixtures (including trade fixtures) and fixed plant machinery and equipment from time to time thereon all right title and interest to and in any proceeds of any present or future insurances of the property any present and future goodwill of the business (if any) and by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 06 janv. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 août 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 19 déc. 2003
    Livré le 06 janv. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 06 janv. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 août 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal mortgage
    Créé le 23 avr. 1992
    Livré le 28 avr. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a tyntyla hospital llwynypia rhondda mid glamorgan and the procee. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 28 avr. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 juil. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 14 avr. 1992
    Livré le 21 avr. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 21 avr. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 juil. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    TESTACTIVE LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    23 juin 2017Commencement of winding up
    06 oct. 2018Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    David Matthew Hammond
    Pricewaterhousecoopers Llp Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    practitioner
    Pricewaterhousecoopers Llp Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Emma Cray
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    practitioner
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0