ENTERPRISE INNS (NO 2) LIMITED

ENTERPRISE INNS (NO 2) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéENTERPRISE INNS (NO 2) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02686643
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ENTERPRISE INNS (NO 2) LIMITED ?

    • (7011) /

    Où se situe ENTERPRISE INNS (NO 2) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Ernst & Young Llp No 1
    Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ENTERPRISE INNS (NO 2) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    JOHN LABATT RETAIL LIMITED27 juil. 199427 juil. 1994
    MAPLE LEAF INNS LIMITED15 mai 199215 mai 1992
    DECKCLEAR LIMITED12 févr. 199212 févr. 1992

    Quels sont les derniers comptes de ENTERPRISE INNS (NO 2) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2007

    Quels sont les derniers dépôts pour ENTERPRISE INNS (NO 2) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 04 juin 2010

    5 pages4.68

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    3 pages4.71

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 16 avr. 2010

    5 pages4.68

    legacy

    1 pages287

    Résolution d'insolvabilité

    Resolution INSOLVENCY:remuneration, books and records
    1 pagesLIQ MISC RES

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 17 avr. 2009

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    2 pages600

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    3 pages363a

    Comptes d'exonération totale établis au 30 sept. 2007

    7 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages288c

    Comptes d'exonération totale établis au 30 sept. 2006

    7 pagesAA

    legacy

    6 pages363a

    legacy

    1 pages353

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    6 pages363a

    Comptes d'exonération totale établis au 30 sept. 2005

    8 pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    resolution

    Résolution élective

    ELRES

    Résolutions

    Resolutions
    pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    resolution

    Résolution élective

    ELRES

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    resolution

    Résolution élective

    ELRES

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2004

    10 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de ENTERPRISE INNS (NO 2) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    GEORGE, David Colbron
    Harlestone House
    Church Lane
    NN7 4EN Lower Harlestone
    Northamptonshire
    Secrétaire
    Harlestone House
    Church Lane
    NN7 4EN Lower Harlestone
    Northamptonshire
    British69592110002
    GEORGE, David Colbron
    Harlestone House
    Church Lane
    NN7 4EN Lower Harlestone
    Northamptonshire
    Administrateur
    Harlestone House
    Church Lane
    NN7 4EN Lower Harlestone
    Northamptonshire
    EnglandBritish69592110002
    POOLE, James Andrew
    Vale Cottage
    Oakridge Lynch
    GL6 7NR Stroud
    Gloucestershire
    Administrateur
    Vale Cottage
    Oakridge Lynch
    GL6 7NR Stroud
    Gloucestershire
    United KingdomBritish 57614880004
    TUPPEN, Graham Edward
    5 Queensdale Place
    Holland Park
    W11 4SQ London
    Administrateur
    5 Queensdale Place
    Holland Park
    W11 4SQ London
    United KingdomBritish9549960009
    CROSS, Anthony
    38 The Lane
    Spinkhill
    S21 3YF Sheffield
    South Yorkshire
    Secrétaire
    38 The Lane
    Spinkhill
    S21 3YF Sheffield
    South Yorkshire
    British1812400001
    RUIJS, Mary Johanna
    13 Botfield Avenue
    M9B 4C6 Etobicoke
    Ontario
    Canada
    Secrétaire
    13 Botfield Avenue
    M9B 4C6 Etobicoke
    Ontario
    Canada
    British42305520001
    RUSNELL, Joanne Doreen
    51 Old Mill Drive
    M6S 4JD Toronto
    Ontario
    Canada
    Secrétaire
    51 Old Mill Drive
    M6S 4JD Toronto
    Ontario
    Canada
    Canadian9656720002
    THYS, Joseph Marie Victor Patrice
    Rue Yernawe 12
    Saint Georges Sur Meuse 4470
    FOREIGN Belgium
    Secrétaire
    Rue Yernawe 12
    Saint Georges Sur Meuse 4470
    FOREIGN Belgium
    Belgian45152470001
    ABOGADO CUSTODIANS LIMITED
    100 New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    Secrétaire désigné
    100 New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    900021140001
    ABOGADO NOMINEES LIMITED
    100 New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    Secrétaire désigné
    100 New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    900021150001
    ABOGADO NOMINEES LIMITED
    100 New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    Secrétaire désigné
    100 New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    900021150001
    THE COMPANY REGISTRATION AGENTS LIMITED
    83 Leonard Street
    EC2A 4QS London
    Secrétaire désigné
    83 Leonard Street
    EC2A 4QS London
    900003220001
    BRACKENBURY, Frederick Edwin John Gedge
    8 Moore Street
    SW3 2QN London
    Administrateur
    8 Moore Street
    SW3 2QN London
    United KingdomBritish53682420001
    CRITCHLOW, Christopher Hugh
    45 Solent Road
    West Hampstead
    NW6 1TY London
    Administrateur
    45 Solent Road
    West Hampstead
    NW6 1TY London
    British32989090001
    DIAKIW, Richard John
    Crawfordsburn
    St Georges Road
    KT13 0EP Weybridge
    Surrey
    Administrateur
    Crawfordsburn
    St Georges Road
    KT13 0EP Weybridge
    Surrey
    Canadian39830640001
    ECKMIRE, John
    White Spinney
    10 Broomfield Ride
    KT22 0LW Oxshott
    Surrey
    Administrateur
    White Spinney
    10 Broomfield Ride
    KT22 0LW Oxshott
    Surrey
    Canadian34831670001
    HARRISON, Gordon William
    Bramley House
    Chapel Lane
    S18 4AZ Apperknowle
    Dronfield
    Administrateur
    Bramley House
    Chapel Lane
    S18 4AZ Apperknowle
    Dronfield
    British96987760001
    IZZA, Michael Donald Mccartney
    Sanza 2 Claremont Avenue
    KT10 9JD Esher
    Surrey
    Administrateur
    Sanza 2 Claremont Avenue
    KT10 9JD Esher
    Surrey
    British27447890001
    JACOBS, Marc Philomena Francois
    St Maartenstraat 43/22
    3000 Leuven
    Belgium
    Administrateur
    St Maartenstraat 43/22
    3000 Leuven
    Belgium
    Luxembourger46037650001
    MURRAY, John Duncan
    High Jenks 74a Southampton Road
    SO41 9GZ Lymington
    Hampshire
    Administrateur
    High Jenks 74a Southampton Road
    SO41 9GZ Lymington
    Hampshire
    British52310900002
    PEER, Bruce Edward
    60 Hillholm Road
    M5P 1MS Toronto
    Ontario
    Canada
    Administrateur
    60 Hillholm Road
    M5P 1MS Toronto
    Ontario
    Canada
    Canadian12682100002
    PITT, Christopher James
    Wilton Cottage
    Wildhern
    SP11 0JE Andover
    Hants
    Administrateur
    Wilton Cottage
    Wildhern
    SP11 0JE Andover
    Hants
    United KingdomBritish32115900001
    SANDS, John Robert
    11 Falcon Lane
    Norton
    TS20 1LS Stockton On Tees
    Administrateur
    11 Falcon Lane
    Norton
    TS20 1LS Stockton On Tees
    United KingdomBritish141561650001
    WILLIAMS, Sean
    191 Southwood Road
    Rusthall
    TN4 8UX Tunbridge Wells
    Kent
    Administrateur
    191 Southwood Road
    Rusthall
    TN4 8UX Tunbridge Wells
    Kent
    British40164940001
    ABOGADO CUSTODIANS LIMITED
    100 New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    Administrateur désigné
    100 New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    900021140001
    ABOGADO NOMINEES LIMITED
    100 New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    Administrateur désigné
    100 New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    900021150001
    LUCIENE JAMES LIMITED
    83 Leonard Street
    EC2A 4QS London
    Administrateur désigné
    83 Leonard Street
    EC2A 4QS London
    900003210001

    ENTERPRISE INNS (NO 2) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Security deed
    Créé le 24 mai 2002
    Livré le 05 juin 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The security deed charges in favour of the security trustee by way of a first floating charge all the company's undertaking and assets whatsoever and wheresoever both present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag London (The "Security Trustee")on Behalf of Itself and the Banks and Financialinstitutions from Time to Time Party to the Secured Documents
    Transactions
    • 05 juin 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 févr. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Security deed
    Créé le 07 juin 2000
    Livré le 23 juin 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to (the "finance documents") (as defined) and (a credit agreement) (as defined) up to £350,000,000 dated 15 may 2000
    Brèves mentions
    The security deed charges in favour of the security trustee by way of a first floating charge all the company's undertaking and assets whatsoever and wheresoever both present and future.
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag Londonon Behalf of Itself and the Banks and Financialinstitutions from Time to Time Party to the Finance Documents
    Transactions
    • 23 juin 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 juin 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture
    Créé le 13 mars 1998
    Livré le 23 mars 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owned jointly or severaly or in any other capacity whatsoever) of each obligor to any finance party under the finance documents
    Brèves mentions
    All the shares and related rights fixed charge all shares and related rights floating charge all its undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Investment Bank PLC("Trustee")
    Transactions
    • 23 mars 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 juin 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture created by the company (formerly known as john labatt retail limited)
    Créé le 07 juin 1996
    Livré le 19 juin 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the finance documents
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Investment Bank PLC(As Trustee for the Finance Parties)
    Transactions
    • 19 juin 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 août 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of assignment
    Créé le 07 août 1992
    Livré le 14 août 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the fourth schedule of a management agreement dated 7/8/92
    Brèves mentions
    By way of first fixed charge all the companys right title and interest and benefit in an interest bearing deposit account k/a the maple leaf inns limited management fees account with no: 97510173 with national westminster bank PLC and all moneys from time to time standing in the nominated including all interest thereon and all amounts deriving therefrom whether directly or indirectly.
    Personnes ayant droit
    • Brother of Pubmaster Limited
    Transactions
    • 14 août 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 juin 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    ENTERPRISE INNS (NO 2) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    17 sept. 2010Dissolved on
    17 avr. 2009Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Ian Best
    Ernst & Young
    One Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    practitioner
    Ernst & Young
    One Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    Tomislav Lukic
    Ernst & Young
    1 Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    practitioner
    Ernst & Young
    1 Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0