ENTERPRISE INNS (NO 2) LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | ENTERPRISE INNS (NO 2) LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 02686643 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe ENTERPRISE INNS (NO 2) LIMITED ?
| Adresse du siège social | C/O Ernst & Young Llp No 1 Colmore Square B4 6HQ Birmingham |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de ENTERPRISE INNS (NO 2) LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 30 sept. 2007 |
Quels sont les derniers dépôts pour ENTERPRISE INNS (NO 2) LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 04 juin 2010 | 5 pages | 4.68 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 3 pages | 4.71 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 16 avr. 2010 | 5 pages | 4.68 | ||||||||||
legacy | 1 pages | 287 | ||||||||||
Résolution d'insolvabilité Resolution INSOLVENCY:remuneration, books and records | 1 pages | LIQ MISC RES | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de solvabilité | 3 pages | 4.70 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 2 pages | 600 | ||||||||||
legacy | 1 pages | 403a | ||||||||||
legacy | 3 pages | 363a | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 30 sept. 2007 | 7 pages | AA | ||||||||||
legacy | 3 pages | 363a | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288c | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 30 sept. 2006 | 7 pages | AA | ||||||||||
legacy | 6 pages | 363a | ||||||||||
legacy | 1 pages | 353 | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288c | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288c | ||||||||||
legacy | 6 pages | 363a | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 30 sept. 2005 | 8 pages | AA | ||||||||||
Résolutions Resolutions | pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Résolutions Resolutions | pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes annuels établis au 30 sept. 2004 | 10 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de ENTERPRISE INNS (NO 2) LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEORGE, David Colbron | Secrétaire | Harlestone House Church Lane NN7 4EN Lower Harlestone Northamptonshire | British | 69592110002 | ||||||
| GEORGE, David Colbron | Administrateur | Harlestone House Church Lane NN7 4EN Lower Harlestone Northamptonshire | England | British | 69592110002 | |||||
| POOLE, James Andrew | Administrateur | Vale Cottage Oakridge Lynch GL6 7NR Stroud Gloucestershire | United Kingdom | British | 57614880004 | |||||
| TUPPEN, Graham Edward | Administrateur | 5 Queensdale Place Holland Park W11 4SQ London | United Kingdom | British | 9549960009 | |||||
| CROSS, Anthony | Secrétaire | 38 The Lane Spinkhill S21 3YF Sheffield South Yorkshire | British | 1812400001 | ||||||
| RUIJS, Mary Johanna | Secrétaire | 13 Botfield Avenue M9B 4C6 Etobicoke Ontario Canada | British | 42305520001 | ||||||
| RUSNELL, Joanne Doreen | Secrétaire | 51 Old Mill Drive M6S 4JD Toronto Ontario Canada | Canadian | 9656720002 | ||||||
| THYS, Joseph Marie Victor Patrice | Secrétaire | Rue Yernawe 12 Saint Georges Sur Meuse 4470 FOREIGN Belgium | Belgian | 45152470001 | ||||||
| ABOGADO CUSTODIANS LIMITED | Secrétaire désigné | 100 New Bridge Street EC4V 6JA London | 900021140001 | |||||||
| ABOGADO NOMINEES LIMITED | Secrétaire désigné | 100 New Bridge Street EC4V 6JA London | 900021150001 | |||||||
| ABOGADO NOMINEES LIMITED | Secrétaire désigné | 100 New Bridge Street EC4V 6JA London | 900021150001 | |||||||
| THE COMPANY REGISTRATION AGENTS LIMITED | Secrétaire désigné | 83 Leonard Street EC2A 4QS London | 900003220001 | |||||||
| BRACKENBURY, Frederick Edwin John Gedge | Administrateur | 8 Moore Street SW3 2QN London | United Kingdom | British | 53682420001 | |||||
| CRITCHLOW, Christopher Hugh | Administrateur | 45 Solent Road West Hampstead NW6 1TY London | British | 32989090001 | ||||||
| DIAKIW, Richard John | Administrateur | Crawfordsburn St Georges Road KT13 0EP Weybridge Surrey | Canadian | 39830640001 | ||||||
| ECKMIRE, John | Administrateur | White Spinney 10 Broomfield Ride KT22 0LW Oxshott Surrey | Canadian | 34831670001 | ||||||
| HARRISON, Gordon William | Administrateur | Bramley House Chapel Lane S18 4AZ Apperknowle Dronfield | British | 96987760001 | ||||||
| IZZA, Michael Donald Mccartney | Administrateur | Sanza 2 Claremont Avenue KT10 9JD Esher Surrey | British | 27447890001 | ||||||
| JACOBS, Marc Philomena Francois | Administrateur | St Maartenstraat 43/22 3000 Leuven Belgium | Luxembourger | 46037650001 | ||||||
| MURRAY, John Duncan | Administrateur | High Jenks 74a Southampton Road SO41 9GZ Lymington Hampshire | British | 52310900002 | ||||||
| PEER, Bruce Edward | Administrateur | 60 Hillholm Road M5P 1MS Toronto Ontario Canada | Canadian | 12682100002 | ||||||
| PITT, Christopher James | Administrateur | Wilton Cottage Wildhern SP11 0JE Andover Hants | United Kingdom | British | 32115900001 | |||||
| SANDS, John Robert | Administrateur | 11 Falcon Lane Norton TS20 1LS Stockton On Tees | United Kingdom | British | 141561650001 | |||||
| WILLIAMS, Sean | Administrateur | 191 Southwood Road Rusthall TN4 8UX Tunbridge Wells Kent | British | 40164940001 | ||||||
| ABOGADO CUSTODIANS LIMITED | Administrateur désigné | 100 New Bridge Street EC4V 6JA London | 900021140001 | |||||||
| ABOGADO NOMINEES LIMITED | Administrateur désigné | 100 New Bridge Street EC4V 6JA London | 900021150001 | |||||||
| LUCIENE JAMES LIMITED | Administrateur désigné | 83 Leonard Street EC2A 4QS London | 900003210001 |
ENTERPRISE INNS (NO 2) LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Security deed | Créé le 24 mai 2002 Livré le 05 juin 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The security deed charges in favour of the security trustee by way of a first floating charge all the company's undertaking and assets whatsoever and wheresoever both present and future. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Security deed | Créé le 07 juin 2000 Livré le 23 juin 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to (the "finance documents") (as defined) and (a credit agreement) (as defined) up to £350,000,000 dated 15 may 2000 | |
Brèves mentions The security deed charges in favour of the security trustee by way of a first floating charge all the company's undertaking and assets whatsoever and wheresoever both present and future. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Guarantee and debenture | Créé le 13 mars 1998 Livré le 23 mars 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owned jointly or severaly or in any other capacity whatsoever) of each obligor to any finance party under the finance documents | |
Brèves mentions All the shares and related rights fixed charge all shares and related rights floating charge all its undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Guarantee and debenture created by the company (formerly known as john labatt retail limited) | Créé le 07 juin 1996 Livré le 19 juin 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the finance documents | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deed of assignment | Créé le 07 août 1992 Livré le 14 août 1992 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the fourth schedule of a management agreement dated 7/8/92 | |
Brèves mentions By way of first fixed charge all the companys right title and interest and benefit in an interest bearing deposit account k/a the maple leaf inns limited management fees account with no: 97510173 with national westminster bank PLC and all moneys from time to time standing in the nominated including all interest thereon and all amounts deriving therefrom whether directly or indirectly. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
ENTERPRISE INNS (NO 2) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0