EBBGATE NURSING HOMES LIMITED

EBBGATE NURSING HOMES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéEBBGATE NURSING HOMES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02690211
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de EBBGATE NURSING HOMES LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe EBBGATE NURSING HOMES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1 Angel Court
    EC2R 7HJ London
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de EBBGATE NURSING HOMES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BASISFOCUS LIMITED24 févr. 199224 févr. 1992

    Quels sont les derniers comptes de EBBGATE NURSING HOMES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2020

    Quels sont les derniers dépôts pour EBBGATE NURSING HOMES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2020

    5 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 07 févr. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2019

    5 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 07 févr. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018

    5 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 07 févr. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017

    5 pagesAA

    Nomination de Mr Michael Harrison en tant qu'administrateur le 27 avr. 2018

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Jonathan Stephen Picken en tant que directeur le 27 avr. 2018

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 07 févr. 2018 avec mises à jour

    3 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Bupa Secretaries Limited le 08 déc. 2017

    1 pagesCH02

    Les registres ont été transférés à l'adresse du siège social enregistré 1 Angel Court London EC2R 7HJ

    1 pagesAD04

    Modification des détails de Bupa Investments Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 08 déc. 2017

    2 pagesPSC05

    Modification des coordonnées du secrétaire Bupa Secretaries Limited le 08 déc. 2017

    1 pagesCH04

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Jonathan Stephen Picken le 08 déc. 2017

    2 pagesCH01

    Changement d'adresse du siège social de Bridge House, Outwood Lane Horsforth Leeds LS18 4UP à 1 Angel Court London EC2R 7HJ le 08 déc. 2017

    1 pagesAD01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    10 pagesAA

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré Bupa House 15-19 Bloomsbury Way London WC1A 2BA

    1 pagesAD03

    Déclaration de confirmation établie le 07 févr. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2015

    13 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 févr. 2016 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital29 févr. 2016

    État du capital au 29 févr. 2016

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    4 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de EBBGATE NURSING HOMES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BUPA SECRETARIES LIMITED
    Angel Court
    EC2R 7HJ London
    1
    United Kingdom
    Secrétaire
    Angel Court
    EC2R 7HJ London
    1
    United Kingdom
    107319700001
    HARRISON, Michael
    Angel Court
    EC2R 7HJ London
    1
    United Kingdom
    Administrateur
    Angel Court
    EC2R 7HJ London
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritish241166230001
    BUPA SECRETARIES LIMITED
    Angel Court
    EC2R 7HJ London
    1
    United Kingdom
    Administrateur
    Angel Court
    EC2R 7HJ London
    1
    United Kingdom
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement3155937
    162768400001
    KING, Robert Frederick
    8 Prior Bolton Street
    Canonbury
    N1 2NX London
    Secrétaire
    8 Prior Bolton Street
    Canonbury
    N1 2NX London
    British10012650001
    SLC REGISTRARS LIMITED
    42-46 High Street
    KT10 9QY Esher
    Surrey
    Secrétaire
    42-46 High Street
    KT10 9QY Esher
    Surrey
    34893920001
    BEAZLEY, Nicholas Tetley
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    Administrateur
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    United KingdomBritish105797560001
    CANNON, Andrew John
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    Administrateur
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    EnglandBritish200461360001
    DALY, Geoffrey William Stuart
    Sixpenny Buckle
    Coldhouse Hill
    GU22 0QS Woking
    Surrey
    Administrateur
    Sixpenny Buckle
    Coldhouse Hill
    GU22 0QS Woking
    Surrey
    United KingdomBritish19464860003
    DALY, Geoffrey William Stuart
    97 Valiant House
    Vicarage Crescent
    SW11 3LX London
    Administrateur
    97 Valiant House
    Vicarage Crescent
    SW11 3LX London
    British19464860001
    DAVIES, Julian Peter
    Timberlea, Warminster Road
    South Newton
    SP2 0QW Salisbury
    Wiltshire
    Administrateur
    Timberlea, Warminster Road
    South Newton
    SP2 0QW Salisbury
    Wiltshire
    United KingdomBritish29367700001
    DHANDSA, Narinder, Dr
    D102 Montevetro
    100 Battersea Church Road Battersea
    SW11 3YL London
    Administrateur
    D102 Montevetro
    100 Battersea Church Road Battersea
    SW11 3YL London
    EnglandBritish115844000001
    ELLERBY, Mark
    Burton Grange
    Burton Leonard
    HG3 3SU Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    Burton Grange
    Burton Leonard
    HG3 3SU Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritish40582650004
    GREGORY, Fraser David
    9 Nightingale Shott
    TW20 9SU Egham
    Berkshire
    Administrateur
    9 Nightingale Shott
    TW20 9SU Egham
    Berkshire
    United KingdomBritish107664270003
    KENT, Benjamin David Jemphrey
    Fernleigh Lodge
    Northchurch Common
    HP4 1LR Berkhamsted
    Hertfordshire
    Administrateur
    Fernleigh Lodge
    Northchurch Common
    HP4 1LR Berkhamsted
    Hertfordshire
    United KingdomBritish93897360003
    KING, Robert Frederick
    8 Prior Bolton Street
    Canonbury
    N1 2NX London
    Administrateur
    8 Prior Bolton Street
    Canonbury
    N1 2NX London
    British10012650001
    LOS, Steven Michael
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    Administrateur
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    United KingdomBritish116895800001
    MERCHANT, Mahboob Ali
    28 Denham Road
    KT17 3AA Epsom
    Surrey
    Administrateur
    28 Denham Road
    KT17 3AA Epsom
    Surrey
    United KingdomBritish56732410001
    MOORE, Keith
    Outwood Lane
    Horsforth
    LS18 4UP Leeds
    Bridge House
    United Kingdom
    Administrateur
    Outwood Lane
    Horsforth
    LS18 4UP Leeds
    Bridge House
    United Kingdom
    United KingdomBritish49217290002
    PICKEN, Jonathan Stephen
    Angel Court
    EC2R 7HJ London
    1
    United Kingdom
    Administrateur
    Angel Court
    EC2R 7HJ London
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritish189611450001
    REITER, Simon Philip
    Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House 15-19
    England
    Administrateur
    Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House 15-19
    England
    United KingdomBritish135845570001
    ROBINSON, Anthony Leake
    17 Chad Road
    Edgbaston
    B15 3ER Birmingham
    West Midlands
    Administrateur
    17 Chad Road
    Edgbaston
    B15 3ER Birmingham
    West Midlands
    British48323880001
    SALISBURY, Nicholas William
    14 Charmouth Road
    AL1 4SW St Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    14 Charmouth Road
    AL1 4SW St Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritish4380320002
    SINCLAIR BROWN, Frederick John
    Rudge House
    Itchel Lane Crondall
    GU10 5PR Farnham
    Surrey
    Administrateur
    Rudge House
    Itchel Lane Crondall
    GU10 5PR Farnham
    Surrey
    United KingdomBritish8070730003
    STOREY, Roger Christopher
    11 Newlands
    SG6 2JE Letchworth
    Hertfordshire
    Administrateur
    11 Newlands
    SG6 2JE Letchworth
    Hertfordshire
    United KingdomBritish1663050001
    TAYLOR, Neil Robert
    Highfield
    Church Street
    HG5 8NR Goldsborough
    Knaresborough
    Administrateur
    Highfield
    Church Street
    HG5 8NR Goldsborough
    Knaresborough
    United KingdomBritish62846800003
    THOMAS, Oliver Henry Dixon
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    Administrateur
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    United KingdomBritish256549290001
    TINDALL, Terence William
    19 Oak Tree Close
    GU25 4JF Virginia Water
    Surrey
    Administrateur
    19 Oak Tree Close
    GU25 4JF Virginia Water
    Surrey
    EnglandBritish4380330001
    WALFORD, Arthur David
    94 London Road
    HA7 4NS Stanmore
    Middlesex
    Administrateur
    94 London Road
    HA7 4NS Stanmore
    Middlesex
    United KingdomBritish6658190001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur EBBGATE NURSING HOMES LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Angel Court
    EC2R 7HJ London
    1
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Angel Court
    EC2R 7HJ London
    1
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleUnited Kingdom (England)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement902253
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    EBBGATE NURSING HOMES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 09 janv. 2004
    Livré le 14 janv. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All the company's right title and interest from time to time in and to the real property, the tangible moveable property, the accounts, the intellectual property, any goodwill and rights in relation to the uncalled capital of the company, the investments, the shares all dividends interest and other monies. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for the Secured Parties
    Transactions
    • 14 janv. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 août 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 28 mars 2001
    Livré le 11 avr. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All obligations due or to become due from the company to the chargee as trustee for the secured parties (as defined) (the "security trustee") or any of the other secured parties (as defined) including any liability in respect of any further advances made under the facilities or the mezzanine loan facility (as defined) on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 11 avr. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 janv. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Second debenture
    Créé le 27 oct. 1998
    Livré le 02 nov. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All liabilities of any nature of ebbgate nursing homes (london) limited to the chargee and/or any receiver howsoever arising whether under or in connection with the indemnity or otherwise
    Brèves mentions
    Legal mortgage - f/h property k/a chestnut court nursing home newton street bury greater manchester-GM509158 and all and whole that plot of ground in the city of edinburgh and county of midlothian (for further details see form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 02 nov. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 avr. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Standard security
    Créé le 03 sept. 1993
    Livré le 16 sept. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The whole of the plot of ground in the city of edingburgh and the county of mithlothian extending 4 acres on the soputh of liberton drive in the city of edingburgh and all fixtures and fittings and plant machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 16 sept. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 déc. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 12 août 1993
    Livré le 20 août 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the facility agreement (as defined)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 20 août 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 avr. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over credit balances
    Créé le 12 août 1993
    Livré le 17 août 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The deposits held by the bank on account nos 40115894 and 22202960. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 17 août 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 avr. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 28 mai 1992
    Livré le 05 juin 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 11/03/92,this debenture,and/or any other security documents
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital building fixtures fixed plant and machinery see form 395 for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays De Zoete Wedd Limited
    Transactions
    • 05 juin 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 avr. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0