NESTLÉ PURLAW LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | NESTLÉ PURLAW LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 02691982 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe NESTLÉ PURLAW LIMITED ?
| Adresse du siège social | Nestlé Purlaw Limited Haxby Road YO31 8TA York England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de NESTLÉ PURLAW LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2025 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour NESTLÉ PURLAW LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 01 mars 2027 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 15 mars 2027 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 01 mars 2026 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour NESTLÉ PURLAW LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Déclaration de confirmation établie le 01 mars 2026 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 12 déc. 2025
| 3 pages | SH01 | ||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2024 | 263 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 mars 2025 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 19 déc. 2024
| 3 pages | SH01 | ||||||||||
Notification de Nestle S.A. en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 19 déc. 2024 | 2 pages | PSC02 | ||||||||||
Cessation de Nestle Uk Ltd. en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 19 déc. 2024 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||
Notification de Nestle Uk Ltd. en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 19 déc. 2024 | 2 pages | PSC02 | ||||||||||
Cessation de Nestle Holdings (U.K.) Plc en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 19 déc. 2024 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Purlaw Company Haxby Road York YO31 8TA England à Nestlé Purlaw Limited Haxby Road York YO31 8TA le 03 déc. 2024 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Nomination de Mr Richard Anthony Watson en tant qu'administrateur le 03 déc. 2024 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Certificat de changement de nom Company name changed purlaw LIMITED\certificate issued on 03/12/24 | 3 pages | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2023 | 17 pages | AA | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Katarzyna Malgorzata Choinska le 01 mai 2024 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 mars 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Mrs Katarzyna Malgorzata Choinska en tant qu'administrateur le 01 mars 2024 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Matthieu Albert Weber en tant que directeur le 31 janv. 2024 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Certificat de changement de nom et de réimmatriculation en société à responsabilité limitée | 1 pages | CERT2 | ||||||||||
Réenregistrement des statuts | 27 pages | MAR | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Re-enregistrement d'une société à responsabilité illimitée privée en société à responsabilité limitée privée | 2 pages | RR06 | ||||||||||
Certificat de changement de nom Company name changed purlaw company\certificate issued on 13/12/23 | 1 pages | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Avis de changement de nom" | 2 pages | CONNOT | ||||||||||
Nomination de Mr Andrew Peter Shaw en tant qu'administrateur le 06 nov. 2023 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Calum Fionn Macrae en tant que directeur le 06 nov. 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de NESTLÉ PURLAW LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHOINSKA, Katarzyna Malgorzata | Administrateur | Haxby Road YO31 8TA York Nestlé Purlaw Limited England | England | Polish | 320124930004 | |||||
| SHAW, Andrew Peter | Administrateur | Haxby Road YO31 8TA York Nestlé Purlaw Limited England | England | British | 166727190001 | |||||
| WATSON, Richard Anthony | Administrateur | Haxby Road YO31 8TA York Nestlé Purlaw Limited England | England | British | 147005240001 | |||||
| DENIGAN, Susan Marie | Secrétaire | 29 North Elm Avenue 63119 St Louis Missouri Usa | American | 50101820001 | ||||||
| DESCHAMPS, Isabelle | Secrétaire | CR9 1NR Croydon St. Georges House Surrey | British | 87994070004 | ||||||
| MESSUD, Elizabeth Charlotte Lucienne Marjorie | Secrétaire | City Place RH6 0PA Gatwick 1 United Kingdom | 171882250001 | |||||||
| SWAN, Alan William | Secrétaire | Lakedown House Swife Lane Broad Oak TN21 8UX Heathfield East Sussex | British | 9826700001 | ||||||
| WHITEHEAD, Adrian | Secrétaire | 2 Forest Way BR5 2AQ Orpington Kent | British | 83031020001 | ||||||
| WOOD, Mark Alan | Secrétaire | 3 Oakland View Oaklands AL6 0RJ Welwyn Hertfordshire | British | 41724890006 | ||||||
| BACOURIS, Constantine | Administrateur | 26 Chemin Des Crets-De-Champel 1206 Geneva Switzerland | Greek | 26544500001 | ||||||
| BOUGHTON, Mark | Administrateur | 66 Queensberry Avenue CO6 1YN Copford Essex | British | 115917470001 | ||||||
| BROWN, Richard Samuel | Administrateur | 8 Kidmans Close Hilton PE18 9QB Huntingdon Cambridgeshir | British | 65690200001 | ||||||
| CHANDLER, Matthew John | Administrateur | Haxby Road YO31 8TA York Purlaw Company England | England | British | 236036750001 | |||||
| DUFFY, Terence Anthony | Administrateur | 68 Walpole House 126 Westminster Bridge Road SE1 7UN London | British | 58442920001 | ||||||
| EDWARDS, Kym Mcalpine, Mr. | Administrateur | 41 Walham Grove SW6 1QR London | United Kingdom | Australian | 51759890001 | |||||
| ELSESSER, James Richard | Administrateur | 6105 Lindell Boulevard St Louis FOREIGN Missouri 63112 Usa | American | 78033050001 | ||||||
| FISCHLI, Marcel | Administrateur | 401 County Hall East Block Magnum Square SE1 7GN London | Swiss | 100216090001 | ||||||
| FOLEY, Marsha Suzanne | Administrateur | 9 Rosscourt Mansions 13 Buckingham Palace Road SW1W 0PR London | American | 34464150006 | ||||||
| GRIMWOOD, Paul | Administrateur | Weydown House Farnham Lane GU27 1EU Haslemere Surrey | British | 86255060001 | ||||||
| HUSBAND, Mark David | Administrateur | 3 Blount Avenue RH19 1JJ East Grinstead West Sussex | British | 50620970001 | ||||||
| IRVINE, Stuart Joseph Featherstone | Administrateur | Warren House Coombe Road TN14 5RJ Otford Kent | British | 89654820001 | ||||||
| JENKINS, Douglas Erwin | Administrateur | 2115 Branch Road Fenton Missouri 63026 Usa | American | 71528440001 | ||||||
| KRUM, Franklin Warren | Administrateur | 1121 Erskine Manor Hill South Bend Indiana 46614 Usa | American | 71528460001 | ||||||
| LEGGE, Elizabeth Charlotte | Administrateur | City Place RH6 0PA Gatwick 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 152582530002 | |||||
| MACRAE, Calum Fionn | Administrateur | Haxby Road YO31 8TA York Purlaw Company England | United Kingdom | British | 236092070001 | |||||
| MALLINSON, Nigel Alexander | Administrateur | The Old Stores Whistlers Lane Silchester RG7 2NE Reading Berkshire | British | 59733490001 | ||||||
| MCCREA, Nigel Grant | Administrateur | Street Farm Ashen CO10 8JN Sudbury Suffolk | British | 38633260002 | ||||||
| MCDANIEL, David Steven | Administrateur | City Place RH6 0PA Gatwick 1 | England | British | 207312520002 | |||||
| MESSENT, Peter Ronald, Dr | Administrateur | 3 Graham Road IP1 3QE Ipswich Suffolk | England | British | 53186560001 | |||||
| O'CONNOR, John Edward | Administrateur | 1 Chandler Way Broughton Astley LE9 6SW Leicestershire | British | 33574800001 | ||||||
| PHILLIPS, Steven Norman | Administrateur | Rafters The Glade Kingswood KT20 6LL Tadworth Surrey | United Kingdom | British | 119044110002 | |||||
| PLANA DEL LLANO, Luis | Administrateur | 11-13 1294 Chemin Du Creux De Genthod FOREIGN 1294 Genthod Geneva Switzerland | Spanish | 69153020001 | ||||||
| RAE, Graham Keith | Administrateur | 29 Maida Avenue Little Venice W2 1ST London | British | 40889300003 | ||||||
| SEILER, Marc Philippe | Administrateur | City Place RH6 0PA Gatwick 1 | England | French And Swiss | 191635480001 | |||||
| SWAN, Alan William | Administrateur | Lakedown House Swife Lane Broad Oak TN21 8UX Heathfield East Sussex | British | 9826700001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur NESTLÉ PURLAW LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nestle Uk Ltd. | 19 déc. 2024 | Haxby Road YO31 8TA York Nestle Uk Ltd. England | Oui | ||||||||||||
| |||||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||||
| Nestle S.A. | 19 déc. 2024 | Avenue Nestle 1800 Vevey 55 Switzerland | Non | ||||||||||||
| |||||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||||
| Nestle Holdings (U.K.) Plc | 06 avr. 2016 | City Place RH6 0PA Gatwick 1 England | Oui | ||||||||||||
| |||||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0