HIGHWAY (BURNLEY) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHIGHWAY (BURNLEY) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02693859
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HIGHWAY (BURNLEY) LIMITED ?

    • (8514) /

    Où se situe HIGHWAY (BURNLEY) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Craegmoor House
    Perdiswell Park
    WR3 7NW Worcestershire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de HIGHWAY (BURNLEY) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BRIAN CHRISTOPHER PROPERTY LIMITED16 avr. 199216 avr. 1992
    BANDNAME LIMITED05 mars 199205 mars 1992

    Quels sont les derniers comptes de HIGHWAY (BURNLEY) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour HIGHWAY (BURNLEY) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Cessation de la nomination de David Manson en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr David James Hall en tant que secrétaire

    2 pagesAP03

    Nomination de Mr Philip Henry Scott en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Jason David Lock en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Matthew Franzidis en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Scott Morrison en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Albert Smith en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Christine Cameron en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Julian Ball en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 mars 2011 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital30 mars 2011

    État du capital au 30 mars 2011

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    legacy

    3 pagesMG02

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2009

    14 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 mars 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    legacy

    2 pages288a

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2008

    16 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages353a

    legacy

    1 pages190a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages288a

    Qui sont les dirigeants de HIGHWAY (BURNLEY) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HALL, David James
    Randalls Way
    KT22 7TP Leatherhead
    Priory House
    Surrey
    United Kingdom
    Secrétaire
    Randalls Way
    KT22 7TP Leatherhead
    Priory House
    Surrey
    United Kingdom
    159660530001
    FRANZIDIS, Matthew
    Randalls Way
    KT22 7TP Leatherhead
    Priory House
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    Randalls Way
    KT22 7TP Leatherhead
    Priory House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandUk129251300001
    LOCK, Jason David
    Randalls Way
    KT22 7TP Leatherhead
    Priory House
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    Randalls Way
    KT22 7TP Leatherhead
    Priory House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritish144822040001
    SCOTT, Philip Henry
    Randalls Way
    KT22 7TP Leatherhead
    Priory House
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    Randalls Way
    KT22 7TP Leatherhead
    Priory House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritish174231320001
    CHRISTOPHER, Brian John
    11 Acres Brook Road
    Higham
    BB12 9BY Burnley
    Lancashire
    Secrétaire
    11 Acres Brook Road
    Higham
    BB12 9BY Burnley
    Lancashire
    British18037120001
    CHRISTOPHER, Richard Robert Edward
    9 Millcombe Way
    Walton Le Dale
    PR5 4NB Preston
    Lancashire
    Secrétaire
    9 Millcombe Way
    Walton Le Dale
    PR5 4NB Preston
    Lancashire
    British54424700002
    MORRISON, Scott
    24 Gaveston Road
    CV32 6EU Leamington Spa
    Warwickshire
    Secrétaire
    24 Gaveston Road
    CV32 6EU Leamington Spa
    Warwickshire
    British99297890001
    BLG (PROFESSIONAL SERVICES) LIMITED
    7th Floor Beaufort House
    15 St Botolph Street
    EC3A 7NJ London
    Secrétaire
    7th Floor Beaufort House
    15 St Botolph Street
    EC3A 7NJ London
    39680630001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ANDREWS, Carole
    155 Watermoor Road
    GL7 1LF Cirencester
    Gloucestershire
    Administrateur
    155 Watermoor Road
    GL7 1LF Cirencester
    Gloucestershire
    British102238960001
    BALL, Julian Charles
    Mill Fleam
    Hilton
    DE65 5HE Derby
    14
    Derbyshire
    Administrateur
    Mill Fleam
    Hilton
    DE65 5HE Derby
    14
    Derbyshire
    EnglandBritish138044110001
    CAMERON, Charles Donald Ewen
    Orchard Manor
    Church Lane Martin Hussingtree
    WR3 8TQ Worcester
    Worcestershire
    Administrateur
    Orchard Manor
    Church Lane Martin Hussingtree
    WR3 8TQ Worcester
    Worcestershire
    EnglandBritish113187140001
    CAMERON, Christine Isabel
    10 Mount Crescent
    HR1 NQ1 Hereford
    Administrateur
    10 Mount Crescent
    HR1 NQ1 Hereford
    EnglandBritish163745150001
    CAVANAGH, Peter Kenneth
    8 Fir Grove
    Paddington
    WA1 3JF Warrington
    Administrateur
    8 Fir Grove
    Paddington
    WA1 3JF Warrington
    British114627410002
    CHRISTOPHER, Barbara Ruth
    11 Acres Brook Road
    Higham
    BB12 9BY Burnley
    Lancashire
    Administrateur
    11 Acres Brook Road
    Higham
    BB12 9BY Burnley
    Lancashire
    British18037140001
    CHRISTOPHER, Brian John
    11 Acres Brook Road
    Higham
    BB12 9BY Burnley
    Lancashire
    Administrateur
    11 Acres Brook Road
    Higham
    BB12 9BY Burnley
    Lancashire
    British18037120001
    CHRISTOPHER, Richard Robert Edward
    9 Millcombe Way
    Walton Le Dale
    PR5 4NB Preston
    Lancashire
    Administrateur
    9 Millcombe Way
    Walton Le Dale
    PR5 4NB Preston
    Lancashire
    British54424700002
    HILL, Margaret
    11 Pear Tree Close
    Hollingsworth
    S43 2LU Chesterfield
    Derbyshire
    Administrateur
    11 Pear Tree Close
    Hollingsworth
    S43 2LU Chesterfield
    Derbyshire
    EnglandBritish102587360001
    KAY, Allyson
    12 Folks Wood Way
    Stone Street Lympne
    CT21 4EW Hythe
    Kent
    Administrateur
    12 Folks Wood Way
    Stone Street Lympne
    CT21 4EW Hythe
    Kent
    British93464240001
    KEATING, Denise Elizabeth
    62 Church Street
    Cogenhoe
    NN7 1LS Northampton
    Northamptonshire
    Administrateur
    62 Church Street
    Cogenhoe
    NN7 1LS Northampton
    Northamptonshire
    EnglandBritish111513540001
    MANSON, David Lindsay
    111 Lodge Road
    Knowle
    B93 0HG Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    111 Lodge Road
    Knowle
    B93 0HG Solihull
    West Midlands
    EnglandBritish126071210001
    NEWHAM, Pamela Maria
    Rowan Cottage
    38 Reedley Road Reedley
    BB10 2LU Burnley
    Lancashire
    Administrateur
    Rowan Cottage
    38 Reedley Road Reedley
    BB10 2LU Burnley
    Lancashire
    British69690300002
    SAVILLE, Richard Cyril Campbell
    Fairings
    Valley Way
    SL9 7PL Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Fairings
    Valley Way
    SL9 7PL Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    EnglandBritish38530070001
    SMITH, Albert Edward
    Flint House
    Froxfield
    SN8 3JY Marlborough
    Wiltshire
    Administrateur
    Flint House
    Froxfield
    SN8 3JY Marlborough
    Wiltshire
    EnglandBritish77631340001
    SPURLING, Julian Neville Guy
    Foundry House
    GU35 9LY Kingsley
    Hampshire
    Administrateur
    Foundry House
    GU35 9LY Kingsley
    Hampshire
    EnglandBritish110225070001
    STRATFORD, Michael Anthony
    10 Anne Hathaway Drive
    GL3 2PX Churchdown
    Gloucestershire
    Administrateur
    10 Anne Hathaway Drive
    GL3 2PX Churchdown
    Gloucestershire
    United KingdomBritish38853720002
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur désigné
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    HIGHWAY (BURNLEY) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of accession and charge acceeding to the debenture dated 18 july 2008 and
    Créé le 02 oct. 2008
    Livré le 08 oct. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each chargor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The acquisition agreement claims all rights in respect of the insurance policies, the hedging agreements, any structural intra group loans fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transactions
    • 08 oct. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 17 sept. 2007
    Livré le 26 sept. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the companies to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 26 sept. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 juil. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental legal mortgage
    Créé le 11 mars 2006
    Livré le 21 mars 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    3 talbot street burnley t/n LA486809,. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 21 mars 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 sept. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental legal mortgage
    Créé le 11 mars 2006
    Livré le 21 mars 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the lenders (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The property being 3 talbot street burnley t/n LA486809,. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (As Security Agent for the Lenders)
    Transactions
    • 21 mars 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 sept. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite debenture
    Créé le 11 mars 2006
    Livré le 21 mars 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the lenders (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (Security Agent)
    Transactions
    • 21 mars 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 sept. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite debenture
    Créé le 31 déc. 2004
    Livré le 06 janv. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from craegmoor homes limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 06 janv. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 sept. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 17 oct. 2003
    Livré le 06 nov. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 06 nov. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 sept. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 17 oct. 2003
    Livré le 06 nov. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 06 nov. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 sept. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 17 oct. 2003
    Livré le 06 nov. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from craegmoor homes limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 06 nov. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 févr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 26 févr. 1999
    Livré le 05 mars 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 05 mars 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 nov. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 12 mars 1993
    Livré le 13 mars 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property k/a 30 talbot street burnley inc: fixtuer and fittings title no: LA485170. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Yorkshire Bank PLC
    Transactions
    • 13 mars 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 nov. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0