SANCTUARY RECORDS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSANCTUARY RECORDS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02694276
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SANCTUARY RECORDS LIMITED ?

    • Création artistique (90030) / Activités artistiques, de loisirs et de divertissement
    • Autres activités de services n.c.a. (96090) / Autres activités de services

    Où se situe SANCTUARY RECORDS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    33 Wigmore Street
    W1U 1QX London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SANCTUARY RECORDS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SANCTUARY ASSOCIATED INVESTMENTS LIMITED05 mars 199205 mars 1992

    Quels sont les derniers comptes de SANCTUARY RECORDS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour SANCTUARY RECORDS LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour SANCTUARY RECORDS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Maximilian Dressendoerfer le 17 oct. 2014

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Mark David Ranyard le 17 oct. 2014

    2 pagesCH01

    Comptes établis au 31 déc. 2013

    8 pagesAA

    legacy

    2 pagesSH20

    État du capital au 28 août 2014

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    legacy

    2 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Beaumont House Avonmore Road Kensington Village London W14 8TS United Kingdom à Simons Muirhead & Burton 8 9 Frith Street London W1D 3JB

    1 pagesAD02

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré Simons Muirhead & Burton 8 9 Frith Street London W1D 3JB

    1 pagesAD03

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 mars 2014 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Changement d'adresse du siège social de C/O Davenport Lyons 30 Old Burlington Street London W1S 3NL le 10 sept. 2013

    1 pagesAD01

    Nomination de Mr Mark David Ranyard en tant qu'administrateur le 30 avr. 2013

    2 pagesAP01

    Nomination de Maximilian Dressendoerfer en tant qu'administrateur le 30 avr. 2013

    2 pagesAP01

    Nomination de John Leslie Dobinson en tant qu'administrateur le 30 avr. 2013

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Timothy Spencer Smith en tant que directeur le 30 avr. 2013

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de 364-366 Kensington High Street London W14 8NS England le 10 mai 2013

    2 pagesAD01

    Comptes établis au 31 déc. 2012

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 mars 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Richard Michael Constant en tant que directeur le 21 nov. 2012

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Andrew Brown en tant que directeur le 21 nov. 2012

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Abolanle Abioye en tant que secrétaire le 21 nov. 2012

    1 pagesTM02

    Nomination de Timothy Spencer Smith en tant qu'administrateur le 21 nov. 2012

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de SANCTUARY RECORDS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    DOBINSON, John Leslie
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    England
    Administrateur
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    England
    United KingdomBritishChief Operating Officer - Europe34942720003
    DRESSENDOERFER, Maximilian, Dr
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    England
    Administrateur
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    England
    GermanyGermanCompany Director157717080010
    RANYARD, Mark David
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    England
    Administrateur
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    England
    EnglandBritishFinance Director154884950002
    ABIOYE, Abolanle
    Kensington High Street
    W14 8NS London
    364-366
    United Kingdom
    Secrétaire
    Kensington High Street
    W14 8NS London
    364-366
    United Kingdom
    BritishSecretary88802330001
    JOY, Matthew Robert
    2 Chestnut Place
    KT21 2DY Ashtead
    Surrey
    Secrétaire
    2 Chestnut Place
    KT21 2DY Ashtead
    Surrey
    British115905420001
    MILLER, Michael David
    76 Marsworth Avenue
    HA5 4TT Pinner
    Middlesex
    Secrétaire
    76 Marsworth Avenue
    HA5 4TT Pinner
    Middlesex
    British44250870001
    STANDING, Sarah Elizabeth Anne
    1 Pilsdon Close
    Inner Park Road Wimbledon
    SW19 6DR London
    Secrétaire
    1 Pilsdon Close
    Inner Park Road Wimbledon
    SW19 6DR London
    British41378870002
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Secrétaire désigné
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    BROWN, Andrew
    Kensington High Street
    W14 8NS London
    364-366
    United Kingdom
    Administrateur
    Kensington High Street
    W14 8NS London
    364-366
    United Kingdom
    EnglandBritishInternational Chief Financial Officer163199590001
    BURTON, Paul Anthony
    65 Hartford Road
    DA5 1NL Bexley
    Kent
    Administrateur
    65 Hartford Road
    DA5 1NL Bexley
    Kent
    EnglandBritishChartered Accountant34303730002
    COKELL, Joseph
    Talltrees
    Orpington Road
    BR7 6RA Chislehurst
    Kent
    Administrateur
    Talltrees
    Orpington Road
    BR7 6RA Chislehurst
    Kent
    Gb-EngBritishCompany Director76396440001
    CONSTANT, Richard Michael
    Kensington High Street
    W14 8NS London
    364-366
    United Kingdom
    Administrateur
    Kensington High Street
    W14 8NS London
    364-366
    United Kingdom
    United KingdomBritishGeneral Counsel43836310003
    COURTNEY, Rohan Richard
    Deepwood
    Lower Wood Road
    SY8 2JQ Ludlow
    Shropshire
    Administrateur
    Deepwood
    Lower Wood Road
    SY8 2JQ Ludlow
    Shropshire
    BritishCompany Director9512790002
    DAVIES, David Michael
    13 Marine Parade
    CF64 3BG Penarth
    South Glamorgan
    Administrateur
    13 Marine Parade
    CF64 3BG Penarth
    South Glamorgan
    United KingdomBritishDirector3792920003
    DAVIES, Hywel Hadley
    2b Florence Road
    W5 3TX London
    Administrateur
    2b Florence Road
    W5 3TX London
    BritishManaging Director13515170001
    DRISCOLL, James Christopher
    66 Norton Road
    DY8 2AQ Stourbridge
    West Midlands
    Administrateur
    66 Norton Road
    DY8 2AQ Stourbridge
    West Midlands
    BritishCompany Director98716480001
    DRISCOLL, James Christopher
    66 Norton Road
    DY8 2AQ Stourbridge
    West Midlands
    Administrateur
    66 Norton Road
    DY8 2AQ Stourbridge
    West Midlands
    BritishDirector98716480001
    HAXBY, Martin James, Mr.
    Wildhern 133 Silverdale Avenue
    Ashley Park
    KT12 1EJ Walton On Thames
    Surrey
    Administrateur
    Wildhern 133 Silverdale Avenue
    Ashley Park
    KT12 1EJ Walton On Thames
    Surrey
    United KingdomBritishBusiness Affairs Director6001160002
    MILLER, Michael David
    High Trees 15a Linksway
    HA6 2XA Northwood
    Middlesex
    Administrateur
    High Trees 15a Linksway
    HA6 2XA Northwood
    Middlesex
    United KingdomBritishChartered Accountant44250870002
    MUIR, Boyd Johnston
    Colorado Avenue
    CA 90404 Santa Monica
    2220
    Usa
    Administrateur
    Colorado Avenue
    CA 90404 Santa Monica
    2220
    Usa
    United StatesBritishEvp & Chief Financial Officer172824510001
    NAJEEB, Aky
    The Old School House
    Bovington Green
    SL7 2JH Marlow
    Buckinghamshire
    Administrateur
    The Old School House
    Bovington Green
    SL7 2JH Marlow
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director10689380007
    SMALLWOOD, Roderick Charles
    42 Hartingdon Road
    Chiswick
    W4 London
    Administrateur
    42 Hartingdon Road
    Chiswick
    W4 London
    BritishManager43907530001
    SMITH, Timothy Spencer
    Avonmore Road
    Kensington Village
    W14 8TS London
    Beaumont House
    United Kingdom
    Administrateur
    Avonmore Road
    Kensington Village
    W14 8TS London
    Beaumont House
    United Kingdom
    EnglandBritishSolicitor130003340001
    TAYLOR, Andrew John
    The Bridge House Bisham Road
    SL7 1RP Marlow
    Buckinghamshire
    Administrateur
    The Bridge House Bisham Road
    SL7 1RP Marlow
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishChartered Accountant54448520001
    WALLACE, Paul Frederick
    Westfield House
    Nunnery Lane
    TN11 8HA Penshurst
    Kent
    Administrateur
    Westfield House
    Nunnery Lane
    TN11 8HA Penshurst
    Kent
    EnglandBritishChartered Accountant76655520001
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Administrateur désigné
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001500001

    SANCTUARY RECORDS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 14 juin 2002
    Livré le 27 juin 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 27 juin 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 sept. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of amendment to a composite guarantee and debenture dated 29 october 1998 (the "deed")
    Créé le 11 août 2000
    Livré le 30 août 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All indebtedness liabilities and obligations due owing or incurred to the chargee under the mezzanine documents by any charging company (as defined)
    Brèves mentions
    L/H property k/a 45-53 sinclair road, hammersmith, london t/no BGL14049 together with all buildings, fixtures and its fixed plant and machinery at any time thereon.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Abn Amro Causeway Mezzanine Partnership LP
    Transactions
    • 30 août 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 mai 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of amendment to a composite guarantee and debenture dated 29 october 1998
    Créé le 01 juil. 1999
    Livré le 09 juil. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All indebtedness liabilities and obligations due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee pursuant to the terms of the mezzanine documents (as defined)
    Brèves mentions
    All its f/h and l/h interest in the properties being the l/h property k/a 45-53 sinclair road,hammersmith,london t/no BGL14049 together with all buildings,fixtures (excluding in the case of l/h property landlord's fixtures but including other trade fixtures and excluding in the case of f/h property and l/h property which is let or sub-let to a third party,tenant's and trade fixtures and fittings of such third party) and its fixed plant and machinery at any time thereon.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Abn Amro Causeway Mezzanine Partnership LP
    Transactions
    • 09 juil. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 mai 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 29 oct. 1998
    Livré le 17 nov. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the mezzanine documents
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Abn Amro Causeway Mezzanine Partnership LP
    Transactions
    • 17 nov. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 mai 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 26 oct. 1998
    Livré le 06 nov. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 06 nov. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 sept. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of amendment to a composite guarantee and debenture originally dated 3RD september 1997
    Créé le 03 juil. 1998
    Livré le 21 juil. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from sanctuary enterprises PLC (borrower) to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the mezzanine loan agreement and the deed
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Abn Amro Causeway Mezzanine Partnership LP
    Transactions
    • 21 juil. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 mai 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of amendment to a composite guarantee and debenture dated 3 september 1997
    Créé le 20 mai 1998
    Livré le 06 juin 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies which are as at 20 may 1998 due or to become due from sanctuary enterprises PLC (the "borrower") to the chargee under the mezzanine loan agreement dated 3 september 1997 whether pursuant to the guarantee as therein defined) or otherwise and all other sums payable pursuant to the terms of the mezzanine loan agreement and the deed
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Abn Amro Causeway Mezzanine Partnership LP
    Transactions
    • 06 juin 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 mai 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite guarantee & debenture
    Créé le 03 sept. 1997
    Livré le 19 sept. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    That part of the mezzanine loan facility drawndown by the the sanctuary group PLC to the company or to nomis studios limited and/or to companies in which either of the company or nomis holds an equity interest
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Abn Amro Causeway Mezzanine Partnership LP
    Transactions
    • 19 sept. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 mai 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 26 août 1997
    Livré le 16 sept. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • Brown Shipley & Co Limited
    Transactions
    • 16 sept. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 févr. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 24 mars 1997
    Livré le 26 mars 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • Coutts & Company
    Transactions
    • 26 mars 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 oct. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 28 sept. 1994
    Livré le 01 oct. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • Coutts & Company
    Transactions
    • 01 oct. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 oct. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0