FARNBOROUGH AIRPORT PROPERTIES COMPANY
Vue d'ensemble
| Nom de la société | FARNBOROUGH AIRPORT PROPERTIES COMPANY |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société privée à responsabilité illimitée |
| Numéro de société | 02698195 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe FARNBOROUGH AIRPORT PROPERTIES COMPANY ?
| Adresse du siège social | 5th Floor Leconfield House Curzon Street W1J 5JA London |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de FARNBOROUGH AIRPORT PROPERTIES COMPANY ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 30 mai 2020 |
Quels sont les derniers dépôts pour FARNBOROUGH AIRPORT PROPERTIES COMPANY ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 30 mai 2020 | 6 pages | AA | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Ms Nicole Ann Martin le 23 avr. 2021 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 12 mars 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Ms Nicole Ann Martin le 19 sept. 2020 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Ms Nicole Ann Martin le 19 sept. 2020 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 12 mars 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Ms Nicole Ann Martin en tant qu'administrateur le 07 févr. 2020 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Klosters Limited en tant que directeur le 07 févr. 2020 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 30 mai 2019 | 10 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 12 mars 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 30 mai 2018 | 10 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Timothy John Smalley en tant que directeur le 03 déc. 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Robert Tchenguiz en tant qu'administrateur le 03 déc. 2018 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 12 mars 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 30 mai 2017 | 14 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 12 mars 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 30 mai 2016 | 18 pages | AA | ||||||||||
Démission de l'auditeur | 3 pages | AUD | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 12 mars 2016 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes annuels établis au 30 mai 2015 | 17 pages | AA | ||||||||||
Satisfaction de la charge 1 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 2 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de FARNBOROUGH AIRPORT PROPERTIES COMPANY ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTIN, Nicole Ann | Administrateur | Floor Leconfield House Curzon Street W1J 5JA London 5th | United Kingdom | British | 244758010003 | |||||||||||||
| TCHENGUIZ, Robert | Administrateur | Floor Leconfield House Curzon Street W1J 5JA London 5th | England | British | 74322720004 | |||||||||||||
| DUNCAN, Rosemary | Secrétaire | 3066 119th Street Toledo 43611 United States Of America | American | 65379670001 | ||||||||||||||
| INGHAM, Michael Harry Peter | Secrétaire | 3 Lauriston Road Wimbledon SW19 4TJ London | British | 2739650001 | ||||||||||||||
| EPS SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | Lacon House Theobalds Road WC1X 8RW London | 67339580001 | |||||||||||||||
| BARNARD, Neal Brian | Administrateur | 26703 Nawash Drive Perrysburg 43551 Ohio United States Of America | American | 67684380001 | ||||||||||||||
| BEHAM, Joseph Alan | Administrateur | 6029 Wild Ivy Court Sylvania Ohio 43560 Usa | American | 56706690001 | ||||||||||||||
| BISHOP, Paul J | Administrateur | 1801 Richards Road Toledo Ohio 43697 Usa | American | 51363820003 | ||||||||||||||
| BISHOP, Paul J | Administrateur | 724 E Boundary Road 43551 Perrysburg Ohio Usa | American | 51363820001 | ||||||||||||||
| DEY, Jayanta | Administrateur | 13759 Heron Circle FOREIGN Clearwater Florida 34622 Usa | American | 21435320001 | ||||||||||||||
| GRUNNELL, Mark | Administrateur | Montolieu Gardens SW15 6PB London 3 | United Kingdom | British | 94144450002 | |||||||||||||
| HOLY, Julian Robert | Administrateur | 33 Spencer Road W4 3SS Chiswick Greater London | United Kingdom | British | 91517950001 | |||||||||||||
| MOYER, Kevin P | Administrateur | 26788 Mohawk Drive 43551 Perrysburg Ohio Usa | American | 51343000001 | ||||||||||||||
| POLLOCK, Robert Evans | Administrateur | 3640 Brookside FOREIGN Toledo Ohio 43606 Usa | American | 21435340001 | ||||||||||||||
| SHULTZ, Edward | Administrateur | 7164 Forest Brook Drive 43560 Sylvania Ohio Usa | American | 45098000001 | ||||||||||||||
| SMALLEY, Timothy John | Administrateur | Chivers Road CM15 0LG Stondon Massey Stondon Place Essex | United Kingdom | British | 102593650002 | |||||||||||||
| TCHENGUIZ, Robert | Administrateur | Royal College Of Organists 26 Kensington Gore SW7 2ET London | England | British | 74322720004 | |||||||||||||
| TCHENGUIZ, Robert | Administrateur | 6 Chesterfield Hill Mayfair W1J 5BL London | Iranian | 74322720002 | ||||||||||||||
| KLOSTERS LIMITED | Administrateur | Les Banques St Sampsons GY1 3HS Guernsey La Tonnelle House Channel Islands |
| 188565290001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur FARNBOROUGH AIRPORT PROPERTIES COMPANY ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gatevalley Limited | 06 avr. 2016 | Curzon Street W1J 5JA London 5th Floor, Leconfield House England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
FARNBOROUGH AIRPORT PROPERTIES COMPANY a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Créé le 12 oct. 2005 Livré le 20 oct. 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each obligor to the lender parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions L/H property k/a bristol house t/no HP451127 and york house t/no HP451125 at lakeside road, farnborough, hampshire, all rights, title, interest and benefit in and to the rent account and the rent account deposit and to any account proceeds and floating charge its undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 09 mars 2004 Livré le 17 mars 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each obligor to the lender parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The l/h property k/a bristol house t/n HP451127 and york house t/n HP451125 at lakeside road farnborough hampshire, all of its rights title and interest and benefit in and to the rent account and the rent account deposit, in and to the free cash account and the free cash account deposit. By way of second floating charge its undertaking and all its assets both present and future. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage | Créé le 21 août 1992 Livré le 26 août 1992 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the trust indenture and other security documents (as defined | |
Brèves mentions L/H buildings S2 & S3 farnborough aerospace centre farnborough hants.floating charge over see form 395 for details. Undertaking and all property and assets. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Memorandum of charge over rent account | Créé le 21 août 1992 Livré le 26 août 1992 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the indenture trust and other security documents (as defined | |
Brèves mentions All rights title interest in and to all amounts standing to the credit of the company on account no.3056279 With citibank N.A. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0