FITCH INTERNATIONAL LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéFITCH INTERNATIONAL LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02699605
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de FITCH INTERNATIONAL LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe FITCH INTERNATIONAL LIMITED ?

    Adresse du siège social
    27 Farm Street
    London
    W1J 5RJ
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de FITCH INTERNATIONAL LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    THORSTEIN LIMITED23 mars 199223 mars 1992

    Quels sont les derniers comptes de FITCH INTERNATIONAL LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour FITCH INTERNATIONAL LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Cessation de la nomination de Nicholas David Charles Bishop en tant que directeur le 27 juil. 2012

    1 pagesTM01

    Nomination de James Alistair Burnley Bruce en tant qu'administrateur le 16 juil. 2012

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2011

    13 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 23 mars 2012 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital29 mars 2012

    État du capital au 29 mars 2012

    • Capital: GBP 5,051,868
    SH01

    État du capital après une attribution d'actions au 23 nov. 2011

    • Capital: GBP 5,051,868
    3 pagesSH01

    Cessation de la nomination de Wpp Group (Nominees) Limited en tant que secrétaire le 08 déc. 2011

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Christopher Paul Sweetland en tant que directeur le 08 déc. 2011

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Andrew Grant Balfour Scott en tant que directeur le 08 déc. 2011

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Robert Charles Horjus en tant que directeur le 08 déc. 2011

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Paul Delaney en tant que directeur le 08 déc. 2011

    1 pagesTM01

    Nomination de Robert Charles Horjus en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 23 mars 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    5 pagesAA

    Nomination de Nicholas David Charles Bishop en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 23 mars 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2008

    7 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    Comptes établis au 31 déc. 2007

    7 pagesAA

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    4 pages363a

    Qui sont les dirigeants de FITCH INTERNATIONAL LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BRUCE, James Alistair Burnley
    Rowallan Road
    SW6 6AG London
    56a
    England
    England
    Administrateur
    Rowallan Road
    SW6 6AG London
    56a
    England
    England
    United KingdomBritishAccountant159021010001
    BATESON, Anne Rosalind
    High Trees
    Great Holland
    CO13 0HZ Frinton On Sea
    Essex
    Secrétaire désigné
    High Trees
    Great Holland
    CO13 0HZ Frinton On Sea
    Essex
    British900007490001
    BHUCHAR, Sangeeta
    19 Bramfield Road
    SW11 6RA London
    Secrétaire
    19 Bramfield Road
    SW11 6RA London
    British32354180001
    CALOW, David Ferguson
    27 Farm Street
    W1J 5RJ London
    Secrétaire
    27 Farm Street
    W1J 5RJ London
    British91285750001
    JOHNSTON, Kathleen Marie
    2671 North Lincoln Avenue Number 3-S
    FOREIGN Chicago
    Illinois Il 60614
    Usa
    Secrétaire
    2671 North Lincoln Avenue Number 3-S
    FOREIGN Chicago
    Illinois Il 60614
    Usa
    BritishGeneral Counsel75539330001
    THOMPSON, Christopher James
    19 Herrick Road
    Highbury
    N5 2JX London
    Secrétaire
    19 Herrick Road
    Highbury
    N5 2JX London
    BritishCompany Secretary29191340001
    WILLIAMS, Denise
    Marie Cottage
    Holmbury Lane
    RH5 6ND Holmbury St Mary
    Surrey
    Secrétaire
    Marie Cottage
    Holmbury Lane
    RH5 6ND Holmbury St Mary
    Surrey
    BritishCompany Secretary24311940004
    WPP GROUP (NOMINEES) LIMITED
    27 Farm Street
    W1J 5RJ London
    Secrétaire
    27 Farm Street
    W1J 5RJ London
    80143770001
    BECK, Martin James
    Sweet Clover Farm
    8800 Olentang River Road
    FOREIGN Delaware Ohio 43015 Usa
    Administrateur
    Sweet Clover Farm
    8800 Olentang River Road
    FOREIGN Delaware Ohio 43015 Usa
    AmericanChief Executive29191330003
    BENTZ, Jean Francois
    29b Queens Gate Mews
    South Kensington
    SW7 5QL London
    Administrateur
    29b Queens Gate Mews
    South Kensington
    SW7 5QL London
    FrenchDirector34384710002
    BHUCHAR, Sangeeta
    19 Bramfield Road
    SW11 6RA London
    Administrateur
    19 Bramfield Road
    SW11 6RA London
    BritishChartered Accountant32354180001
    BISHOP, Nicholas David Charles
    27 Farm Street
    London
    W1J 5RJ
    Administrateur
    27 Farm Street
    London
    W1J 5RJ
    United KingdomBritishFinance Director118379060002
    BOLAND, Andrew Kenneth
    25 Chessfield Park
    Little Chalfont
    HP6 6RU Amersham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    25 Chessfield Park
    Little Chalfont
    HP6 6RU Amersham
    Buckinghamshire
    BritishAccountant71264540005
    BUSS, Jeremy David
    34 Goddington Road
    SL8 5TZ Bourne End
    Buckinghamshire
    Administrateur
    34 Goddington Road
    SL8 5TZ Bourne End
    Buckinghamshire
    United Kingdom British Accountant26720550002
    D'ANGELO, Arthur Edward
    35 Wendy Drive
    Staton Island
    New York
    Ny 10312
    Usa
    Administrateur
    35 Wendy Drive
    Staton Island
    New York
    Ny 10312
    Usa
    UsaAmericanAccountant72254570001
    DELANEY, Paul
    27 Farm Street
    W1J 5RJ London
    Administrateur
    27 Farm Street
    W1J 5RJ London
    United KingdomBritishGroup Treasurer69254240002
    GRAUNKE, Terence Michael
    461 Oak Knoll Road
    Barrington Hills
    60010 Illinois
    Usa
    Administrateur
    461 Oak Knoll Road
    Barrington Hills
    60010 Illinois
    Usa
    AmericanDirector63226590001
    HAM, David Fenton
    25 Chestnut Avenue
    TN4 0BT Tunbridge Wells
    Kent
    Administrateur
    25 Chestnut Avenue
    TN4 0BT Tunbridge Wells
    Kent
    EnglandBritishChartered Accountant103819950001
    HARRISON, John Kevin
    5 St Dionis Road
    SW6 4UQ Parsons Green
    Administrateur
    5 St Dionis Road
    SW6 4UQ Parsons Green
    United KingdomBritishChief Executive Officer94570680001
    HORJUS, Robert Charles
    27 Farm Street
    London
    W1J 5RJ
    Administrateur
    27 Farm Street
    London
    W1J 5RJ
    UsaAmericanChief Financial Officer67879780001
    LAI, Poh Lim
    24 Redwood Drive
    LU7 0TA Wing
    Buckinghamshire
    Administrateur désigné
    24 Redwood Drive
    LU7 0TA Wing
    Buckinghamshire
    British900007480001
    MARKING, Giles
    The Manor
    Toller Whelme
    DT8 3NU Beaminster
    Dorset
    Administrateur
    The Manor
    Toller Whelme
    DT8 3NU Beaminster
    Dorset
    United KingdomBritishDesigner121432880001
    MCLEOD, Gerald John Moreton
    Porthview 9 The Lugger
    Portscatho
    TR2 5HE Truro
    Cornwall
    Administrateur
    Porthview 9 The Lugger
    Portscatho
    TR2 5HE Truro
    Cornwall
    BritishFinancial Director1448320003
    RICHARDSON, Paul Winston George
    125 Park Avenue
    New York
    Ny 10017-5529
    Usa
    Administrateur
    125 Park Avenue
    New York
    Ny 10017-5529
    Usa
    BritishDirector45700660003
    SCOTT, Andrew Grant Balfour
    27 Farm Street
    W1J 5RJ London
    Administrateur
    27 Farm Street
    W1J 5RJ London
    United KingdomBritishLawyer67078370001
    SIMMONDS, Jane Helen
    9 Pleydell Avenue
    W6 0XX London
    Administrateur
    9 Pleydell Avenue
    W6 0XX London
    United KingdomBritishDirector78265430003
    SWEETLAND, Christopher Paul
    27 Farm Street
    W1J 5RJ London
    Administrateur
    27 Farm Street
    W1J 5RJ London
    EnglandBritishDirector56529540005
    THOMPSON, Christopher James
    19 Herrick Road
    Highbury
    N5 2JX London
    Administrateur
    19 Herrick Road
    Highbury
    N5 2JX London
    United KingdomBritishCompany Secretary29191340001
    WILLIAMS, Denise
    Marie Cottage
    Holmbury Lane
    RH5 6ND Holmbury St Mary
    Surrey
    Administrateur
    Marie Cottage
    Holmbury Lane
    RH5 6ND Holmbury St Mary
    Surrey
    BritishCompany Secretary24311940004
    WILSON, Stephen Michael
    9 Boulters Lock
    Giffard Park
    MK14 5QR Milton Keynes
    Administrateur
    9 Boulters Lock
    Giffard Park
    MK14 5QR Milton Keynes
    BritishCorporate Treasurer81144620001

    FITCH INTERNATIONAL LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 19 avr. 2002
    Livré le 26 avr. 2002
    En cours
    Montant garanti
    All monies obligations and liabilities due or to become due from the company to the finance parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Investment Bank PLC (And Its Successors in Title) for and on Behalf of Itself Thenoteholders and the Banks and Financial Institutions from Time to Time Parties to the Finance Documents
    Transactions
    • 26 avr. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 04 avr. 2002
    Livré le 12 avr. 2002
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Investment Bank PLC for and on Behalf of Itself and the Banks Andfinancial Institutions from Time to Time Parties to the Bridge Facility Agreement
    Transactions
    • 12 avr. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    Mortgage debenture
    Créé le 08 juil. 1999
    Livré le 23 juil. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under or in connection with the credit agreement or the notes (both as defined) and this mortgage debenture
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • First Union National Bank,as Agent and Trustee for the Banks (As Defined)
    Transactions
    • 23 juil. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 févr. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 29 juil. 1994
    Livré le 05 août 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Sir Terence Conran
    Transactions
    • 05 août 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 mars 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 19 oct. 1992
    Livré le 22 oct. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 22 oct. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 juil. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0