NPS (UK1) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéNPS (UK1) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02703539
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de NPS (UK1) LIMITED ?

    • Autres activités de services informatiques (62090) / Information et communication

    Où se situe NPS (UK1) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de NPS (UK1) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    NORTHGATE CSG LIMITED12 août 200312 août 2003
    HAYS REDFERN LIMITED05 janv. 200005 janv. 2000
    REDFERN CONSULTANCY LIMITED03 avr. 199203 avr. 1992

    Quels sont les derniers comptes de NPS (UK1) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 avr. 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour NPS (UK1) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    6 pagesLIQ13

    Changement d'adresse du siège social de Peoplebuilding 2 Peoplebuilding Estate Maylands Avenue Hemel Hempstead Herts HP2 4NW à 15 Canada Square London E14 5GL le 03 mai 2019

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 03 avr. 2019

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Comptes de micro-entité établis au 30 avr. 2018

    2 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 26 sept. 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Période comptable actuelle raccourcie du 30 avr. 2019 au 31 mars 2019

    1 pagesAA01

    Cessation de la nomination de Ian Michael Noble en tant que directeur le 06 août 2018

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Stephen James Callaghan le 06 août 2018

    2 pagesCH01

    Comptes de micro-entité établis au 30 avr. 2017

    3 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 26 sept. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 avr. 2016

    4 pagesAA

    Nomination de Ian Michael Noble en tant qu'administrateur le 06 déc. 2016

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Andrew Coll en tant que directeur le 06 déc. 2016

    1 pagesTM01

    Satisfaction de la charge 8 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 9 en totalité

    4 pagesMR04

    Nomination de Mr Stephen James Callaghan en tant qu'administrateur le 10 oct. 2016

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de David John Meaden en tant que directeur le 10 oct. 2016

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 26 sept. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 avr. 2015

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 26 sept. 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital26 oct. 2015

    État du capital au 26 oct. 2015

    • Capital: GBP 2,016,890
    SH01

    Certificat de changement de nom

    Company name changed northgate csg LIMITED\certificate issued on 16/06/15
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name16 juin 2015

    Changement de nom" par résolution

    NM01
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Comptes pour une société dormante établis au 30 avr. 2014

    4 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de NPS (UK1) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    United Kingdom
    Secrétaire
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement2318923
    76579530001
    CALLAGHAN, Stephen James
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector201347710052
    CLIFF, David Ross
    Highbury The Headlands
    North Woodchester
    GL5 5PS Stroud
    Gloucestershire
    Secrétaire
    Highbury The Headlands
    North Woodchester
    GL5 5PS Stroud
    Gloucestershire
    British16556040001
    FARRIMOND, Nicholas Brian
    51 The Avenue
    WD17 4NU Watford
    Hertfordshire
    Secrétaire
    51 The Avenue
    WD17 4NU Watford
    Hertfordshire
    British75357260001
    FRASER, Neil Geoffrey
    21 Long Acre East
    Bingham
    NG13 8BY Nottingham
    Nottinghamshire
    Secrétaire
    21 Long Acre East
    Bingham
    NG13 8BY Nottingham
    Nottinghamshire
    English92567520001
    JONES, Richard Mark Lea
    Leycester Cottage Middlewich Road
    Toft
    WA16 9PG Knutsford
    Cheshire
    Secrétaire
    Leycester Cottage Middlewich Road
    Toft
    WA16 9PG Knutsford
    Cheshire
    BritishAccountant41997740001
    LAYTON, Robert
    10 Cherry Hill
    Old
    NN6 9EN Northampton
    Northamptonshire
    Secrétaire
    10 Cherry Hill
    Old
    NN6 9EN Northampton
    Northamptonshire
    British75448020002
    NUNN, Carol Jayne
    Boundary Way
    HP2 7HU Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Secrétaire
    Boundary Way
    HP2 7HU Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    British101872040001
    RICHARDSON, John David
    High Street
    Burnham
    SL1 7JD Slough
    27
    Berks
    Secrétaire
    High Street
    Burnham
    SL1 7JD Slough
    27
    Berks
    British128558470001
    SCHENCK, Daniel William
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Usa181204960001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    AL-SALEH, Adel Bedry
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United StatesAmericanDirector165900220001
    CASSELLS, Leslie James Davidson
    Bridge Cottage
    6 Hodges Lane
    NN7 4AJ Kislingbury
    Northamptonshire
    Administrateur
    Bridge Cottage
    6 Hodges Lane
    NN7 4AJ Kislingbury
    Northamptonshire
    BritishCompany Director95347040001
    CHARLTON, Keith Pearson
    Thatched Barn
    Hanslope Road Castlethorpe
    MK19 7HD Milton Keynes
    Northamptonshire
    Administrateur
    Thatched Barn
    Hanslope Road Castlethorpe
    MK19 7HD Milton Keynes
    Northamptonshire
    BritishExecutive Director51102460003
    CLIFF, David Ross
    Highbury The Headlands
    North Woodchester
    GL5 5PS Stroud
    Gloucestershire
    Administrateur
    Highbury The Headlands
    North Woodchester
    GL5 5PS Stroud
    Gloucestershire
    BritishDirector16556040001
    CLIFF, Judith
    Highbury The Headlands
    North Woodchester
    GL5 5PS Stroud
    Gloucestershire
    Administrateur
    Highbury The Headlands
    North Woodchester
    GL5 5PS Stroud
    Gloucestershire
    BritishDirector (Proposed)25534180001
    COLL, Andrew
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishFinance Director237260100001
    GORDON-JONES, Andrew
    Wiltshire House Uffcott
    Broad Hinton
    SN4 9NB Swindon
    Wiltshire
    Administrateur
    Wiltshire House Uffcott
    Broad Hinton
    SN4 9NB Swindon
    Wiltshire
    BritishDirector16556050002
    GORDON-JONES, Melanie
    2 Summerdale
    Aldbourne
    SN8 2LG Marlborough
    Wiltshire
    Administrateur
    2 Summerdale
    Aldbourne
    SN8 2LG Marlborough
    Wiltshire
    BritishDirector (Proposed)25534170001
    HODGSON, John Gordon
    1 Stone Cottages
    The Street, Starston
    IP20 9NP Harleston
    Norfolk
    Administrateur
    1 Stone Cottages
    The Street, Starston
    IP20 9NP Harleston
    Norfolk
    BritishCompany Director65293600001
    JONES, Richard Mark Lea
    Leycester Cottage Middlewich Road
    Toft
    WA16 9PG Knutsford
    Cheshire
    Administrateur
    Leycester Cottage Middlewich Road
    Toft
    WA16 9PG Knutsford
    Cheshire
    United KingdomBritishAccountant41997740001
    MEADEN, David John
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishChief Executive193740420001
    MOTTRAM, Malcolm John
    West End Barn Church Road
    Egleton
    LE15 8AD Oakham
    Leicestershire
    Administrateur
    West End Barn Church Road
    Egleton
    LE15 8AD Oakham
    Leicestershire
    BritishManaging Director42370680002
    NOBLE, Ian Michael
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector199843940001
    ROUTLEDGE, Craig Wilson
    Beechwood House
    Bevere Green
    WR3 7RG Worcester
    Administrateur
    Beechwood House
    Bevere Green
    WR3 7RG Worcester
    United KingdomBritishCompany Director78239540001
    SADLER, Christopher John
    Corinium House
    Seven Leaze Lane, Edge
    GL6 6NJ Stroud
    Gloucestershire
    Administrateur
    Corinium House
    Seven Leaze Lane, Edge
    GL6 6NJ Stroud
    Gloucestershire
    BritishDirector68996830001
    SADLER, Ursula Katherine
    Highcroft Hollies Hill
    Nailsworth
    GL6 0AW Stroud
    Glos
    Administrateur
    Highcroft Hollies Hill
    Nailsworth
    GL6 0AW Stroud
    Glos
    BritishDirector (Proposed)25534190001
    SMITH, James Peter
    Keepers Cottage
    Radmore Green Haughton
    CW6 9RL Tarporley
    Cheshire
    Administrateur
    Keepers Cottage
    Radmore Green Haughton
    CW6 9RL Tarporley
    Cheshire
    EnglandBritishDirector49898310004
    SOWDEN, Michael Andrew
    Flat 3 Crete
    25 Ray Mill Road East
    SL6 8SW Maidenhead
    Berkshire
    Administrateur
    Flat 3 Crete
    25 Ray Mill Road East
    SL6 8SW Maidenhead
    Berkshire
    BritishIt Business Developments63144130002
    STIER, John Robert
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector78901530003
    STONE, Christopher Michael Renwick
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Administrateur
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    United KingdomBritishChief Executive66955690003
    WILSON, Philip William
    Paradise Farm
    Banbury Road
    NN11 6XY Lower Boddington
    Northamptonshire
    Administrateur
    Paradise Farm
    Banbury Road
    NN11 6XY Lower Boddington
    Northamptonshire
    BritishCompany Director69189630002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur NPS (UK1) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement00968498
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    NPS (UK1) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Security agreement
    Créé le 25 avr. 2005
    Livré le 10 mai 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (The Facility Agent)
    Transactions
    • 10 mai 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 déc. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Security agreement
    Créé le 22 janv. 2004
    Livré le 10 févr. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (The "Facility Agent") as Agent and Trustee for the Finance Parties
    Transactions
    • 10 févr. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 déc. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    Créé le 13 avr. 1999
    Livré le 17 avr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever whether arising under the agreement (as defined) or otherwise
    Brèves mentions
    All debts purchased or purported to be purchased by the chargee pursuant to an agreement for the purchase of debts between the chargee and the company (including the associated rights relating thereto) which fail to vest effectively or absolutely in the chargee for any reason.
    Personnes ayant droit
    • Griffin Credit Services Limited
    Transactions
    • 17 avr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 févr. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental debenture
    Créé le 31 mars 1999
    Livré le 13 avr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor (as defined therein) to the bank (as defined in the senior facility agreement of even date) and/or the chargee (the security agent); as agent and trustee for itself and each of the lenders (as defined therein) under the terms of the senior finance documents (as defined threrein) or any other document; and all monies due or to become due from each obligor (as defined therein) to the mezzanine lenders (as defined therein) (or any of them) under the terms of the mezzanine finance documents (as defined therein) or any other document
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC(The Security Agent)
    Transactions
    • 13 avr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 déc. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rent deposit deed
    Créé le 07 juil. 1997
    Livré le 08 juil. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £5,750 and interest due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    The deposit account and all sums standing to the credit thereof (£5,750).
    Personnes ayant droit
    • Charles Michael Baron Faringdon
    Transactions
    • 08 juil. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 oct. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Third supplemental debenture
    Créé le 30 mai 1997
    Livré le 04 juin 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor (as defined) to the bank and/or the security agent under any of the senior finance documents (as defined) or any other document and all other obligatios and liabilities of eash obligor to the mezzanine lenders under the mezzanine finance documents (as defined) or any other document
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank Plcas Security Agent
    Transactions
    • 04 juin 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 déc. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of accession
    Créé le 08 mai 1997
    Livré le 28 mai 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor (as defined therein) to the bank (as defined in the senior facility agreement of even date) and/or the chargee (the security agent) as agent and trustee for itself and each of the lenders (as defined therein) or any other document; and all monies due or to become due from each obligor (as defined therein) to the mezzanine lenders (as defined therein) (or any of them) under the terms of the mezzanine finance documents (as defined therein) or any other document
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 28 mai 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 déc. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 19 janv. 1995
    Livré le 31 janv. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 31 janv. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 déc. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rent deposit deed
    Créé le 09 déc. 1993
    Livré le 16 déc. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease dated 20TH august 1993 and this deed
    Brèves mentions
    £2,750.00 in cash standing to the credit of a bank deposit account in the name of the landlord.
    Personnes ayant droit
    • Ian Kennedy
    Transactions
    • 16 déc. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 oct. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    NPS (UK1) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    03 avr. 2019Commencement of winding up
    01 févr. 2020Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Mark Jeremy Orton
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    practitioner
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Nicholas James Timpson
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    practitioner
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0