BIOCOMPATIBLES INTERNATIONAL LIMITED

BIOCOMPATIBLES INTERNATIONAL LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBIOCOMPATIBLES INTERNATIONAL LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02703724
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BIOCOMPATIBLES INTERNATIONAL LIMITED ?

    • Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82990) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe BIOCOMPATIBLES INTERNATIONAL LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Chapman House
    Farnham Business Park
    GU9 8QL Farnham
    Surrey
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BIOCOMPATIBLES INTERNATIONAL LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BIOCOMPATIBLES INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY03 avr. 199203 avr. 1992

    Quels sont les derniers comptes de BIOCOMPATIBLES INTERNATIONAL LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2019

    Quels sont les derniers dépôts pour BIOCOMPATIBLES INTERNATIONAL LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Période comptable actuelle prolongée du 31 déc. 2019 au 30 sept. 2020

    1 pagesAA01

    Déclaration de confirmation établie le 03 avr. 2020 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Modification des détails de Btg Plc en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 29 août 2019

    2 pagesPSC05

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de 5 Fleet Place London EC4M 7rd United Kingdom à 100 New Bridge Street London EC4V 6JA

    1 pagesAD02

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré 100 New Bridge Street London EC4V 6JA

    1 pagesAD03

    Cessation de la nomination de Timothy John Martel en tant que directeur le 28 févr. 2020

    1 pagesTM01

    Nomination de Jonathan Richard Monson en tant qu'administrateur le 28 févr. 2020

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Elaine Maureen Johnston en tant que secrétaire le 28 févr. 2020

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Elaine Maureen Johnston en tant que directeur le 28 févr. 2020

    1 pagesTM01

    Nomination de Vance Ronald Brown en tant que secrétaire le 28 févr. 2020

    2 pagesAP03

    Nomination de Vance Ronald Brown en tant qu'administrateur le 28 févr. 2020

    2 pagesAP01

    Nomination de Abogado Nominees Limited en tant que secrétaire le 16 oct. 2019

    2 pagesAP04

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Company business 02/12/2019
    RES13
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10
    resolution

    Résolution de capitalisation ou d'émission d'actions gratuites

    Sum of £12250000 is capitalised 02/12/2019
    RES14

    État du capital après une attribution d'actions au 02 déc. 2019

    • Capital: GBP 21,106,623.92
    4 pagesSH01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2019

    19 pagesAA

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 02 déc. 2019

    • Capital: GBP 0.215638
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Période comptable actuelle raccourcie du 31 mars 2020 au 31 déc. 2019

    1 pagesAA01

    Cessation de la nomination de John Richard Sylvester en tant que directeur le 19 août 2019

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de BIOCOMPATIBLES INTERNATIONAL LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BROWN, Vance Ronald
    Boston Scientific Way
    Marlborough
    300
    Ma 01752
    United States
    Secrétaire
    Boston Scientific Way
    Marlborough
    300
    Ma 01752
    United States
    267650420001
    ABOGADO NOMINEES LIMITED
    New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    100
    United Kingdom
    Secrétaire
    New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    100
    United Kingdom
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement1688036
    73539350001
    BROWN, Vance Ronald
    Boston Scientific Way
    Marlborough
    300
    Ma 01752
    United States
    Administrateur
    Boston Scientific Way
    Marlborough
    300
    Ma 01752
    United States
    United StatesCanadian188829030001
    MONSON, Jonathan Richard
    Boston Scientific Way
    Marlborough
    300
    Ma 01752
    United States
    Administrateur
    Boston Scientific Way
    Marlborough
    300
    Ma 01752
    United States
    United StatesAmerican263413340001
    ARDILL, Ian Leslie
    21 Springfield
    GU18 5XP Lightwater
    Surrey
    Secrétaire
    21 Springfield
    GU18 5XP Lightwater
    Surrey
    Northern Irish87485640001
    BARDWELL, John Edward
    12 Beaufort Road
    SO23 9ST Winchester
    Hampshire
    Secrétaire
    12 Beaufort Road
    SO23 9ST Winchester
    Hampshire
    British14008990002
    EVANS, Fiona Maria
    164 Duke Road
    Chiswick
    W4 2DF London
    Secrétaire
    164 Duke Road
    Chiswick
    W4 2DF London
    British49259690004
    HUNT, Michael Elliott
    Little Bourne Lavander Lane
    Rowledge
    GU10 4AX Farnham
    Surrey
    Secrétaire
    Little Bourne Lavander Lane
    Rowledge
    GU10 4AX Farnham
    Surrey
    British64386630001
    JOHNSTON, Elaine Maureen
    Chapman House
    Farnham Business Park
    GU9 8QL Farnham
    Surrey
    Secrétaire
    Chapman House
    Farnham Business Park
    GU9 8QL Farnham
    Surrey
    254569490001
    JONES, Lygia Jane
    Chapman House
    Farnham Business Park
    GU9 8QL Farnham
    Surrey
    Secrétaire
    Chapman House
    Farnham Business Park
    GU9 8QL Farnham
    Surrey
    166927230001
    MCLEAN, Suzanne Victoria
    17 Elthiron Road
    SW6 4BN London
    Secrétaire
    17 Elthiron Road
    SW6 4BN London
    British39673610001
    MUSSENDEN, Paul Justin
    c/o Btg Plc
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    Secrétaire
    c/o Btg Plc
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    British157527420001
    STEADMAN, Julian Alex
    3 Hill Place
    SL2 3EW Farnham Common
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    3 Hill Place
    SL2 3EW Farnham Common
    Buckinghamshire
    British43224360003
    ARDILL, Ian Leslie
    21 Springfield
    GU18 5XP Lightwater
    Surrey
    Administrateur
    21 Springfield
    GU18 5XP Lightwater
    Surrey
    EnglandNorthern Irish87485640001
    BARDWELL, John Edward
    12 Beaufort Road
    SO23 9ST Winchester
    Hampshire
    Administrateur
    12 Beaufort Road
    SO23 9ST Winchester
    Hampshire
    British14008990002
    BONFIELD, William, Professor
    48 Harmer Green Lane
    AL6 0AT Welwyn
    Hertfordshire
    Administrateur
    48 Harmer Green Lane
    AL6 0AT Welwyn
    Hertfordshire
    EnglandBritish69066360001
    BROWN, Gerry
    10 Elsley Road
    Tilehurst
    RG31 6RN Reading
    Berkshire
    Administrateur
    10 Elsley Road
    Tilehurst
    RG31 6RN Reading
    Berkshire
    British109952650001
    CAHILL, Linda
    185 Ridge Road
    FOREIGN Lebanon
    New Jersey 08833
    Usa
    Administrateur
    185 Ridge Road
    FOREIGN Lebanon
    New Jersey 08833
    Usa
    American26982780001
    CHAPMAN, Dennis, Professor
    10 One Tree Lane
    HP9 2BU Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Administrateur
    10 One Tree Lane
    HP9 2BU Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British9340710002
    CHARLES, Stephen Alexander, Dr
    54 Ravencroft
    OX6 0YQ Bicester
    Oxon
    Administrateur
    54 Ravencroft
    OX6 0YQ Bicester
    Oxon
    British49912850002
    CLOHERTY, Patricia Mary
    155 Main Street
    Cold Springs
    Ny 10516
    Usa
    Administrateur
    155 Main Street
    Cold Springs
    Ny 10516
    Usa
    American47855820001
    CURNOCK COOK, Jeremy Lawrence
    King Street
    St James's
    SW1Y 6RJ London
    33
    Administrateur
    King Street
    St James's
    SW1Y 6RJ London
    33
    United KingdomBritish47197010003
    ENWRIGHT, Patrick
    1285 Avenue Of Americas
    New York Ny
    Usa
    Administrateur
    1285 Avenue Of Americas
    New York Ny
    Usa
    British34572210001
    FAIREY, Anne, Doctor
    6 Rasset Mead
    Church Crookham
    GU52 6DG Fleet
    Hampshire
    Administrateur
    6 Rasset Mead
    Church Crookham
    GU52 6DG Fleet
    Hampshire
    British86855160001
    GRANT, James Deneale
    860 Fifth Avenue
    USA New York
    Ny10021
    Administrateur
    860 Fifth Avenue
    USA New York
    Ny10021
    American38496640001
    HACKER, Ann Veronica
    Badgers Wood
    Beaver Lane
    GU46 6XJ Yateley
    Hampshire
    Administrateur
    Badgers Wood
    Beaver Lane
    GU46 6XJ Yateley
    Hampshire
    British66948800001
    HAMBRO, James Daryl
    15 Elm Park Road
    SW3 6BP London
    Administrateur
    15 Elm Park Road
    SW3 6BP London
    United KingdomBritish53684400001
    HANKINSON, David Roger Lindon
    The Brambles Loudwater Lane
    WD3 4HY Rickmansworth
    Hertfordshire
    Administrateur
    The Brambles Loudwater Lane
    WD3 4HY Rickmansworth
    Hertfordshire
    British34175410001
    HARGREAVES, Gordon
    Little Garth Woodlands Road West
    GU25 4PL Virginia Water
    Surrey
    Administrateur
    Little Garth Woodlands Road West
    GU25 4PL Virginia Water
    Surrey
    British34572200001
    HARRIS, Thomas George, Sir
    18 Telfords Yard
    6-8 The Highway
    E1W 2BQ London
    Administrateur
    18 Telfords Yard
    6-8 The Highway
    E1W 2BQ London
    United KingdomBritish103538280002
    JOHNSTON, Elaine Maureen
    Chapman House
    Farnham Business Park
    GU9 8QL Farnham
    Surrey
    Administrateur
    Chapman House
    Farnham Business Park
    GU9 8QL Farnham
    Surrey
    United KingdomIrish241923740002
    KAPASH, Richard Jules, Dr
    317 Woodards Ford Road
    Chesapeake
    Va 23322
    Usa
    Administrateur
    317 Woodards Ford Road
    Chesapeake
    Va 23322
    Usa
    American60509420002
    KEEN, Nigel John
    19 Pembroke Square
    W8 6PA London
    Administrateur
    19 Pembroke Square
    W8 6PA London
    EnglandBritish166130001
    MAKIN, Pamela Louise, Dame
    5 Fleet Place
    EC4M 7RD London
    Btg Plc
    Administrateur
    5 Fleet Place
    EC4M 7RD London
    Btg Plc
    EnglandBritish111491920002
    MARTEL, Timothy John
    Chapman House
    Farnham Business Park
    GU9 8QL Farnham
    Surrey
    Administrateur
    Chapman House
    Farnham Business Park
    GU9 8QL Farnham
    Surrey
    United KingdomBritish241967150001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur BIOCOMPATIBLES INTERNATIONAL LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    100
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    100
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleLaws Of England
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement02670500
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    BIOCOMPATIBLES INTERNATIONAL LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed supplemental to the instrument constituting $20,000,000 floating rate convertible bonds due 2007, dated 5 july 2001
    Créé le 20 sept. 2001
    Livré le 21 sept. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on $20,000,000 floating convertible bonds due 2007 issued by the company and constituted by the instrument dated 5 july 2001
    Brèves mentions
    10 ordinary shares of us$1 each in the share capital of biodivysio limited (the secured property) the company shall be entitled to exercise or direct the exercise of the voting and other rights attached to the secured property and shall be entitled to retain any dividend (as defined in the fourth schedule of the deed).
    Personnes ayant droit
    • Abbott Laboratories
    Transactions
    • 21 sept. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 mai 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Instrument constituting $20,000,000 floating rate convertible bonds due 2007 dated 5 july 2001
    Créé le 05 juil. 2001
    Livré le 19 juil. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The payment of principal and interest on $20,000,000 floating convertible bonds due 2007 issued by the company and constituted by the instrument of even date
    Brèves mentions
    48 ordinary shares of us$1 each in the share capital of biodivysio limited ("the secured property") in accordance with the fourth schedule of the instrument subject to what follows below the company shall be entitled to exercise or direct the exercise of the voting and other rights attached to the secured property and shall be entitled to retain any dividend (as defined in the fourth schedule) derived from the secured property. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Abbott Laboratories and Other Bondholders from Time to Time
    Transactions
    • 19 juil. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 mai 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge of deposit
    Créé le 09 mars 2000
    Livré le 14 mars 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All the company's liabilities to the chargee under a counter indemnity dated 9 march 2000 and entered into by the company in favour of the bank in connection with a guarantee dated 9 march 2000 issued by the bank to guarantee the obligations of the company under certain loans to be issued by the company pursuant to the terms of a loan note instrument dated 9 march 2000
    Brèves mentions
    All deposits now and in the future credited to account designation 21340874 with the bank and any deposit or account of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposits or account.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 14 mars 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 sept. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Instrument
    Créé le 24 oct. 1999
    Livré le 10 nov. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The payment of the principal and interest due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed
    Brèves mentions
    32 ordinary shares of us$1 each in share capital of biodivysio limited together with dividends and bonuses. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Bondholders from Time to Time
    Transactions
    • 10 nov. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 mai 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rent deposit deed
    Créé le 20 mai 1997
    Livré le 28 mai 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease dated 20TH may 1997 and/or this deed
    Brèves mentions
    The contents of the deposit fund held in the name of blake lapthorn solicitors at national westminster bank PLC or other reputable bank or building society of the chargee's choosing being £58,000 exclusive of vat.
    Personnes ayant droit
    • Store Property Investments Limited
    Transactions
    • 28 mai 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 sept. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Rent deposit deed
    Créé le 17 mars 1997
    Livré le 21 mars 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a lease dated 31ST january 1996
    Brèves mentions
    A rent deposit of £58,000.
    Personnes ayant droit
    • Juno Properties Limited
    Transactions
    • 21 mars 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 sept. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Assignment
    Créé le 06 déc. 1996
    Livré le 13 déc. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities of the company to the chargee under the facility letter and/or the assignment
    Brèves mentions
    All rights of the company in and to each of the assigned cash which meansall sums of money which may now or in future be deposited in the name of the company in designated account together with all interest thereon and the debts represented by such sums and interest. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Merrill Lynch International Bank Limited
    Transactions
    • 13 déc. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 sept. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Rent deposit deed
    Créé le 28 mai 1996
    Livré le 01 juin 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease dated 1ST december 1995 and/or this deed
    Brèves mentions
    The "deposit account" as defined in the rent deposit deed, namely:- an interest bearing account opened by the chargee's solicitors have placed the deposit sum being £85,140. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Store Property Investments Limited
    Transactions
    • 01 juin 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 sept. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Assignment
    Créé le 07 mai 1996
    Livré le 17 mai 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the facility letter and/or the assignment together being the "secured liabilities"
    Brèves mentions
    The assigned assets and the charged assets as defined in the continuation sheet attached to the form 395.
    Personnes ayant droit
    • Merrill Lynch International Bank Limited
    Transactions
    • 17 mai 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 juin 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0