HOLMWOODS GROUP LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHOLMWOODS GROUP LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02703817
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HOLMWOODS GROUP LIMITED ?

    • (7499) /

    Où se situe HOLMWOODS GROUP LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de HOLMWOODS GROUP LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour HOLMWOODS GROUP LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Résolution d'insolvabilité

    Resolution insolvency:miscellaneous res re books
    1 pagesLIQ MISC RES

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    3 pages4.71

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée

    2 pagesAD02

    Changement d'adresse du siège social de 8 Canada Square London E14 5HQ le 13 janv. 2011

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    2 pages600

    Déclaration de solvabilité

    6 pages4.70

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 31 déc. 2010

    LRESSP

    Comptes modifiés pour une société dormante jusqu'au 31 déc. 2008

    6 pagesAAMD

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    6 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Graham Alan Faux le 02 juin 2010

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mars 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital26 avr. 2010

    État du capital au 26 avr. 2010

    • Capital: GBP 13,251,200.25
    • Capital: USD 3,333.333
    SH01

    Cessation de la nomination de Christopher Galyer en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Douglas Angus Clow en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Modification des coordonnées du secrétaire Kate Elizabeth Hudson le 13 nov. 2009

    1 pagesCH03

    Nomination de Kate Elizabeth Hudson en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2008

    6 pagesAA

    Cessation de la nomination de Pauline Mcquillan en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    3 pages363a

    Comptes établis au 31 déc. 2007

    6 pagesAA

    legacy

    1 pages288a

    Qui sont les dirigeants de HOLMWOODS GROUP LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HUDSON, Kate Elizabeth
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Secrétaire
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    146795550002
    CLOW, Douglas Angus
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Administrateur
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant68350950003
    FAUX, Graham Alan
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Administrateur
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Accountant125907390001
    HARVEY, Peter James
    82 Frankfurt Road
    SE24 9NY London
    Secrétaire
    82 Frankfurt Road
    SE24 9NY London
    OtherCompany Secretary67026460002
    JENKINSON, Louisa Jane
    80 Mysore Road
    Battersea
    SW11 5SA London
    Secrétaire
    80 Mysore Road
    Battersea
    SW11 5SA London
    British61994950001
    LEDSAM, Charles Edmund Royden
    75 Ware Road
    SG13 7ED Hertford
    Hertfordshire
    Secrétaire
    75 Ware Road
    SG13 7ED Hertford
    Hertfordshire
    BritishCompany Secretary8453110001
    MAKEPEACE, Clive Arnold
    31 Ellis Way
    TN22 2BT Uckfield
    East Sussex
    Secrétaire
    31 Ellis Way
    TN22 2BT Uckfield
    East Sussex
    British18579250002
    MCQUILLAN, Pauline Louise
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Secrétaire
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Other134030790001
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Secrétaire désigné
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    BURR, Christopher James
    Rose Cottage
    Shop Lane, East Mersea
    CO5 8TR Colchester
    Essex
    Administrateur
    Rose Cottage
    Shop Lane, East Mersea
    CO5 8TR Colchester
    Essex
    EnglandBritishAccountant51653350007
    DAVISON, Guy Bryce
    128 Kensington Park Road
    W1 2EP London
    Administrateur
    128 Kensington Park Road
    W1 2EP London
    BritishInvestment Manager48717030002
    DIXON, Andrew Michael Morley
    Southward
    2 Upper Rose Hill
    RH4 2EB Dorking
    Surrey
    Administrateur
    Southward
    2 Upper Rose Hill
    RH4 2EB Dorking
    Surrey
    Gb-EngBritishCeo Hsbc Insurance Brokers Ltd37045200003
    GALYER, Christopher Jonathan
    73 Elm Grove Road
    Barnes
    SW13 0BX London
    Administrateur
    73 Elm Grove Road
    Barnes
    SW13 0BX London
    BritishLawyer82234440001
    GODFRAY, David John Lerrier
    The Chantry
    Chantry Lane, Storrington
    RH20 4AB Pulborough
    West Sussex
    Administrateur
    The Chantry
    Chantry Lane, Storrington
    RH20 4AB Pulborough
    West Sussex
    BritishInsurance Broker35934270002
    INGLEBY-MACKENZIE, Alexander Colin David
    2 Grove End Road
    St Johns Wood
    NW8 9LB London
    Administrateur
    2 Grove End Road
    St Johns Wood
    NW8 9LB London
    BritishCompany Director35934260001
    IRBY III, Alton Fernando
    5 Cottesmore Gardens
    W8 5PR London
    Administrateur
    5 Cottesmore Gardens
    W8 5PR London
    AmericanInvestment Banker72828910001
    ONEILL, Derham Charles
    Royex House
    Aldermanbury Square
    EC2V 7LD London
    Administrateur
    Royex House
    Aldermanbury Square
    EC2V 7LD London
    BritishSolicitor57161700002
    OPENSHAW, Carl Frederick
    2 Calverley Park
    TN1 2SH Tunbridge Wells
    Kent
    Administrateur
    2 Calverley Park
    TN1 2SH Tunbridge Wells
    Kent
    BritishCompany Director11327690002
    PUTTERGILL, Graham Fraser
    The Redwood
    Long Grove, Seer Green
    HP9 2QH Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Administrateur
    The Redwood
    Long Grove, Seer Green
    HP9 2QH Beaconsfield
    Buckinghamshire
    EnglandBritishLloyds Broker71012700001
    RANGER, Carol Ann
    2 Elmscroft Gardens
    EN6 2JR Potters Bar
    Hertfordshire
    Administrateur
    2 Elmscroft Gardens
    EN6 2JR Potters Bar
    Hertfordshire
    BritishCompany Director24966030002
    STOCKFLETH, Carl Alfred
    185 Enterprise Street
    Duxbury
    Massachusetts Ma 02332
    Usa
    Administrateur
    185 Enterprise Street
    Duxbury
    Massachusetts Ma 02332
    Usa
    AmericanInsurance29904100001
    WILLIAMS, Anthony Neville
    Royex House Aldermanbury Square
    EC2V 7HR London
    Administrateur
    Royex House Aldermanbury Square
    EC2V 7HR London
    BritishSolicitor71522900001

    HOLMWOODS GROUP LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Rent deposit deed
    Créé le 16 nov. 1992
    Livré le 26 nov. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £138,039 due from the company to the chargee under the terms of the lease
    Brèves mentions
    Rent deposit sum of £138,039.
    Personnes ayant droit
    • Nomura International PLC
    Transactions
    • 26 nov. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 sept. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture
    Créé le 16 juil. 1992
    Livré le 24 juil. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from thecompany and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the facilities agreement dated 23RD may 1992 and other documents (as defined)
    Brèves mentions
    See form 395 ref M141. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Bsas Security Trustee for the Banks
    Transactions
    • 24 juil. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 oct. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of assignment of life policies
    Créé le 16 juil. 1992
    Livré le 24 juil. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due from the company or any other group company (as defined in the deed) to the chargee as trustee for the banks, the revolvingloan bank, the capital bank and the swap counterparties (each as defined) under the terms of the facilities agreement dated 23/05/92 or otherwise as stated in the deed
    Brèves mentions
    All the company's right title and interest in and to the policies and all monies including bonuses payable thereunder and the benefit of all powers and remedies for enforcing the same (for full details see form 395 tc ref: M1).
    Personnes ayant droit
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotlandas Trustee for the Banks, the Revolving Loan Banks, the Capital Bank and the Swap Counterparties (Each as Defined)
    Transactions
    • 24 juil. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 août 1992Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 13 août 1992Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 08 oct. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    HOLMWOODS GROUP LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    11 août 2011Dissolved on
    31 déc. 2010Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Nicholas Guy Edwards
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    practitioner
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Christopher Richard Frederick Day
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    practitioner
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0