MAIDEN HOLDINGS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMAIDEN HOLDINGS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02704072
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MAIDEN HOLDINGS LIMITED ?

    • (7415) /

    Où se situe MAIDEN HOLDINGS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    The Zenith Building
    26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MAIDEN HOLDINGS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    THE MAIDEN GROUP LIMITED06 mai 199306 mai 1993
    MATAHARI 451 LIMITED06 avr. 199206 avr. 1992

    Quels sont les derniers comptes de MAIDEN HOLDINGS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2007

    Quels sont les derniers dépôts pour MAIDEN HOLDINGS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    12 pages4.72

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 21 mars 2013

    15 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 21 mars 2012

    14 pages4.68

    Déclaration des affaires avec le formulaire 4.19 attaché

    5 pages4.20

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation au 22 mars 2011

    LRESEX

    Changement d'adresse du siège social de 186 City Road London EC1V 2NT le 30 mars 2011

    1 pagesAD01

    La procédure de radiation d'office a été suspendue

    1 pagesDISS16(SOAS)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 juin 2009

    6 pagesAR01

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2007

    14 pagesAA

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    legacy

    7 pages363a

    legacy

    1 pages288c

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2006

    12 pagesAA

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages288a

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2005

    14 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    2 pages288a

    Qui sont les dirigeants de MAIDEN HOLDINGS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    JOHNSTON, Matthew Ian
    2 Boxgate
    TN6 1SF Crowborough
    East Sussex
    Secrétaire
    2 Boxgate
    TN6 1SF Crowborough
    East Sussex
    British122298900001
    ALLMAN, Donald Russell
    55 Arrowhead Way
    Darien
    Connecticut 06820
    Usa
    Administrateur
    55 Arrowhead Way
    Darien
    Connecticut 06820
    Usa
    Usa113088010001
    APFELBAUM, William Michael
    143 Byram Shore Road
    Greenwich
    Connecticut 06830
    Usa
    Administrateur
    143 Byram Shore Road
    Greenwich
    Connecticut 06830
    Usa
    American113086280001
    GOLDSMITH, Scott
    200 East 71st Street
    New York
    Ny 10021
    Usa
    Administrateur
    200 East 71st Street
    New York
    Ny 10021
    Usa
    American111559610001
    JOHNSTON, Matthew Ian
    2 Boxgate
    TN6 1SF Crowborough
    East Sussex
    Administrateur
    2 Boxgate
    TN6 1SF Crowborough
    East Sussex
    EnglandBritish122298900001
    MOUG, Andrew John
    Wintons
    Tanhouse Lane Peasmarsh
    TN31 6UX Rye
    East Sussex
    Administrateur
    Wintons
    Tanhouse Lane Peasmarsh
    TN31 6UX Rye
    East Sussex
    EnglandBritish85481770002
    SLATKIN, Jonathan Aaron
    Stanhope Gardens
    NW7 2JD London
    26
    Administrateur
    Stanhope Gardens
    NW7 2JD London
    26
    American117628600002
    SAVAGE, Timothy John
    Squirrels Wood
    Clock House Lane, Bramley
    GU5 0AP Guildford
    Surrey
    Secrétaire
    Squirrels Wood
    Clock House Lane, Bramley
    GU5 0AP Guildford
    Surrey
    British8871460006
    TKB REGISTRARS LIMITED
    50 Stratton Street
    W1X 6NX London
    Secrétaire désigné
    50 Stratton Street
    W1X 6NX London
    900002650001
    BOASE, Martin
    27 St Leonards Terrace
    SW3 4QG London
    Administrateur
    27 St Leonards Terrace
    SW3 4QG London
    United KingdomBritish1460150003
    BOYLE, Tobias Humphrey James
    67 Carlton Hill
    NW8 0EN London
    Administrateur
    67 Carlton Hill
    NW8 0EN London
    EnglandBritish141831310001
    DRON, David John Anthony
    Somerville 5 Adelaide Road
    KT12 1NB Walton On Thames
    Surrey
    Administrateur
    Somerville 5 Adelaide Road
    KT12 1NB Walton On Thames
    Surrey
    British1730460002
    GOODWIN, Francis Dominic
    The Mansion House
    1 Purley Magna
    RG8 8EL Purley On Thames
    Berkshire
    Administrateur
    The Mansion House
    1 Purley Magna
    RG8 8EL Purley On Thames
    Berkshire
    United KingdomUnited Kingdom127055040001
    POWELL, Ian
    The Weir House
    7 Preston Crowmarsh
    OX10 6SL Benson
    Oxfordshire
    Administrateur
    The Weir House
    7 Preston Crowmarsh
    OX10 6SL Benson
    Oxfordshire
    EnglandBritish33706140001
    PUGH, David John
    12 Vineyard Hill Road
    SW19 7JH London
    Administrateur
    12 Vineyard Hill Road
    SW19 7JH London
    British70814670001
    REAY, Alison
    Flat 2
    1 Parkhill Road
    NW3 2YJ London
    Administrateur
    Flat 2
    1 Parkhill Road
    NW3 2YJ London
    EnglandBritish113085780001
    ROPER, Mervyn Edward Patrick
    19 Criffel Avenue
    SW2 4AY London
    Administrateur désigné
    19 Criffel Avenue
    SW2 4AY London
    British900002640001
    SWAINSON, John Frederick
    15 Chaldon Way
    CR5 1DG Coulsdon
    Surrey
    Administrateur
    15 Chaldon Way
    CR5 1DG Coulsdon
    Surrey
    British114617510001
    ZEGHIBE, Ronald William
    19 Cheyne Walk
    SW3 5RA London
    Administrateur
    19 Cheyne Walk
    SW3 5RA London
    United KingdomAmerican51349440001

    MAIDEN HOLDINGS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Security agreement
    Créé le 15 août 2006
    Livré le 31 août 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • General Electric Capital Corporation
    Transactions
    • 31 août 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Mortgage over shares
    Créé le 15 août 2006
    Livré le 31 août 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from titan outdoor ireland limited and titan outdoor advertising limited to the chargee and the lenders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All rights in and to the original shares any further shares and any related assets including dividends,. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • General Electric Capital Corporation
    Transactions
    • 31 août 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Security agreement
    Créé le 22 déc. 2004
    Livré le 07 janv. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Land, investments, plant and machinery, credit balances, book debts, insurances, intellectual property and miscellaneous. Floating charge all its assets.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for the Finance Parties (The "Security Trustee")
    Transactions
    • 07 janv. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 juin 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Security agreement
    Créé le 19 juil. 2002
    Livré le 05 août 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from maiden group PLC to any transaction party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC(The Security Trustee)
    Transactions
    • 05 août 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 22 juin 1995
    Livré le 29 juin 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the "finance documents" (as defined in the debenture)
    Brèves mentions
    L/H property k/a 14 half moon street (ngl 459043), l/h property k/a fifth floor churchill house titheborn street liverpool MS1087453. L/h property k/a suite 15 floor c josephs well westgate leeds. L/h property k/a part first floor 371/375 kennington lane london SE11. L/h property k/a part second floor, 371/375 kennington lane london SE11. L/h property k/a unit 2 22/24 glanville street birmingham.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Morgan Grenfell & Co Limitedthe "Security Agent"
    Transactions
    • 29 juin 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 juin 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 07 avr. 1995
    Livré le 25 avr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee under each or any of the finance documents or any other document
    Brèves mentions
    See schedule attached to form M395 for details of all the properties. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Morgan Grenfell & Co. Limited(The "Security Agent") as Agent and Trustee Foritself and Each of the Lenders (as Defined)
    Transactions
    • 25 avr. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 juil. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignment of key-man policies
    Créé le 21 juil. 1993
    Livré le 29 juil. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All and each of the key-man life assurance policies set out on the reverse of the form 395 and all moneys thereby assured which may become payable thereunder and the full benefit thereof and all rights, title and interest therin (for full details see form 395).
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC as Security Trustee
    Transactions
    • 29 juil. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 avr. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 08 avr. 1993
    Livré le 22 avr. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of or in connection with each of the financing documents (all as defined)
    Brèves mentions
    (For full details see form 395 and contd sheets). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC (In Its Capacity as Security Trustee) and the Banks
    Transactions
    • 22 avr. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 avr. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    MAIDEN HOLDINGS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    20 déc. 2013Dissolved on
    22 mars 2011Commencement of winding up
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Stuart Charles Edward Mackellar
    Toronto Square Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    practitioner
    Toronto Square Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    Simon Jonathan Appell
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    practitioner
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0