CICM (SERVICES) LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | CICM (SERVICES) LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 02707375 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe CICM (SERVICES) LIMITED ?
| Adresse du siège social | 1 Accent Park Orton Southgate PE2 6XS Peterborough England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de CICM (SERVICES) LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2025 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour CICM (SERVICES) LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 12 avr. 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 26 avr. 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 12 avr. 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour CICM (SERVICES) LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Déclaration de confirmation établie le 12 avr. 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2024 | 10 pages | AA | ||
Nomination de Mr Andrew Allan Simon Poole en tant qu'administrateur le 10 sept. 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Debra Tara Nolan en tant que directeur le 10 sept. 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2023 | 10 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 12 avr. 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Nomination de Mr Neil Richard Jinks en tant qu'administrateur le 29 janv. 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Phil Colin Rice en tant que directeur le 31 déc. 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 12 avr. 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2022 | 10 pages | AA | ||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2021 | 10 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 12 avr. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Changement d'adresse du siège social de The Water Mill Station Road, South Luffenham, Oakham, Leics. LE15 8NB à 1 Accent Park Orton Southgate Peterborough PE2 6XS le 06 avr. 2022 | 1 pages | AD01 | ||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2020 | 11 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 12 avr. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Nomination de Mr Phil Colin Rice en tant qu'administrateur le 08 sept. 2020 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Peter James Whitmore en tant que directeur le 08 sept. 2020 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 12 avr. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2019 | 9 pages | AA | ||
Nomination de Ms Sue Carol Chapple en tant qu'administrateur le 04 févr. 2020 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Philip John King en tant que directeur le 04 févr. 2020 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2018 | 9 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 12 avr. 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Nomination de Miss Debra Tara Nolan en tant qu'administrateur le 04 sept. 2018 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Laurence Frederick Beagle en tant que directeur le 04 sept. 2018 | 1 pages | TM01 | ||
Qui sont les dirigeants de CICM (SERVICES) LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAPPLE, Sue Carol | Administrateur | Accent Park Orton Southgate PE2 6XS Peterborough 1 England | England | British | 267214890001 | |||||
| JINKS, Neil Richard | Administrateur | Accent Park Orton Southgate PE2 6XS Peterborough 1 England | England | British | 256504450001 | |||||
| POOLE, Andrew Allan Simon | Administrateur | Accent Park Orton Southgate PE2 6XS Peterborough 1 England | United Kingdom | British | 166309610002 | |||||
| BEARNE, Peter William | Secrétaire | 9 Main Road Collyweston PE9 3PF Stamford Lincolnshire | British | 34389280001 | ||||||
| GOLDRING, Simon | Secrétaire | 201 Bredhurst Road Wigmore ME8 0QX Gillingham Kent | British | 45342150001 | ||||||
| HAYNES, Victoria Louise | Secrétaire | Main St Southorpe PE9 3BX Stamford Holly Tree House Lincolnshire Great Britain | 171850360001 | |||||||
| WARD, Glyn | Secrétaire | 3 St Marys Road Stilton PE7 3RX Peterborough | British | 62550110001 | ||||||
| ALLEN, Robert Peter | Administrateur | 31 Langley Way WD1 3EH Watford Hertfordshire | British | 12694490001 | ||||||
| ANCLIFFE, David | Administrateur | 1 Moubray Road Dalgety Bay KY11 9JP Dunfermline Fife | United Kingdom | British | 70098630001 | |||||
| BEAGLE, Laurence Frederick | Administrateur | The Water Mill Station Road, South Luffenham, LE15 8NB Oakham, Leics. | United Kingdom | British | 171838700001 | |||||
| BEARNE, Peter William | Administrateur | 9 Main Road Collyweston PE9 3PF Stamford Lincolnshire | British | 34389280001 | ||||||
| BROWN, Edward James | Administrateur | 10 Goodwood Rise SL7 3QE Marlow Buckinghamshire | British | 69779490001 | ||||||
| BROWN, John | Administrateur | 40 Southwark Close SG1 4PG Stevenage Hertfordshire | British | 47879570001 | ||||||
| BULLIVANT, Glen Stewart | Administrateur | Victoria Road BD21 1JF Keighley 85 West Yorkshire Great Britain | Great Britain | British | 12694550003 | |||||
| BULLIVANT, Glen Stewart | Administrateur | Dobella Cottage Station Road Rawcliffe DN14 8QT Goole North Humberside | British | 12694550001 | ||||||
| COLTMAN, Larry | Administrateur | The Water Mill Station Road, South Luffenham, LE15 8NB Oakham, Leics. | United Kingdom | British | 96889820001 | |||||
| HINGSTON, Colin Eric | Administrateur | 65 Dean Garden Rise HP11 1RF High Wycombe Buckinghamshire | United Kingdom | British | 12694630001 | |||||
| HOPEWELL, Stuart | Administrateur | 18 Ashtons Lane SG7 6JJ Baldock Hertfordshire | England | British | 64970230001 | |||||
| KING, Philip John | Administrateur | The Water Mill Station Road, South Luffenham, LE15 8NB Oakham, Leics. | England | British | 53605190001 | |||||
| LINGER, Brenda Joan | Administrateur | 10 Bacon Lane PO11 0DN Hayling Island Hampshire | United Kingdom | British | 69083780001 | |||||
| NOLAN, Debra Tara | Administrateur | Accent Park Orton Southgate PE2 6XS Peterborough 1 England | England | British | 250228420001 | |||||
| PETTIFOR, Bryony Dawn | Administrateur | The Water Mill Station Road, South Luffenham, LE15 8NB Oakham, Leics. | England | British | 171850160001 | |||||
| PHILLIPS, Trevor Wade | Administrateur | Brittany Cottage Beacon Road TN6 1UG Crowborough | British | 12694740001 | ||||||
| RICE, Phil Colin | Administrateur | Accent Park Orton Southgate PE2 6XS Peterborough 1 England | England | British | 274049480001 | |||||
| ROBERTSON, Charles | Administrateur | 13 First Avenue Millerston G33 6JW Glasgow | Scotland | British | 36735390001 | |||||
| ROWE, Peter Anthony | Administrateur | The Barn House Church Street Nassington PE8 6QG Peterborough Cambridgeshire | British | 30670780001 | ||||||
| SANDBROOK, Claire Louise | Administrateur | The Water Mill Station Road, South Luffenham, LE15 8NB Oakham, Leics. | United Kingdom | British | 154342350001 | |||||
| WHITMORE, Peter James | Administrateur | The Water Mill Station Road, South Luffenham, LE15 8NB Oakham, Leics. | England | British | 199294710001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CICM (SERVICES) LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chartered Institute Of Credit Management | 06 avr. 2016 | Station Road South Luffenham LE15 8NB Oakham The Watermill England | Non | ||||
| |||||||
Nature du contrôle
| |||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0