RESPONSE COMPANY LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéRESPONSE COMPANY LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02711414
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de RESPONSE COMPANY LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe RESPONSE COMPANY LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Secure House
    Moorside Road
    S023 7RX Winchester
    Hampshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de RESPONSE COMPANY LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    POLYMETERS LIMITED05 juin 199205 juin 1992
    AREALEVEL LIMITED01 mai 199201 mai 1992

    Quels sont les derniers comptes de RESPONSE COMPANY LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2012

    Quels sont les derniers dépôts pour RESPONSE COMPANY LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2012

    3 pagesAA

    legacy

    3 pagesMG02

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 mai 2012

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital04 mai 2012

    État du capital au 04 mai 2012

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2011

    3 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Sanjaya Singhal le 20 sept. 2011

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 mai 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Peter Wilman le 16 août 2010

    2 pagesCH03

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2010

    3 pagesAA

    legacy

    5 pagesMG01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Kaushik Ghosh le 26 sept. 2010

    2 pagesCH01

    Changement d'adresse du siège social de P R I House Moorside Road Winchester Hampshire SO23 7RX le 29 juin 2010

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 mai 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2009

    9 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2008

    8 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Comptes établis au 31 mars 2007

    7 pagesAA

    legacy

    7 pages363s

    Certificat de changement de nom

    Company name changed polymeters LIMITED\certificate issued on 06/06/07
    2 pagesCERTNM

    legacy

    1 pages288b

    Qui sont les dirigeants de RESPONSE COMPANY LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WILMAN, Peter
    Heath Road
    KT138TS Weybridge
    The Old Post House
    Surrey
    United Kingdom
    Secrétaire
    Heath Road
    KT138TS Weybridge
    The Old Post House
    Surrey
    United Kingdom
    British6728520001
    GHOSH, Kaushik
    Oakfields
    Allbrook
    SO504RP Eastleigh
    10
    Hampshire
    England
    Administrateur
    Oakfields
    Allbrook
    SO504RP Eastleigh
    10
    Hampshire
    England
    EnglandIndian138818080002
    SINGHAL, Sanjaya
    Moorside Road
    S0237RX Winchester
    Secure House
    Hampshire
    Administrateur
    Moorside Road
    S0237RX Winchester
    Secure House
    Hampshire
    IndiaIndian51868310007
    DICK, Michael John
    76 Heath Road
    GU31 4EJ Petersfield
    Heath House
    Hampshire
    Secrétaire
    76 Heath Road
    GU31 4EJ Petersfield
    Heath House
    Hampshire
    British30542990002
    PIERCE, Philippa Elinor
    5 Monnow Gardens
    West End
    SO3 3QD Southampton
    Secrétaire
    5 Monnow Gardens
    West End
    SO3 3QD Southampton
    British36862820001
    STREATFIELD, Paul Richard
    45 Castle Lane
    Chandlers Ford
    SO53 4AH Eastleigh
    Hampshire
    Secrétaire
    45 Castle Lane
    Chandlers Ford
    SO53 4AH Eastleigh
    Hampshire
    British49339260001
    TUTTON, Richard John
    8 Withingham Road
    BH13 6BU Poole
    Dorset
    Secrétaire
    8 Withingham Road
    BH13 6BU Poole
    Dorset
    British50685530004
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BABEL, Bhagwat Singh
    12 Peninsula Square
    SO23 8GJ Winchester
    Hampshire
    Administrateur
    12 Peninsula Square
    SO23 8GJ Winchester
    Hampshire
    United KingdomBritish70303880005
    DICK, Michael John
    76 Heath Road
    GU31 4EJ Petersfield
    Heath House
    Hampshire
    Administrateur
    76 Heath Road
    GU31 4EJ Petersfield
    Heath House
    Hampshire
    United KingdomBritish30542990002
    FIELDEN, John Spensley
    Downalong
    Higher Metcombe
    EX11 1SL Ottery St. Mary
    Administrateur
    Downalong
    Higher Metcombe
    EX11 1SL Ottery St. Mary
    British5159620002
    PEDDIE, Robert Alan
    24 Quarry Road
    SO23 0JG Winchester
    Hampshire
    Administrateur
    24 Quarry Road
    SO23 0JG Winchester
    Hampshire
    British36719300002
    ST CLAIR, Richard John
    Millstone
    40 Shortheath Crest
    GU9 8SB Farnham
    Surrey
    Administrateur
    Millstone
    40 Shortheath Crest
    GU9 8SB Farnham
    Surrey
    United KingdomBritish53455290005
    STREATFIELD, Paul Richard
    45 Castle Lane
    Chandlers Ford
    SO53 4AH Eastleigh
    Hampshire
    Administrateur
    45 Castle Lane
    Chandlers Ford
    SO53 4AH Eastleigh
    Hampshire
    British49339260001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur désigné
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    RESPONSE COMPANY LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 09 déc. 2010
    Livré le 10 déc. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 10 déc. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 25 mai 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 05 déc. 2003
    Livré le 09 déc. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 09 déc. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 mars 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 07 mars 1997
    Livré le 25 mars 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 25 mars 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 mars 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 12 sept. 1994
    Livré le 27 sept. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 27 sept. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 juin 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0