RESPONSE COMPANY LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | RESPONSE COMPANY LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 02711414 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe RESPONSE COMPANY LIMITED ?
| Adresse du siège social | Secure House Moorside Road S023 7RX Winchester Hampshire |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de RESPONSE COMPANY LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2012 |
Quels sont les derniers dépôts pour RESPONSE COMPANY LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2012 | 3 pages | AA | ||||||||||
legacy | 3 pages | MG02 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 mai 2012 | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2011 | 3 pages | AA | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Sanjaya Singhal le 20 sept. 2011 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 mai 2011 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Mr Peter Wilman le 16 août 2010 | 2 pages | CH03 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2010 | 3 pages | AA | ||||||||||
legacy | 5 pages | MG01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Kaushik Ghosh le 26 sept. 2010 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de P R I House Moorside Road Winchester Hampshire SO23 7RX le 29 juin 2010 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 mai 2010 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2009 | 9 pages | AA | ||||||||||
legacy | 3 pages | 363a | ||||||||||
legacy | 2 pages | 288a | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288b | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2008 | 8 pages | AA | ||||||||||
legacy | 3 pages | 363a | ||||||||||
Comptes établis au 31 mars 2007 | 7 pages | AA | ||||||||||
legacy | 7 pages | 363s | ||||||||||
Certificat de changement de nom Company name changed polymeters LIMITED\certificate issued on 06/06/07 | 2 pages | CERTNM | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288b | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de RESPONSE COMPANY LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILMAN, Peter | Secrétaire | Heath Road KT138TS Weybridge The Old Post House Surrey United Kingdom | British | 6728520001 | ||||||
| GHOSH, Kaushik | Administrateur | Oakfields Allbrook SO504RP Eastleigh 10 Hampshire England | England | Indian | 138818080002 | |||||
| SINGHAL, Sanjaya | Administrateur | Moorside Road S0237RX Winchester Secure House Hampshire | India | Indian | 51868310007 | |||||
| DICK, Michael John | Secrétaire | 76 Heath Road GU31 4EJ Petersfield Heath House Hampshire | British | 30542990002 | ||||||
| PIERCE, Philippa Elinor | Secrétaire | 5 Monnow Gardens West End SO3 3QD Southampton | British | 36862820001 | ||||||
| STREATFIELD, Paul Richard | Secrétaire | 45 Castle Lane Chandlers Ford SO53 4AH Eastleigh Hampshire | British | 49339260001 | ||||||
| TUTTON, Richard John | Secrétaire | 8 Withingham Road BH13 6BU Poole Dorset | British | 50685530004 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secrétaire désigné | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| BABEL, Bhagwat Singh | Administrateur | 12 Peninsula Square SO23 8GJ Winchester Hampshire | United Kingdom | British | 70303880005 | |||||
| DICK, Michael John | Administrateur | 76 Heath Road GU31 4EJ Petersfield Heath House Hampshire | United Kingdom | British | 30542990002 | |||||
| FIELDEN, John Spensley | Administrateur | Downalong Higher Metcombe EX11 1SL Ottery St. Mary | British | 5159620002 | ||||||
| PEDDIE, Robert Alan | Administrateur | 24 Quarry Road SO23 0JG Winchester Hampshire | British | 36719300002 | ||||||
| ST CLAIR, Richard John | Administrateur | Millstone 40 Shortheath Crest GU9 8SB Farnham Surrey | United Kingdom | British | 53455290005 | |||||
| STREATFIELD, Paul Richard | Administrateur | 45 Castle Lane Chandlers Ford SO53 4AH Eastleigh Hampshire | British | 49339260001 | ||||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Administrateur désigné | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
RESPONSE COMPANY LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Créé le 09 déc. 2010 Livré le 10 déc. 2010 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 05 déc. 2003 Livré le 09 déc. 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Fixed and floating charge | Créé le 07 mars 1997 Livré le 25 mars 1997 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Guarantee & debenture | Créé le 12 sept. 1994 Livré le 27 sept. 1994 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0