CGX REALISATIONS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCGX REALISATIONS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02714095
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CGX REALISATIONS LIMITED ?

    • Autres industries manufacturières n.d.a. (32990) / Industries manufacturières

    Où se situe CGX REALISATIONS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o GRANT THORNTON UK LLP
    4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CGX REALISATIONS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CHROMOGENEX TECHNOLOGIES LIMITED15 août 200515 août 2005
    EUPHOTONICS LIMITED16 avr. 200316 avr. 2003
    PHOTONICS LIMITED25 févr. 200325 févr. 2003
    ICN PHOTONICS LIMITED13 sept. 200013 sept. 2000
    SLS BIOPHILE LIMITED17 févr. 199917 févr. 1999
    SLS TECHNOLOGIES LIMITED14 janv. 199914 janv. 1999
    SLS BIOPHILE LIMITED21 août 199621 août 1996
    SLS (WALES) LIMITED24 nov. 199224 nov. 1992
    NOTICEGRAND LIMITED13 mai 199213 mai 1992

    Quels sont les derniers comptes de CGX REALISATIONS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2014

    Quels sont les derniers dépôts pour CGX REALISATIONS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Avis de transition de l'administration à la dissolution

    14 pagesAM23

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    16 pagesAM10

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    17 pagesAM10

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    3 pagesAM19

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 14 mars 2017

    15 pages2.24B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 14 sept. 2016

    19 pages2.24B

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    1 pages2.31B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 08 juin 2016

    20 pages2.24B

    Cessation de la nomination de Peter William Mcguinness en tant que directeur le 27 mai 2016

    2 pagesTM01

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Avis de changement de nom"

    2 pagesCONNOT

    Cessation de la nomination de Stephen John Ellis en tant que directeur le 31 mars 2016

    2 pagesTM01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Déclaration des affaires avec le formulaire 2.14B

    9 pages2.16B

    Avis d'approbation réputée des propositions

    1 pagesF2.18

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    19 pages2.17B

    Changement d'adresse du siège social de Unit 1 & 2 Heol Rhosyn Parc Dafen Llanelli Carmarthenshire SA14 8QG à C/O Grant Thornton Uk Llp 4 Hardman Square Spinningfields Manchester M3 3EB le 29 déc. 2015

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2014

    26 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 avr. 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital11 mai 2015

    État du capital au 11 mai 2015

    • Capital: GBP 524,129.5
    SH01

    Cessation de la nomination de Kevin Donald Williams en tant que directeur le 31 janv. 2015

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Gerwyn John Miles en tant que directeur le 31 janv. 2015

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Gerwyn John Miles en tant que secrétaire le 31 janv. 2015

    1 pagesTM02

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2013

    25 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de CGX REALISATIONS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HOOD, Elizabeth Rhoda
    8 Caesars Gate
    NN13 7NH Brackley
    Northamptonshire
    Secrétaire
    8 Caesars Gate
    NN13 7NH Brackley
    Northamptonshire
    British106249340001
    HUGHES, Ian
    22 Clos Leighton Davies
    Gowerton
    SA4 3GG Swansea
    Secrétaire
    22 Clos Leighton Davies
    Gowerton
    SA4 3GG Swansea
    British34575790001
    MAIR, Barrie, Dr
    Wych Elm
    Fishery Road
    SL6 1UP Maidenhead
    Berkshire
    Secrétaire
    Wych Elm
    Fishery Road
    SL6 1UP Maidenhead
    Berkshire
    British64128670001
    MILES, Gerwyn John
    Unit 1 & 2 Heol Rhosyn
    Parc Dafen
    SA14 8QG Llanelli
    Carmarthenshire
    Secrétaire
    Unit 1 & 2 Heol Rhosyn
    Parc Dafen
    SA14 8QG Llanelli
    Carmarthenshire
    185755600001
    MORGAN, David Gareth
    Unit 1 & 2 Heol Rhosyn
    Parc Dafen
    SA14 8QG Llanelli
    Carmarthenshire
    Secrétaire
    Unit 1 & 2 Heol Rhosyn
    Parc Dafen
    SA14 8QG Llanelli
    Carmarthenshire
    British65312520002
    PECKHAM, David Hywel
    38 Parc Howard Avenue
    SA15 3JY Llanelli
    Dyfed
    Secrétaire
    38 Parc Howard Avenue
    SA15 3JY Llanelli
    Dyfed
    Welsh34106670001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    CAMERON, Allan
    33 Llythrid Avenue
    Uplands
    SA2 0JJ Swansea
    Administrateur
    33 Llythrid Avenue
    Uplands
    SA2 0JJ Swansea
    British54654800002
    CHAPPLE, Timothy Jonathan
    18 Roger Beck Way
    Sketty
    SA2 0JF Swansea
    Administrateur
    18 Roger Beck Way
    Sketty
    SA2 0JF Swansea
    British28933940002
    CLEMENT, Robert Marc
    11 Plas Road
    Rhos Pontardawe
    SA8 3HD Swansea
    Administrateur
    11 Plas Road
    Rhos Pontardawe
    SA8 3HD Swansea
    United KingdomBritish25145750001
    ELLIS, Stephen John
    c/o Grant Thornton Uk Llp
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    Administrateur
    c/o Grant Thornton Uk Llp
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    United KingdomBritish89725230001
    HOSKIN, John David
    Bourne Bank
    Hedsor Road
    SL8 5EE Bourne End
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Bourne Bank
    Hedsor Road
    SL8 5EE Bourne End
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish30414350001
    JONES, Gary Lewis
    48 Neath Road
    Resolven
    SA11 4AH Neath
    West Glamorgan
    Administrateur
    48 Neath Road
    Resolven
    SA11 4AH Neath
    West Glamorgan
    British65958200001
    LUNN, David Arthur
    3rd Floor Euro Canadian Centre
    Marlborough Street
    N 4901 Nassau
    Bahamas
    Bahamas
    Administrateur
    3rd Floor Euro Canadian Centre
    Marlborough Street
    N 4901 Nassau
    Bahamas
    Bahamas
    Bahamian28967300002
    MACDONALD, Bill Alan
    PO BOX 675493
    Rancho Santa Fe
    Ca 92067
    United States Of America
    Administrateur
    PO BOX 675493
    Rancho Santa Fe
    Ca 92067
    United States Of America
    American79392050001
    MAIR, Barrie, Dr
    Wych Elm
    Fishery Road
    SL6 1UP Maidenhead
    Berkshire
    Administrateur
    Wych Elm
    Fishery Road
    SL6 1UP Maidenhead
    Berkshire
    British64128670001
    MAIR, Jill Margaret
    Wych Elm
    Fishery Road
    SL6 1UP Bray
    Berkshire
    Administrateur
    Wych Elm
    Fishery Road
    SL6 1UP Bray
    Berkshire
    British28887650001
    MCGUINNESS, Peter William
    c/o Grant Thornton Uk Llp
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    Administrateur
    c/o Grant Thornton Uk Llp
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    United KingdomBritish97826790005
    MEHL, Thomas
    1015 Highway
    337 Old Bronson Road
    32669 Newberry
    Alachua
    Usa
    Administrateur
    1015 Highway
    337 Old Bronson Road
    32669 Newberry
    Alachua
    Usa
    American52304100001
    MILES, Gerwyn John
    Unit 1 & 2 Heol Rhosyn
    Parc Dafen
    SA14 8QG Llanelli
    Carmarthenshire
    Administrateur
    Unit 1 & 2 Heol Rhosyn
    Parc Dafen
    SA14 8QG Llanelli
    Carmarthenshire
    WalesBritish46422480002
    MORGAN, David Gareth
    Unit 1 & 2 Heol Rhosyn
    Parc Dafen
    SA14 8QG Llanelli
    Carmarthenshire
    Administrateur
    Unit 1 & 2 Heol Rhosyn
    Parc Dafen
    SA14 8QG Llanelli
    Carmarthenshire
    WalesBritish65312520002
    PRICE, John Duncan
    12 Georgian Way
    HA1 3LF Harrow
    Middlesex
    Administrateur
    12 Georgian Way
    HA1 3LF Harrow
    Middlesex
    EnglandBritish38774440001
    ROOSJE, Harry A
    31 New Dawn
    92620 Irvine
    California
    Usa
    Administrateur
    31 New Dawn
    92620 Irvine
    California
    Usa
    American90485720001
    ROVALO LOPEZ DE LINARES, Francisco Javier, Doctor
    Calzada Tlalpan 2021
    04040 Mexo Df
    FOREIGN Mexico City
    Mexico
    Administrateur
    Calzada Tlalpan 2021
    04040 Mexo Df
    FOREIGN Mexico City
    Mexico
    Mexican70935860001
    TAYLOR, Mark
    45 Bridgeport
    Newport Coast
    California
    92657
    Usa
    Administrateur
    45 Bridgeport
    Newport Coast
    California
    92657
    Usa
    American70935810001
    TIMMONS, Christopher Miles
    25261 Vealsquez Road
    Laguna Hills
    Ca 92653
    United States Of America
    Administrateur
    25261 Vealsquez Road
    Laguna Hills
    Ca 92653
    United States Of America
    American79391960001
    WILLIAMS, Kevin Donald
    Unit 1 & 2 Heol Rhosyn
    Parc Dafen
    SA14 8QG Llanelli
    Carmarthenshire
    Administrateur
    Unit 1 & 2 Heol Rhosyn
    Parc Dafen
    SA14 8QG Llanelli
    Carmarthenshire
    WalesWelsh122167440001
    WOOLMAN, Paul
    Foxhill Farm
    Broad Haven
    SA62 3TY Haverfordwest
    Dyfed
    Administrateur
    Foxhill Farm
    Broad Haven
    SA62 3TY Haverfordwest
    Dyfed
    WalesBritish34870340001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur désigné
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    CGX REALISATIONS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 09 oct. 2014
    Livré le 23 oct. 2014
    En cours
    Brève description
    Land "the beacon" at unuts 4, 5 & 6 llanelli gate house, dafen, llanelli. Patent entitled "laser depilation" with grant number 0732895. please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Squadron Capital Llc
    Transactions
    • 23 oct. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 28 févr. 2014
    Livré le 18 mars 2014
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Finance Wales Investments (3) LTD
    Transactions
    • 18 mars 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 16 oct. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 15 juin 2011
    Livré le 16 juin 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 16 juin 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 16 oct. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 09 mars 2011
    Livré le 22 mars 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Finance Wales Investments (6) Limited
    Transactions
    • 22 mars 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 16 oct. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deposit agreement to secure own liabilities
    Créé le 28 sept. 2010
    Livré le 29 sept. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All such rights to the repayment of the deposit meaning the debt(s) on the account(s) described in the schedule being the account with the bank denominated in sterling designated ltsb re chromogenex technologies limited and numbered 03760913 and any account(s) for the time being replacing the same and all interest owing in respect thereof and all deposits with the banks treasury division in the name of the bank re the company.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 29 sept. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 16 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    All assets debenture
    Créé le 30 avr. 2010
    Livré le 05 mai 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 05 mai 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 16 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 24 oct. 2007
    Livré le 07 nov. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 07 nov. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 janv. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 26 mars 1998
    Livré le 09 avr. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Mehl Biophile International Corporation
    Transactions
    • 09 avr. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 nov. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignment and charge of copyright and design right
    Créé le 13 juil. 1995
    Livré le 24 juil. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The copyrights being :- chromos lasers - multiple beam thermolysis laser and laser for treatment of vascular lesions sirius lasers being - carbon dioxide (C02) medical lasers k/a :- the sirius 200 and the sirius 300 and the sirius 500. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 24 juil. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 juil. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge of patents
    Créé le 13 juil. 1995
    Livré le 24 juil. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The applications for patents :- UK multiple beam thermolysis laser 9420696.8 1994 UK laser for treatment of vascular lesions 9420532.5 1994. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 24 juil. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 juil. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 26 août 1993
    Livré le 01 sept. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • 3I Group PLC
    Transactions
    • 01 sept. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 juil. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 03 mars 1993
    Livré le 23 mars 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 23 mars 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 juil. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 05 sept. 1989
    Acquis le 06 nov. 1992
    Livré le 20 nov. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due to the chargee under a secured loan agreement dated 5 september 1989
    Brèves mentions
    All the copyright in the works throughout the world for the full period thereof (for full details of charge see from 395 and contd sheets).
    Personnes ayant droit
    • Welsh Development Agency
    Transactions
    • 20 nov. 1992Enregistrement d'une acquisition (400)
    • 27 août 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    CGX REALISATIONS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    11 sept. 1998Date of meeting to approve CVA
    09 juin 2000Date of completion or termination of CVA
    Corporate voluntary arrangement (CVA)
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Gary Stones
    63 Walter Road
    SA1 4PT Swansea
    West Glamorgan
    practitioner
    63 Walter Road
    SA1 4PT Swansea
    West Glamorgan
    2
    DateType
    09 déc. 2015Administration started
    04 juil. 2018Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Alistair Gareth Wardell
    Grant Thornton Uk Llp
    11-13 Penhill Road
    CF11 9UP Cardiff
    practitioner
    Grant Thornton Uk Llp
    11-13 Penhill Road
    CF11 9UP Cardiff
    Nigel Morrison
    Hartwell House, 55-61 Victoria Street
    BS1 6FT Bristol
    practitioner
    Hartwell House, 55-61 Victoria Street
    BS1 6FT Bristol

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0