SOLICITORS INDEMNITY FUND PENSION SCHEME TRUSTEES LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | SOLICITORS INDEMNITY FUND PENSION SCHEME TRUSTEES LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 02720331 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe SOLICITORS INDEMNITY FUND PENSION SCHEME TRUSTEES LIMITED ?
| Adresse du siège social | 113 Chancery Lane WC2A 1PL London |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de SOLICITORS INDEMNITY FUND PENSION SCHEME TRUSTEES LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 août 2022 |
Quels sont les derniers dépôts pour SOLICITORS INDEMNITY FUND PENSION SCHEME TRUSTEES LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 août 2022 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 juin 2023 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 juin 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 août 2021 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 juin 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 août 2020 | 5 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr Thomas Fothergill en tant qu'administrateur le 01 mars 2021 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 juin 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 août 2019 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 juin 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 août 2018 | 5 pages | AA | ||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de C/O Mr Andrew Darby Sra 20 Co Azy Razvi Lsm Ltd 20 Fenchurch Street London EC3M 3AW England à 10 Lower Thames Street Suite 7.21 London EC3R 6AF | 1 pages | AD02 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 juin 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 août 2017 | 5 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr John Todd Young en tant qu'administrateur le 01 mars 2018 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de David Angus Mcintosh en tant que directeur le 28 févr. 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de C/O Mr Andrew Darby Sra 199 Wharfside Street Birmingham B1 1RN England à C/O Mr Andrew Darby Sra 20 Co Azy Razvi Lsm Ltd 20 Fenchurch Street London EC3M 3AW | 1 pages | AD02 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 juin 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 août 2016 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 juin 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 août 2015 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 juin 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Qui sont les dirigeants de SOLICITORS INDEMNITY FUND PENSION SCHEME TRUSTEES LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DARBY, Andrew Michael | Secrétaire | Chancery Lane WC2A 1PL London 113 | 149521490001 | |||||||
| FOTHERGILL, Thomas | Administrateur | Chancery Lane WC2A 1PL London 113 | England | British | 203342940001 | |||||
| YOUNG, John Todd | Administrateur | Chancery Lane WC2A 1PL London 113 | United Kingdom | British | 237864990001 | |||||
| CONWAY, Christopher Bernard | Secrétaire | 20 Wyndcliff Road SE7 7JX London | British | 61732050001 | ||||||
| WALL, James Cameron | Secrétaire | Flat 4 9 Guildford Road BN1 3LU Brighton East Sussex | British | 11724060001 | ||||||
| WEBB, Paul Ernest | Secrétaire | 5 Loampits Close TN9 1PX Tonbridge Kent | British | 14806250001 | ||||||
| WOODS, Sean Thomas | Secrétaire | 46 Scholars Road Balham SW12 0PG London | British | 29166340002 | ||||||
| ANDERSON, Ian Martyn | Administrateur | 1 Stangrave Hall Bletchingley Road RH9 8NB Godstone Surrey | British | 40644240001 | ||||||
| BAKER, William Simon | Administrateur | 10 Hurle Crescent Clifton BS8 2TA Bristol Avon | England | British | 7994760001 | |||||
| DARBY, Andrew Michael | Administrateur | The Hedgerow Camp Lane Grimley WR2 6LX Worcester Worcestershire | United Kingdom | British | 2390310002 | |||||
| DAY, Bernard Victor | Administrateur | Croft Orchard Gloucester Street GL6 6QN Painswick Gloucestershire | Great Britain | British | 34832930001 | |||||
| GREEN, John Stephen | Administrateur | Chepstow Cottage Chepstow Close CM11 1SH Billericay Essex | British | 29166350001 | ||||||
| GREEN, John Stephen | Administrateur | Chepstow Cottage Chepstow Close CM11 1SH Billericay Essex | British | 29166350001 | ||||||
| KENNEDY, Andrew David | Administrateur | 19 Wool Road Wimbledon SW20 0HN London | England | British | 5153980001 | |||||
| MCINTOSH, David Angus | Administrateur | Chancery Lane WC2A 1PL London 113 | England | British | 105156040001 | |||||
| MILLS, Stephen John | Administrateur | 7 Westbrook Road Blackheath SE3 0NS London | British | 15688420001 | ||||||
| MULLINS, Elizabeth | Administrateur | 5 Wingfield House 261 South Lambeth Road SW8 1UH London | British | 127196170001 | ||||||
| RAUBENHEIMER, George Edwin | Administrateur | Threadneedle Street EC2R 8AY London 28 | United Kingdom | British | 62740010001 | |||||
| RAUBENHEIMER, George Edwin | Administrateur | 21 Limeway TN21 8YB Heathfield East Sussex | United Kingdom | British | 62740010001 | |||||
| SPEEDMAN, John Anderson | Administrateur | Hilton Park Main Road Pettistree IP13 0HG Woodbridge Suffolk | United Kingdom | British | 57852080001 | |||||
| STEWART, Bryan | Administrateur | Junipers 16 Vicarage Lane Great Baddow CM2 8HZ Chelmsford Essex | English | 23809190001 | ||||||
| VENTON, Paul Mervyn | Administrateur | 43 Oxenden Wood Road BR6 6HP Orpington Kent | United Kingdom | British | 14154570001 | |||||
| WILLIAMSON, Peter John | Administrateur | Prestonfield 3 Copperkins Grove Chesham Bois HP6 5QD Amersham Buckinghamshire | United Kingdom | British | 48048710001 | |||||
| WILSON, Nicholas Andrew | Administrateur | 12 The Fairway HD2 2HU Huddersfield West Yorkshire | British | 71337370001 | ||||||
| WOODS, Sean Thomas | Administrateur | 31 Bradfield House SW8 4UA London | British | 29166340001 | ||||||
| YOUNG, John Adrian Emile | Administrateur | Stonewold House The Street Plaxtol TN15 0QH Sevenoaks Kent | British | 23718820001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SOLICITORS INDEMNITY FUND PENSION SCHEME TRUSTEES LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicitors Indemnity Fund Ltd | 06 avr. 2016 | Chancery Lane WC2A 1PL London 113 England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0