EVERSHOLT RAIL LEASING LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | EVERSHOLT RAIL LEASING LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Active |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 02720809 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe EVERSHOLT RAIL LEASING LIMITED ?
Adresse du siège social | First Floor Chancery House 53-64 Chancery Lane WC2A 1QS London England |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de EVERSHOLT RAIL LEASING LIMITED ?
En retard | Non |
---|---|
Prochains comptes | |
Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2024 |
Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2025 |
Derniers comptes | |
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2023 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour EVERSHOLT RAIL LEASING LIMITED ?
Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 11 mai 2025 |
---|---|
Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 25 mai 2025 |
Dernière déclaration de confirmation | |
Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 11 mai 2024 |
En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour EVERSHOLT RAIL LEASING LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |
---|---|---|---|---|
Déclaration de confirmation établie le 11 mai 2024 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2023 | 44 pages | AA | ||
Changement d'adresse du siège social de Ground Floor Wework 1 Waterhouse Square 138-142 Holborn London EC1N 2st England à First Floor Chancery House 53-64 Chancery Lane London WC2A 1QS le 22 janv. 2024 | 1 pages | AD01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Paul Marcus Sutherland le 30 juin 2023 | 2 pages | CH01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 11 mai 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2022 | 46 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 11 mai 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2021 | 23 pages | AA | ||
Modification des détails de Eversholt Uk Rails (Holding) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 déc. 2021 | 2 pages | PSC05 | ||
Changement d'adresse du siège social de 210 Pentonville Road London Great Britain N1 9JY à Ground Floor Wework 1 Waterhouse Square 138-142 Holborn London EC1N 2st le 06 déc. 2021 | 1 pages | AD01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Lee Robert Warsop le 16 oct. 2020 | 2 pages | CH01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2020 | 46 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 11 mai 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 11 mai 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Nomination de Mr Paul Marcus Sutherland en tant qu'administrateur le 16 avr. 2020 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Mr Darren Spence en tant qu'administrateur le 16 avr. 2020 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Mr Lee Robert Warsop en tant qu'administrateur le 16 avr. 2020 | 2 pages | AP01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2019 | 41 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Andrew James Course en tant que directeur le 16 sept. 2019 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 11 mai 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2018 | 36 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 11 mai 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2017 | 31 pages | AA | ||
Notification de Eversholt Uk Rails (Holding) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 22 mai 2017 | 2 pages | PSC02 | ||
Retrait d'une déclaration relative à une personne disposant d'un contrôle significatif le 19 mars 2018 | 2 pages | PSC09 | ||
Qui sont les dirigeants de EVERSHOLT RAIL LEASING LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHARMA, Michelle | Secrétaire | Chancery House 53-64 Chancery Lane WC2A 1QS London First Floor England | 197530480001 | |||||||
KENNY, Mary Bridget | Administrateur | Chancery House 53-64 Chancery Lane WC2A 1QS London First Floor England | United Kingdom | British | Accountant | 118995490003 | ||||
SPENCE, Darren | Administrateur | Chancery House 53-64 Chancery Lane WC2A 1QS London First Floor England | England | British | Accountant | 260636500001 | ||||
SUTHERLAND, Paul Marcus | Administrateur | Chancery House 53-64 Chancery Lane WC2A 1QS London First Floor England | England | British | Engineer | 268962340002 | ||||
WARSOP, Lee Robert | Administrateur | Chancery House 53-64 Chancery Lane WC2A 1QS London First Floor England | England | British | Solicitor | 252761400002 | ||||
WESSON, Andrea Justine | Administrateur | Chancery House 53-64 Chancery Lane WC2A 1QS London First Floor England | England | British | Chartered Accountant | 210784950001 | ||||
BAYER, George William | Secrétaire | Flat 1 Old Bank House, 110 Bermondsey Street SE1 3TX London | Other | 123920600002 | ||||||
GOTT, Sarah Caroline | Secrétaire | Whitworth Street SE10 9EN London 13 United Kingdom | British | 136485400005 | ||||||
MCKENZIE, John Hume | Secrétaire | 37 Lime Trees Staplehurst TN12 0SS Tonbridge Kent | British | 70097280001 | ||||||
MCQUILLAN, Pauline Louise | Secrétaire | 8 Canada Square E14 5HQ London | British | 109247130002 | ||||||
MUSGROVE, Robert Hugh | Secrétaire | 6 Barn Meadow Staplehurst TN12 0SY Tonbridge Kent | Other | 76913670001 | ||||||
NIVEN, Frances Julie | Secrétaire | 73 Celestial Gardens SE13 5RU London | British | 78670270001 | ||||||
PEARCE, Mark Vivian | Secrétaire | 55 Huntly Road Talbot Woods BH3 7HG Bournemouth Dorset | British | 26776940002 | ||||||
READ, Alice | Secrétaire | 188 Berglen Court 7 Branch Road E14 7JZ London | British | 106168980003 | ||||||
THOMAS, Clive Lewis | Secrétaire | Pentonville Road N1 9JY London 210 Great Britain United Kingdom | British | 161324690001 | ||||||
BARKER, Matthew Giles | Administrateur | Pentonville Road N1 9JY London 210 Great Britain United Kingdom | United Kingdom | British | Investment Manager | 186515060001 | ||||
BARKER, Nicholas David | Administrateur | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | Corporate Banker | 41800250004 | ||||
BOTTOMLEY, Stephen Andrew | Administrateur | Liverton House Roundwood Lane RH16 1SJ Lindfield West Sussex | British | Managing Director Gcs | 60768490002 | |||||
BROOKES, Malcolm James | Administrateur | Jubilee Bell Close WR2 6QA Hallow Worcestershire | United Kingdom | British | Head Of Finance Commercial Ban | 61727900005 | ||||
CARNEY, Brian | Administrateur | Springwood Lodge Owler Park Road LS29 0BG Ilkley West Yorkshire | British | General Manager | 100001170001 | |||||
CHAN, Loi Shun | Administrateur | Pentonville Road N1 9JY London 210 Great Britain | Hong Kong | Chinese | Director | 196969170001 | ||||
COURSE, Andrew James | Administrateur | Pentonville Road N1 9JY London 210 Great Britain United Kingdom | England | British | Chief Operating Officer And Chartered Engineer | 178893010002 | ||||
EVANS, Geoffrey William | Administrateur | The Trumpet House Kington Lane Claverdon CV35 8PP Warwick | British | Director & General Manager | 42712190001 | |||||
GILMAN, David William | Administrateur | 32 Riverside Drive Selly Oak B29 7ES Birmingham | British | Director Finance | 5681410002 | |||||
GODFREY, Kevin Joseph | Administrateur | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | Irish | Banker | 34130580006 | ||||
GOUGH, Paul | Administrateur | Pentonville Road N1 9JY London 210 Great Britain United Kingdom | United Kingdom | New Zealander | Partner Private Equity Investment Firm | 155113470001 | ||||
HAINES, Andrew | Administrateur | Pentonville Road N1 9JY London 210 Great Britain United Kingdom | England | British | Chief Executive Civil Aviation Authority | 250737950001 | ||||
HARRIS, Christopher David | Administrateur | 8 Verdon Place Barford CV35 8BT Warwick | British | Director Finance Forward Trust | 28742940002 | |||||
HOLMES, Timothy Victor | Administrateur | 12 Aspins Way Bromsgrove B61 0UW Birmingham | British | Director | 28497420007 | |||||
HOLMES, Timothy Victor | Administrateur | 18 The Badgers Mearse Lane Barnt Green B45 8QR Birmingham | British | Director & General Manager | 28497420002 | |||||
HOLMES, Timothy Victor | Administrateur | The Oak House Moat Court Astwood Lane B96 6HD Feckenham Worcestershire | British | Managing Director Forward Motor Finance | 28497420001 | |||||
HUMPHREYS, Kay Eileen | Administrateur | 36 Windsor Road Wanstead E11 3QU London | British | Snr Company Secretarial Assistant | 27821240001 | |||||
HUNTER, Andrew John | Administrateur | Pentonville Road N1 9JY London 210 Great Britain | Hong Kong | British | Director | 196969210001 | ||||
KAM, Hing Lam | Administrateur | Pentonville Road N1 9JY London 210 Great Britain | Hong Kong | Chinese | Director | 196969940001 | ||||
KELL, Christopher Raymond | Administrateur | 6 Gorse Close WR9 7SG Droitwich Worcestershire | British | Tax Manager | 87307470001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur EVERSHOLT RAIL LEASING LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eversholt Uk Rails (Holding) Limited | 22 mai 2017 | Wework 1 Waterhouse Square 138 - 142 Holborn EC1N 2ST London Ground Floor England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour EVERSHOLT RAIL LEASING LIMITED ?
Notifié le | Cessé le | Déclaration |
---|---|---|
11 mai 2017 | 22 mai 2017 | La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société. |
EVERSHOLT RAIL LEASING LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Créé le 04 janv. 2016 Livré le 04 janv. 2016 | En cours | ||
Contient une promesse négative: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
An amendment deed to a fixed and floating security agreement dated 4 november 2010 and | Créé le 02 déc. 2010 Livré le 17 déc. 2010 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to any secured creditor and the pension trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Fixed and floating security agreement | Créé le 04 nov. 2010 Livré le 12 nov. 2010 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to any secured creditor and all monies due or to become due from the company to the pension trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0