FIESTA FINE FOODS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéFIESTA FINE FOODS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02725733
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de FIESTA FINE FOODS LIMITED ?

    • Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. (10890) / Industries manufacturières

    Où se situe FIESTA FINE FOODS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o WINGATES IND PARK WEST
    31-32 Great Bank Road
    Wingates South
    BL5 3XU Houghton
    Bolton Lancashire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de FIESTA FINE FOODS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    HALLS FRESH SOUPS LIMITED24 juin 199224 juin 1992

    Quels sont les derniers comptes de FIESTA FINE FOODS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au28 févr. 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour FIESTA FINE FOODS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 juin 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital20 juil. 2012

    État du capital au 20 juil. 2012

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 28 févr. 2011

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 juin 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 28 févr. 2010

    6 pagesAA

    État du capital au 04 oct. 2010

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Share premium account 20/09/2010
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 juin 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 28 févr. 2009

    7 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Comptes établis au 29 févr. 2008

    7 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Comptes établis au 28 févr. 2007

    7 pagesAA

    legacy

    2 pages363a

    Comptes établis au 28 févr. 2006

    6 pagesAA

    legacy

    2 pages363a

    Comptes établis au 28 févr. 2005

    6 pagesAA

    legacy

    7 pages363s

    Comptes établis au 28 févr. 2004

    7 pagesAA

    legacy

    7 pages363s

    legacy

    pages363(353)

    Qui sont les dirigeants de FIESTA FINE FOODS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    LUCAS, Jonathan Alan
    Woodhouse Farm
    Anson Road, Poynton
    SK12 1TD Stockport
    Secrétaire
    Woodhouse Farm
    Anson Road, Poynton
    SK12 1TD Stockport
    BritishAccountant30872210003
    KENT, Michael Ian
    36 Anglesey Drive
    Poynton
    SK12 1BU Stockport
    Cheshire
    Administrateur
    36 Anglesey Drive
    Poynton
    SK12 1BU Stockport
    Cheshire
    United KingdomBritishCompany Director7084160005
    LUCAS, Jonathan Alan
    Woodhouse Farm
    Anson Road, Poynton
    SK12 1TD Stockport
    Administrateur
    Woodhouse Farm
    Anson Road, Poynton
    SK12 1TD Stockport
    EnglandBritishAccountant30872210003
    HALLS, Dennis John
    Harpers Farm
    Wilderswood
    BL6 6SA Horwich
    Lancashire
    Secrétaire
    Harpers Farm
    Wilderswood
    BL6 6SA Horwich
    Lancashire
    BritishCompany Secretary12908410001
    HALLS, Valerie
    Harpers Farm
    Wilderswood
    BL6 6SA Horwich
    Lancashire
    Secrétaire
    Harpers Farm
    Wilderswood
    BL6 6SA Horwich
    Lancashire
    British87726360001
    CORPORATE REGISTRARS LIMITED
    Fourways House 16 Tariff Street
    M1 2FL Manchester
    Greater Manchester
    Secrétaire
    Fourways House 16 Tariff Street
    M1 2FL Manchester
    Greater Manchester
    42315760001
    CAINES, Andrew
    Helsinki Road
    Sutton Fields Industrial State
    HU7 0YW Hull
    74
    East Yorkshire
    Administrateur
    Helsinki Road
    Sutton Fields Industrial State
    HU7 0YW Hull
    74
    East Yorkshire
    EnglandBritishDirector106266250001
    GOODALL, Roy
    Cherry Trees Queens Park Road
    CH4 7AD Chester
    Cheshire
    Administrateur
    Cherry Trees Queens Park Road
    CH4 7AD Chester
    Cheshire
    BritishDirector16667490001
    HALLS, Andrew Dennis
    30 Webb Street
    Horwich
    BL6 5NS Bolton
    Lancashire
    Administrateur
    30 Webb Street
    Horwich
    BL6 5NS Bolton
    Lancashire
    BritishDirector41373660001
    HALLS, Dennis John
    Harpers Farm
    Wilderswood
    BL6 6SA Horwich
    Lancashire
    Administrateur
    Harpers Farm
    Wilderswood
    BL6 6SA Horwich
    Lancashire
    BritishSales Director12908410001
    HALLS, Valerie
    Harpers Farm
    Wilderswood
    BL6 6SA Horwich
    Lancashire
    Administrateur
    Harpers Farm
    Wilderswood
    BL6 6SA Horwich
    Lancashire
    BritishDirector87726360001
    MILBURN, Brian Carr
    Dene Cottage Linton Lane
    Linton
    LS22 4HL Wetherby
    West Yorkshire
    Administrateur
    Dene Cottage Linton Lane
    Linton
    LS22 4HL Wetherby
    West Yorkshire
    BritishDirector40264040004
    RITSON, Paul Steven
    12 Hurst Hill Crescent
    OL6 9NJ Ashton Under Lyne
    Lancashire
    Administrateur
    12 Hurst Hill Crescent
    OL6 9NJ Ashton Under Lyne
    Lancashire
    BritishCompany Director70469800001
    SHREEVE, Stanley
    3 Woodrow Park
    DN33 2EF Grimsby
    South Humberside
    Administrateur
    3 Woodrow Park
    DN33 2EF Grimsby
    South Humberside
    BritishDirector62454660001
    WALSH, Ralph Edward
    1 Longden Walk
    Lepton
    HD8 0HG Huddersfield
    West Yorkshire
    Administrateur
    1 Longden Walk
    Lepton
    HD8 0HG Huddersfield
    West Yorkshire
    BritishCompany Director37400910001
    CORPORATE REGISTRARS LIMITED
    Fourways House 16 Tariff Street
    M1 2FL Manchester
    Greater Manchester
    Administrateur
    Fourways House 16 Tariff Street
    M1 2FL Manchester
    Greater Manchester
    42315760001

    FIESTA FINE FOODS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Mortgage debenture
    Créé le 13 oct. 1995
    Livré le 23 oct. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 23 oct. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 nov. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 03 janv. 1995
    Livré le 10 janv. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Including trade fixtures. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • 3I PLC
    Transactions
    • 10 janv. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 avr. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Book debts debenture
    Créé le 16 août 1994
    Livré le 20 août 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    First fixed charge on all book debts and other debts of the company both present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Causeway Invoice Discounting Company Limited
    Transactions
    • 20 août 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 nov. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 01 juin 1994
    Livré le 03 juin 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • 3I Group PLC
    Transactions
    • 03 juin 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 avr. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattel mortgage
    Créé le 01 juin 1994
    Livré le 03 juin 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Automatic line for the production of pizza `pizzeria' diameter 270MM (4000 pieces/hour) as detailed in the sales contract no:94402 made between simmer S.P.A. (1) and the company (2) dated 11TH february 1994 with all additions alterations accessories replacements and renewals of component parts thereto. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • 3I Group PLC
    Transactions
    • 03 juin 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 avr. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0