BAIN 1 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBAIN 1 LIMITED
    Statut de la sociétéLiquidation
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02732585
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BAIN 1 LIMITED ?

    • (1571) /

    Où se situe BAIN 1 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BAIN 1 LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    WELSH COUNTRY FOODS LIMITED24 avr. 199524 avr. 1995
    MCINTOSH REYNOLDS LIMITED28 févr. 199528 févr. 1995
    WELSH COUNTRY FOODS LIMITED20 févr. 199520 févr. 1995
    MCINTOSH REYNOLDS LIMITED14 déc. 199214 déc. 1992
    MCINTOSH REYNOLDS (WALES) LIMITED07 août 199207 août 1992
    MADESMOKE LIMITED20 juil. 199220 juil. 1992

    Quels sont les derniers comptes de BAIN 1 LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2010
    Date d'échéance des prochains comptes30 sept. 2011
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2009

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour BAIN 1 LIMITED ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au20 juil. 2016
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation03 août 2016
    En retardOui

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour BAIN 1 LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour BAIN 1 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Restauration par ordonnance du tribunal - précédemment en liquidation volontaire des membres

    3 pagesREST-MVL

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 02 déc. 2011

    2 pages4.68

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    5 pages4.71

    Modification des coordonnées du secrétaire Tmf Corporate Administration Services Limited le 19 sept. 2011

    2 pagesCH04

    Changement d'adresse du siège social de * Malton Bacon Factory Hugden Way Norton Grove Industrial Estate Malton North Yorkshire YO17 9HG* le 27 mai 2011

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination de Mark Steven en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Certificat de changement de nom

    Company name changed welsh country foods LIMITED\certificate issued on 04/05/11
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name04 mai 2011

    Résolution de changement de nom

    RES15
    change-of-name04 mai 2011

    Changement de nom" par résolution

    NM01

    Cessation de la nomination de Mawlaw Secretaries Limited en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Nomination de Tmf Corporate Administration Services Limited en tant que secrétaire

    2 pagesAP04

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de 201 Bishopsgate London EC2M 3AF

    1 pagesAD02

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2009

    18 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 juil. 2010 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital20 juil. 2010

    État du capital au 20 juil. 2010

    • Capital: GBP 2,810,000
    SH01

    Période comptable précédente prolongée du 22 nov. 2009 au 31 déc. 2009

    1 pagesAA01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Jose Juan Peralta le 14 janv. 2010

    2 pagesCH01

    Cessation de la nomination de Antonius Lammers en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Louis Antoine Maria Vernaus en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Stephen Ronald William Francis le 01 oct. 2009

    3 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Antonius Matheus Maria Lammers le 01 oct. 2009

    3 pagesCH01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée

    2 pagesAD02

    legacy

    5 pages363a

    Comptes annuels établis au 22 nov. 2008

    18 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de BAIN 1 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    TMF CORPORATE ADMINISTRATION SERVICES LIMITED
    6 St Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th Floor
    United Kingdom
    Secrétaire
    6 St Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th Floor
    United Kingdom
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement06902863
    140723560001
    CHRISTIAANSE, Anthony Martin
    3065 Sc Rotterdam
    's-Gravenweg 551
    Netherlands
    Administrateur
    3065 Sc Rotterdam
    's-Gravenweg 551
    Netherlands
    Dutch129239540002
    FRANCIS, Stephen Ronald William
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    Administrateur
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    EnglandBritish105961550001
    PERALTA, Jose
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    Administrateur
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    WalesSpanish55989090003
    STEVEN, Mark Alexander
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    Administrateur
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    ScotlandBritish159788300001
    VERNAUS, Louis Antoine Maria
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    Administrateur
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    NetherlandsDutch146206430001
    THOMAS, Howard
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    Secrétaire désigné
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British900000900001
    IAIN SMITH AND COMPANY
    18-20 Queen's Road
    AB15 4ZT Aberdeen
    Grampian
    Secrétaire
    18-20 Queen's Road
    AB15 4ZT Aberdeen
    Grampian
    93547510001
    MACLAY MURRAY & SPENS LLP
    66 Queen's Road
    AB15 4YE Aberdeen
    Secrétaire
    66 Queen's Road
    AB15 4YE Aberdeen
    119967690001
    MAWLAW SECRETARIES LIMITED
    Bishopsgate
    EC2M 3AF London
    201
    Secrétaire
    Bishopsgate
    EC2M 3AF London
    201
    39182980003
    PAULL & WILLIAMSONS
    Union Plaza (6th Floor)
    1 Union Wynd
    AB10 1DQ Aberdeen
    Secrétaire
    Union Plaza (6th Floor)
    1 Union Wynd
    AB10 1DQ Aberdeen
    24280001
    BATCHELOR, Philip
    25 Wadeson Way
    Croft
    WA3 7JW Warrington
    Cheshire
    Administrateur
    25 Wadeson Way
    Croft
    WA3 7JW Warrington
    Cheshire
    British51334610001
    BURGESS, Robert
    Orme View
    3 Beach Road
    LL59 5HB Menai Bridge
    Gwynedd
    Administrateur
    Orme View
    3 Beach Road
    LL59 5HB Menai Bridge
    Gwynedd
    British56033760001
    DUNCAN, Alfred John
    Saetra House
    Inchmarlo Road
    AB31 3RR Banchory
    Aberdeenshire
    Administrateur
    Saetra House
    Inchmarlo Road
    AB31 3RR Banchory
    Aberdeenshire
    United KingdomBritish402690001
    DUNCAN, Gordon Scott
    Tigh Na Bruich Feuchside
    Strachan
    Banchory
    Kincardineshire
    Administrateur
    Tigh Na Bruich Feuchside
    Strachan
    Banchory
    Kincardineshire
    British33741760001
    ENNIS, Edwin Charles
    22 Abbey Road
    PE10 9EP Bourne
    Lincolnshire
    Administrateur
    22 Abbey Road
    PE10 9EP Bourne
    Lincolnshire
    United KingdomBritish116446960001
    HANGAR, Trevor
    Bowlacre Farm
    Bowlacre Road Gee Cross
    SK14 5ES Hyde
    Cheshire
    Administrateur
    Bowlacre Farm
    Bowlacre Road Gee Cross
    SK14 5ES Hyde
    Cheshire
    British98137740001
    IMRAY, Iain Murray
    41 Hammersmith Road
    AB10 6NA Aberdeen
    Aberdeenshire
    Administrateur
    41 Hammersmith Road
    AB10 6NA Aberdeen
    Aberdeenshire
    United KingdomBritish63444910001
    LAMMERS, Antonius Matheus Maria
    7005-7023
    5692 Hb Son En Breugel
    Ekkersrijt
    The Netherlands
    Administrateur
    7005-7023
    5692 Hb Son En Breugel
    Ekkersrijt
    The Netherlands
    Dutch126350570004
    LEE, Mark Rayton
    29 The Heywoods
    CH2 2RA Chester
    Cheshire
    Administrateur
    29 The Heywoods
    CH2 2RA Chester
    Cheshire
    British58725850002
    LIND, John
    Overton Of Keithfield
    AB41 0EU Methlick
    Aberdeenshire
    Administrateur
    Overton Of Keithfield
    AB41 0EU Methlick
    Aberdeenshire
    United KingdomBritish515220001
    MCMYLER, Francis Patrick
    Porthordy Paradwys
    Paradwys
    LL62 5PE Bodorgan
    Angelsey
    Administrateur
    Porthordy Paradwys
    Paradwys
    LL62 5PE Bodorgan
    Angelsey
    British82282340001
    MITCHELL, John
    2 The Towers
    Trinity Square
    LL30 2PY Llandudno
    Administrateur
    2 The Towers
    Trinity Square
    LL30 2PY Llandudno
    British60035720006
    PARIS, Walter Walker
    21 Hillview Road
    AB31 4EG Banchory
    Kincardineshire
    Scotland
    Administrateur
    21 Hillview Road
    AB31 4EG Banchory
    Kincardineshire
    Scotland
    British338220001
    POCOCK, Patrick William
    55 Millside Road
    Peterculter
    AB1 0WE Aberdeen
    Grampian
    Administrateur
    55 Millside Road
    Peterculter
    AB1 0WE Aberdeen
    Grampian
    British36234170001
    PUGH, Elwyn Martin
    1 Croxdale Close
    OL7 9LJ Ashton Under Lyne
    Lancashire
    Administrateur
    1 Croxdale Close
    OL7 9LJ Ashton Under Lyne
    Lancashire
    British74903230001
    REYNOLDS, Maurice Samuel
    Cae Newydd
    Blackhorse Lane Pentraeth
    LL75 Anglesey
    Administrateur
    Cae Newydd
    Blackhorse Lane Pentraeth
    LL75 Anglesey
    British30923360001
    RHIND, Evelyn Kerr
    Dearg Sheiling
    Corsee Road
    AB31 3RS Banchory
    Kincardineshire
    Administrateur
    Dearg Sheiling
    Corsee Road
    AB31 3RS Banchory
    Kincardineshire
    British389060001
    RIDOUT, Marc Alan
    37 Meliden Road
    LL19 9SD Prestatyn
    Clwyd
    Administrateur
    37 Meliden Road
    LL19 9SD Prestatyn
    Clwyd
    British42012080001
    SALKELD, David John
    The Old Hall Back Lane
    Bramham
    LS23 6QR Wetherby
    West Yorkshire
    Administrateur
    The Old Hall Back Lane
    Bramham
    LS23 6QR Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritish111995510001
    SOBEY, Michael John
    Overton Of Keithfield
    Methlick
    Ellon
    Administrateur
    Overton Of Keithfield
    Methlick
    Ellon
    United KingdomBritish895550001
    STEPHEN, Andrew Michael Duthie
    Speymuir 3 Victoria Street
    AB53 4RE Turriff
    Aberdeenshire
    Scotland
    Administrateur
    Speymuir 3 Victoria Street
    AB53 4RE Turriff
    Aberdeenshire
    Scotland
    ScotlandBritish338210001
    TESTER, William Andrew Joseph
    4 Geary House
    Georges Road
    N7 8EZ London
    Administrateur désigné
    4 Geary House
    Georges Road
    N7 8EZ London
    United KingdomBritish900000890001
    TRIGGS, Colin Patrick
    Crown Farm
    CW8 2HB Oakmere
    Cheshire
    Administrateur
    Crown Farm
    CW8 2HB Oakmere
    Cheshire
    United KingdomBritish193451740001
    WILLOX, Grant Alexander
    5 Charlton Court
    Hoole Road
    CH2 3PB Chester
    Administrateur
    5 Charlton Court
    Hoole Road
    CH2 3PB Chester
    British91193020002

    BAIN 1 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    An intercreditor and security agreement
    Créé le 30 mai 2007
    Livré le 13 juin 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to any restructuring creditor and the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All of its right to and title and interest (if any) from time to time to the deposits. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee
    Transactions
    • 13 juin 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 sept. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 29 mai 2007
    Livré le 08 juin 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 08 juin 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 sept. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattels mortgage
    Créé le 08 juin 2005
    Livré le 18 juin 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All and singular - equipment comprising a warehouse storage, conveyorage and multipick system which includes: swisslog project-5 aisles (2,644 pallet positions) high bay racking, 4 stacker cranes s/no's 939569-ab, 939570-ab, 939571-ab, 939572-ab, accalon pallet conveyors for details of further chattels charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transactions
    • 18 juin 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 févr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattels mortgage
    Créé le 12 août 2004
    Livré le 13 août 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    5 aisles (2,644 pallet positions) high bay racking situated in the high bay warehouse; maintenance access platform situated in the high bay warehouse; 4 stacker cranes serial no's: 939569-ab, 939570-ab, 939571-ab, 93972-ab (for further chattel details please refer to form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transactions
    • 13 août 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 févr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 07 déc. 1998
    Livré le 23 déc. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee in terms of the guarantee including in particular all monies due by the trustees (as defined) under or in connection with any of the finance documents (as defined)
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 23 déc. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 janv. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 28 juil. 1998
    Livré le 14 août 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the finance parties (as defined) on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland,as Trustee for the Finance Parties
    Transactions
    • 14 août 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 sept. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 17 mars 1995
    Livré le 30 mars 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee; as agent and trustee for and on behalf of the banks (as defined therein) and the banks (or any of them) on any account whatsoever under the terms of any financing document
    Brèves mentions
    Including land lying to the south of holyhead road, gaerwen, llanfihangel, esceifiog, ynys mon, isle of anglesey, gwynedd t/no. WA239861 and land lying to the south of lon groes, gaerwen industrial estate, gaerwen and land and buildings at gaerwen industrial estate, gaerwen, ynys mon, isle of anglesey, gwynedd t/no. WA658465. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 30 mars 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 janv. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 19 oct. 1992
    Livré le 30 oct. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage all f/h and l/h property including land lying to the soth of holyhead road, gaerwentitle no. WA239861LAND and buildings at gaerwen industrial(see form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 30 oct. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 janv. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 19 oct. 1992
    Livré le 30 oct. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All present and future f/h and l/h property including land lying to the south of holyhead road, gaerwen title no. WA239861 land and buildings at gaerwen industrial estate, gaerwen (including trade fixtures) (see form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • James Mcintosh & Company Limited
    Transactions
    • 30 oct. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 janv. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    BAIN 1 LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    19 mars 2012Dissolved on
    11 mai 2011Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Malcolm Cohen
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    practitioner
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0