STADIUM PROPERTY ASSET MANAGEMENT LIMITED

STADIUM PROPERTY ASSET MANAGEMENT LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSTADIUM PROPERTY ASSET MANAGEMENT LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02733211
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de STADIUM PROPERTY ASSET MANAGEMENT LIMITED ?

    • Autre location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués (68209) / Activités immobilières

    Où se situe STADIUM PROPERTY ASSET MANAGEMENT LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Welton Grange
    Welton
    HU15 1NB Brough
    East Yorkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de STADIUM PROPERTY ASSET MANAGEMENT LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SOVCO 476 LIMITED21 juil. 199221 juil. 1992

    Quels sont les derniers comptes de STADIUM PROPERTY ASSET MANAGEMENT LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2012

    Quels sont les derniers dépôts pour STADIUM PROPERTY ASSET MANAGEMENT LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2012

    4 pagesAA

    Nomination de Mrs Amanda Jayne Standish en tant qu'administrateur le 27 sept. 2012

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Andrew Stuart Fish en tant que secrétaire le 27 sept. 2012

    1 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Shaun Willox en tant que directeur le 27 sept. 2012

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Michael Clive Crooks en tant que directeur le 27 sept. 2012

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Michael Clive Crooks en tant que secrétaire le 27 sept. 2012

    1 pagesTM02

    Déclaration annuelle jusqu'au 21 juil. 2012 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital25 juil. 2012

    État du capital au 25 juil. 2012

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2011

    9 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 21 juil. 2011 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Andrew Stuart Fish le 21 juil. 2011

    2 pagesCH01

    Nomination de Mr Shaun Willox en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Andrew Stuart Fish en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Paul Nigel Swales en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2010

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 21 juil. 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Michael Clive Crooks le 21 juil. 2010

    2 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Michael Clive Crooks le 21 juil. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Paul Dyson Healey le 21 juil. 2010

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2009

    4 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    Comptes établis au 30 juin 2008

    4 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    Qui sont les dirigeants de STADIUM PROPERTY ASSET MANAGEMENT LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    FISH, Andrew Stuart
    Welton Grange
    Welton
    HU15 1NB Brough
    East Yorkshire
    Secrétaire
    Welton Grange
    Welton
    HU15 1NB Brough
    East Yorkshire
    172413370001
    FISH, Andrew Stuart
    Aberford Road
    Oulton
    LS26 8LD Leeds
    36
    East Yorkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Aberford Road
    Oulton
    LS26 8LD Leeds
    36
    East Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant99181180003
    HEALEY, Edwin Dyson
    West Ella Hall
    West Ella Road West Ella
    HU10 7RP Hull
    East Yorkshire
    Administrateur
    West Ella Hall
    West Ella Road West Ella
    HU10 7RP Hull
    East Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director1798990001
    HEALEY, Paul Dyson
    Spout Hill
    Brantingham
    HU15 1QP Brough
    Brantingham Wold Grange,
    North Humberside
    Administrateur
    Spout Hill
    Brantingham
    HU15 1QP Brough
    Brantingham Wold Grange,
    North Humberside
    EnglandBritishCompany Director7349500004
    STANDISH, Amanda Jayne
    Welton Grange
    Welton
    HU15 1NB Brough
    East Yorkshire
    Administrateur
    Welton Grange
    Welton
    HU15 1NB Brough
    East Yorkshire
    United KingdomBritishPa172278520001
    SWALES, Paul Nigel
    Welton Grange
    Welton
    HU15 1NB Brough
    East Yorkshire
    Administrateur
    Welton Grange
    Welton
    HU15 1NB Brough
    East Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director42213720002
    CROOKS, Michael Clive
    Eppleworth Road,
    Raywell
    HU16 5ZA Cottingham
    Woodhouse Grange, Westfield Road,
    East Yorkshire
    Secrétaire
    Eppleworth Road,
    Raywell
    HU16 5ZA Cottingham
    Woodhouse Grange, Westfield Road,
    East Yorkshire
    BritishSecretary48504730008
    HAYMER, Jonathan
    Ravenscar
    Alvanley Road
    WA6 9PS Helsby
    Cheshire
    Secrétaire
    Ravenscar
    Alvanley Road
    WA6 9PS Helsby
    Cheshire
    British1553510001
    SOVSHELFCO (SECRETARIAL) LIMITED
    PO BOX 8
    Sovereign House South Parade
    LS1 1HQ Leeds
    West Yorkshire
    Secrétaire désigné
    PO BOX 8
    Sovereign House South Parade
    LS1 1HQ Leeds
    West Yorkshire
    900003500001
    CROOKS, Michael Clive
    Eppleworth Road,
    Raywell,
    HU16 5ZA Cottingham
    Woodhouse Grange Westfield Road
    East Yorkshire
    Administrateur
    Eppleworth Road,
    Raywell,
    HU16 5ZA Cottingham
    Woodhouse Grange Westfield Road
    East Yorkshire
    United KingdomBritishSecretary48504730009
    WILLOX, Shaun
    Welton Grange
    Welton
    HU15 1NB Brough
    East Yorkshire
    Administrateur
    Welton Grange
    Welton
    HU15 1NB Brough
    East Yorkshire
    United KingdomBritishFinance Manager And Treasurer99708360002
    SOVSHELFCO (FORMATIONS) LIMITED
    PO BOX 8
    Sovereign House South Parade
    LS1 1HQ Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur désigné
    PO BOX 8
    Sovereign House South Parade
    LS1 1HQ Leeds
    West Yorkshire
    900003490001

    STADIUM PROPERTY ASSET MANAGEMENT LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Insurance policy proceeds assignment
    Créé le 10 juin 2002
    Livré le 17 juin 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies obligations and liabilities due or to become due from neue mitte oberhausen projektentwicklung gmbh & co. (As principal borrower) to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All monies of whatsoever kind payable by the insurers to or for the account of the borrowers arising out of or as a result of the policies including all claims for damages arising out of any breach of any of the policies wher the account means the account number 5804327799 with the agent (sort code 70020270) "the policy proceeds account". See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Ag (As Agent for Itself and the Banks, as Defined)
    Transactions
    • 17 juin 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 août 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 09 juin 1999
    Livré le 19 juin 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    In favour of the chargee all present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor (as defined) and stadium developments limited to each finance party under each finance document (as defined) except for any obligation which, if it were so included, would result in the debenture contravening section 151 of the companies act 1985
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge all its assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hvb Real Estate Capital Limited (The "Facility Agent")
    Transactions
    • 19 juin 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 nov. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 31 oct. 1996
    Livré le 05 nov. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors (as defined) to each finance party under each finance document (as defined) on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bayerische Hypotheken-Und Wechsel-Bank Aktiengesellschaft,London Branch,as Agent and Trusteefor the Finance Parties (As Defined)
    Transactions
    • 05 nov. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 juin 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 21 oct. 1993
    Livré le 10 nov. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility agreement dated 18/10/93
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Bayerische Hypotheken-Und Wechsel-Bank Ag as Agent and Trustee for the Secured Parties
    Transactions
    • 10 nov. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 mars 1996Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 09 nov. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rental assignment
    Créé le 21 oct. 1993
    Livré le 10 nov. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility agreement dated 18/10/93
    Brèves mentions
    All right title interest in and to all spam rental income. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bayerische Hypotheken-Und Wechsel-Bank Ag
    Transactions
    • 10 nov. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 mars 1996Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 09 nov. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of assignment
    Créé le 28 sept. 1993
    Livré le 15 oct. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the security documents (as defined)
    Brèves mentions
    The rents and/or licences and all interest under the terms of the leases. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bayerische Hypotheken-Und Wechsel-Bank Ag
    Transactions
    • 15 oct. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 oct. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of charge
    Créé le 01 juil. 1993
    Livré le 12 juil. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the facility agreement and/or this charge
    Brèves mentions
    Unit 11B retail park parkgate rotherham south yorkshire together with all buildings and fixtures and fittings.
    Personnes ayant droit
    • Bayerische Hypotheken-Und Weschel-Bank Ag
    Transactions
    • 12 juil. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 oct. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of charge
    Créé le 01 juil. 1993
    Livré le 12 juil. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the facility agreement ,the charge and the scl charge
    Brèves mentions
    Unit 11B retail park parkgate rotherham south yorkshire together with all buildings fixtures and fittings.
    Personnes ayant droit
    • Bayerische Hypotheken-Und Wechsel-Bank Ag
    Transactions
    • 12 juil. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 oct. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 31 mars 1993
    Livré le 08 avr. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility agreement of even date
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bayerische Hypotheken-Und Wechsel-Bank Ag
    Transactions
    • 08 avr. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 oct. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignment of rental income
    Créé le 31 mars 1993
    Livré le 08 avr. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement of even date
    Brèves mentions
    By way of assignment the benefit of all rents and/or licence fees or any other sums whatsoever payable under the leases in the nature of rent or licence fees payable. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bayerische Hypotheken-Und Wechsel-Bank Ag
    Transactions
    • 08 avr. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 oct. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 31 mars 1993
    Livré le 08 avr. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility agreement dated 3/11/92 the finance documents (as defined) and/or this charge
    Brèves mentions
    Second fixed charge the personal agreements and covenants by the tenants lessees or licencees under the letting documents and by all guarantors and all security held by the mortgagor. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bayerische Hypotheken-Und Wechsel-Bank Ag
    Transactions
    • 08 avr. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    Charge
    Créé le 31 mars 1993
    Livré le 08 avr. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility agreement dted 3/11/92 the finance documents (as defined) and/or this charge
    Brèves mentions
    Second fixed charge on the personal agreements covenants by the tenants lessees or licencees under the letting documents and by all guarantors and all security held by the mortgagor. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bayerische Hypotheken-Und Wechsel-Bank Ag
    Transactions
    • 08 avr. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 oct. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of assignment
    Créé le 31 mars 1993
    Livré le 08 avr. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the facility agreement, the debenture or otherwise
    Brèves mentions
    The benefit of all rents and/or licence fees or any other sums payable under the leases. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bayerische Hypotheken-Und Wechsel-Bank Ag
    Transactions
    • 08 avr. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 oct. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0