TELECOM DESIGN COMMUNICATIONS LIMITED

TELECOM DESIGN COMMUNICATIONS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTELECOM DESIGN COMMUNICATIONS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02735976
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TELECOM DESIGN COMMUNICATIONS LIMITED ?

    • (7499) /

    Où se situe TELECOM DESIGN COMMUNICATIONS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    5th Floor Ship Canal House
    98 King Street
    M2 4WU Manchester
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de TELECOM DESIGN COMMUNICATIONS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour TELECOM DESIGN COMMUNICATIONS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    16 pages4.71

    Changement d'adresse du siège social de Avnet House Rutherford Close Meadway Stevenage Hertfordshire SG1 2EF United Kingdom le 14 déc. 2010

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 30 nov. 2010

    LRESSP

    Cessation de la nomination de Patrick Zammit en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Peter Bielefeld en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 juil. 2010 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital28 juil. 2010

    État du capital au 28 juil. 2010

    • Capital: GBP 40,000
    SH01

    legacy

    3 pagesMG02

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2009

    5 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de Abacus House Bone Lane Newbury Berkshire RG14 5SF le 19 janv. 2010

    1 pagesAD01

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes établis au 30 sept. 2008

    5 pagesAA

    legacy

    3 pages288a

    legacy

    3 pages288a

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages225

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    3 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Qui sont les dirigeants de TELECOM DESIGN COMMUNICATIONS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    VAN DER ZWALMEN, Anne
    Grimbergen
    Helman De Grimberghelaan 28
    1850
    Belgium
    Secrétaire
    Grimbergen
    Helman De Grimberghelaan 28
    1850
    Belgium
    BelgianBusiness Executive138188190001
    BIRK, David Ralph, Mr.
    East Corrine Drive
    Scottsdale
    Arizona
    12983
    Az 85259
    United States
    Administrateur
    East Corrine Drive
    Scottsdale
    Arizona
    12983
    Az 85259
    United States
    UsaAmericanBusiness Executive136282980001
    SADOWSKI, Raymond John
    13120 East Appaloosa Place
    Scottsdale
    Arizona 85259 Az
    Usa
    Administrateur
    13120 East Appaloosa Place
    Scottsdale
    Arizona 85259 Az
    Usa
    UsaAmericanBusiness Executive143504560001
    ARMOUR, Douglas William
    32a High Street
    KT10 9RT Esher
    Surrey
    Secrétaire
    32a High Street
    KT10 9RT Esher
    Surrey
    British31463000001
    BATEMAN, Andrew
    34 Heath Close
    RG41 2PG Wokingham
    Berkshire
    Secrétaire
    34 Heath Close
    RG41 2PG Wokingham
    Berkshire
    British24432680002
    BIRKETT, Timothy
    13 Saint Clements Road
    BH15 3PB Poole
    Dorset
    Secrétaire
    13 Saint Clements Road
    BH15 3PB Poole
    Dorset
    BritishAccountant63601320001
    BURKE, James Jude
    142 The Avenue
    TW16 5EA Sunbury On Thames
    Middlesex
    Secrétaire
    142 The Avenue
    TW16 5EA Sunbury On Thames
    Middlesex
    British6245890001
    HEFFERNAN, Liam Anthony
    5 Malthouse Meadows
    GU30 7BD Liphook
    Hampshire
    Secrétaire
    5 Malthouse Meadows
    GU30 7BD Liphook
    Hampshire
    BritishAccountant100478700001
    PRIOR, Pauline
    37 Lordsfield Gardens
    Overton
    RG25 3EW Basingstoke
    Hampshire
    Secrétaire
    37 Lordsfield Gardens
    Overton
    RG25 3EW Basingstoke
    Hampshire
    British64776950001
    TEE, William
    11 Moor Road
    BH18 8AZ Broadstone
    Dorset
    Secrétaire
    11 Moor Road
    BH18 8AZ Broadstone
    Dorset
    BritishDirector33486710001
    VAN DER PANT, Gavin Lawrence
    9 Westfield Cottages
    Henley Road
    SL7 2HQ Medmenham
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    9 Westfield Cottages
    Henley Road
    SL7 2HQ Medmenham
    Buckinghamshire
    BritishFinance Director72310190001
    VAN DER PANT, Gavin Lawrence
    9 Westfield Cottages
    Henley Road
    SL7 2HQ Medmenham
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    9 Westfield Cottages
    Henley Road
    SL7 2HQ Medmenham
    Buckinghamshire
    BritishFinance Director72310190001
    ALLEN, Peter Vance
    Buckholm Mill
    TD1 2HB Galashields
    Selkirkshire
    Administrateur
    Buckholm Mill
    TD1 2HB Galashields
    Selkirkshire
    Great BritainBritishDirector3711280004
    BIELEFELD, Peter
    Guckingen
    Im Vordern Boden 25
    65558
    Germany
    Administrateur
    Guckingen
    Im Vordern Boden 25
    65558
    Germany
    GermanyGermanBusiness Executive138187960001
    BURKE, James Jude
    142 The Avenue
    TW16 5EA Sunbury On Thames
    Middlesex
    Administrateur
    142 The Avenue
    TW16 5EA Sunbury On Thames
    Middlesex
    British6245890001
    GRIFFITH JONES, Peetr
    Lockeridge House
    Lockeridge
    SN8 4EL Marlborough
    Wiltshire
    Administrateur
    Lockeridge House
    Lockeridge
    SN8 4EL Marlborough
    Wiltshire
    BritishFinance Director99584170001
    GRIFFITH-JONES, Peter Laugharne
    Lockeridge House
    Lockeridge
    SN8 4EL Marlborough
    Wiltshire
    Administrateur
    Lockeridge House
    Lockeridge
    SN8 4EL Marlborough
    Wiltshire
    EnglandBritishFinance Director48649690001
    HEFFERNAN, Liam Anthony
    5 Malthouse Meadows
    GU30 7BD Liphook
    Hampshire
    Administrateur
    5 Malthouse Meadows
    GU30 7BD Liphook
    Hampshire
    United KingdomBritishAccountant100478700001
    KENT, Martin Robert
    Ridgebourne
    Front Street, East Garston
    RG17 7EU Hungerford
    Berkshire
    Administrateur
    Ridgebourne
    Front Street, East Garston
    RG17 7EU Hungerford
    Berkshire
    BritishChief Executive6391620007
    SANDYS, Jeremy Terence
    Tarn Cottage Tarn Court
    The Maultway
    GU15 1PS Camberley
    Surrey
    Administrateur
    Tarn Cottage Tarn Court
    The Maultway
    GU15 1PS Camberley
    Surrey
    United KingdomBritishDirector6245900002
    TEE, William
    87 Higher Blandford Road
    BH18 9AE Broadstone
    Dorset
    Administrateur
    87 Higher Blandford Road
    BH18 9AE Broadstone
    Dorset
    BritishDirector33486710002
    VAN DER PANT, Gavin Lawrence
    9 Westfield Cottages
    Henley Road
    SL7 2HQ Medmenham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    9 Westfield Cottages
    Henley Road
    SL7 2HQ Medmenham
    Buckinghamshire
    EnglandBritishFinance Director72310190001
    VENUS, David Anthony
    86 Park Road
    KT2 5JZ Kingston Upon Thames
    Surrey
    Administrateur désigné
    86 Park Road
    KT2 5JZ Kingston Upon Thames
    Surrey
    United KingdomBritish900007290001
    ZAMMIT, Patrick Laurent
    Avenue Du Manoir 38
    B-1180 Brussels
    1180
    Belgium
    Administrateur
    Avenue Du Manoir 38
    B-1180 Brussels
    1180
    Belgium
    BelgiumFrenchBusiness Executive114841080001

    TELECOM DESIGN COMMUNICATIONS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 10 mars 2006
    Livré le 15 mars 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 15 mars 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 mai 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Charge over credit balances
    Créé le 17 août 2000
    Livré le 29 août 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to a letter of credit dated 7 august 2000 in favour of emtac technology corporation taiwan for us$104,000
    Brèves mentions
    The sum of £70,270 together with interest accrued now or to be held by national westminster bank PLC on an account numbered 79141323 and earmarked or designated by reference to the company.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 29 août 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 sept. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over credit balances
    Créé le 17 août 2000
    Livré le 29 août 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to a letter of credit dated 11 july 2000 for us$ 53,200 in favour of emtac technology corporation taiwan
    Brèves mentions
    The sum of £36,000 together with interest accrued now or to be held by national westminster bank PLC on an account numbered 79137393 and earmarked or designated by reference to the company.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 29 août 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 sept. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rental deposit deed
    Créé le 26 sept. 1996
    Livré le 28 sept. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease of even date
    Brèves mentions
    The sum of £15,916.66 paid into a separate designated deposit account on behalf of the chargee at the royal bank of scotland.
    Personnes ayant droit
    • Sun Life Assurance Company of Canada
    Transactions
    • 28 sept. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 déc. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    TELECOM DESIGN COMMUNICATIONS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    07 oct. 2011Dissolved on
    30 nov. 2010Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Mark Terence Getliffe
    Ship Canal House 98 King Street
    M2 4WU Manchester
    practitioner
    Ship Canal House 98 King Street
    M2 4WU Manchester
    Diane Elizabeth Hill
    Ship Canal House 98 King Street
    M2 4WU Manchester
    practitioner
    Ship Canal House 98 King Street
    M2 4WU Manchester

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0