ALMOR LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéALMOR LIMITED
    Statut de la sociétéEn administration
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02736280
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ALMOR LIMITED ?

    • fabrication d'autres produits métalliques n.c.a. (25990) / Industries manufacturières
    • fabrication de fours, de fourneaux et de brûleurs de four (28210) / Industries manufacturières
    • Activités de conseil en gestion autres que la gestion financière (70229) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe ALMOR LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Forvis Mazars Llp 1st Floor Two
    Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ALMOR LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    WELDING AND BRAZING DEVELOPMENTS (CANNOCK) LIMITED18 sept. 199218 sept. 1992
    OPTIONQUICK LIMITED31 juil. 199231 juil. 1992

    Quels sont les derniers comptes de ALMOR LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le30 sept. 2021
    Date d'échéance des prochains comptes30 juin 2022
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2020

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour ALMOR LIMITED ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au19 juil. 2022
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation02 août 2022
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au19 juil. 2021
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour ALMOR LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    29 pagesAM10

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    44 pagesAM10

    Changement d'adresse du siège social de 1st Floor Two Chamberlain Square Birmingham B3 3AX à Forvis Mazars Llp 1st Floor Two Chamberlain Square Birmingham B3 3AX le 24 juil. 2024

    3 pagesAD01

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    3 pagesAM19

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    33 pagesAM10

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    36 pagesAM10

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    3 pagesAM19

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    28 pagesAM10

    Avis d'approbation réputée des propositions

    4 pagesAM06

    Déclaration des affaires avec le formulaire AM02SOA/AM02SOC

    19 pagesAM02

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    52 pagesAM03

    Changement d'adresse du siège social de Almor Ltd Daleside Road Nottingham Nottinghamshire NG2 3GJ à 1st Floor Two Chamberlain Square Birmingham B3 3AX le 22 août 2022

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    3 pagesAM01

    Statuts

    10 pagesMA

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de modification des droits ou de la dénomination des actions

    RES12
    incorporation

    Résolution des statuts

    RES01

    Changement de nom ou de désignation de la catégorie d'actions

    2 pagesSH08

    Comptes pour une petite entreprise établis au 30 sept. 2020

    11 pagesAA

    Cessation de la nomination de Christopher John Allum en tant que directeur le 26 août 2021

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Thomas Christopher Allum en tant qu'administrateur le 26 août 2021

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 19 juil. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 19 juil. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 30 sept. 2019

    17 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 19 juil. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 30 sept. 2018

    16 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 19 juil. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Qui sont les dirigeants de ALMOR LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CLARKE, Patricia Jill
    109 First Avenue
    NG4 1PD Carlton
    Nottingham
    Secrétaire
    109 First Avenue
    NG4 1PD Carlton
    Nottingham
    British80472650001
    ALLUM, Thomas Christopher
    Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Forvis Mazars Llp 1st Floor Two
    Administrateur
    Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Forvis Mazars Llp 1st Floor Two
    EnglandBritishCompany Director286978610001
    LEADBETTER, Martin John
    Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Forvis Mazars Llp 1st Floor Two
    Administrateur
    Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Forvis Mazars Llp 1st Floor Two
    EnglandBritishCompany Director202953130001
    MORRIS, John
    208 Sutton Road
    WS5 3AH Walsall
    West Midlands
    Secrétaire
    208 Sutton Road
    WS5 3AH Walsall
    West Midlands
    BritishAccountant20726430001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    WINSEC LIMITED
    3rd Floor Windsor House
    3 Temple Row
    B2 5LF Birmingham
    West Midlands
    Secrétaire désigné
    3rd Floor Windsor House
    3 Temple Row
    B2 5LF Birmingham
    West Midlands
    900001080001
    ALLUM, Christopher John, Dr
    Almor Ltd
    Daleside Road
    NG2 3GJ Nottingham
    Nottinghamshire
    Administrateur
    Almor Ltd
    Daleside Road
    NG2 3GJ Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritishCompany Director3754100001
    MORRIS, John
    208 Sutton Road
    WS5 3AH Walsall
    West Midlands
    Administrateur
    208 Sutton Road
    WS5 3AH Walsall
    West Midlands
    BritishAccountant20726430001
    PRICE, William Frederick Ernest
    Willowbrook 20 High Street
    Wheatley
    OX33 1XX Oxford
    Oxfordshire
    Administrateur
    Willowbrook 20 High Street
    Wheatley
    OX33 1XX Oxford
    Oxfordshire
    United KingdomBritishAccountant24187260001
    WILKINS, Philip
    152 Comberford Road
    B79 8PG Tamworth
    Staffordshire
    Administrateur
    152 Comberford Road
    B79 8PG Tamworth
    Staffordshire
    BritishSales Director36164940001
    WOODCRAFT, David George
    The Grove House Tanners Green Lane
    Earlswood
    B94 5JT Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    The Grove House Tanners Green Lane
    Earlswood
    B94 5JT Solihull
    West Midlands
    BritishCompany Director35524360001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur désigné
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001
    WINDSOR HOUSE NOMINEES LIMITED
    3rd Floor Windsor House
    3 Temple Row
    B2 5LF Birmingham
    West Midlands
    Administrateur désigné
    3rd Floor Windsor House
    3 Temple Row
    B2 5LF Birmingham
    West Midlands
    900001070001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur ALMOR LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Dr Christopher John Allum
    Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Forvis Mazars Llp 1st Floor Two
    30 juin 2016
    Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Forvis Mazars Llp 1st Floor Two
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    ALMOR LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 04 avr. 2014
    Livré le 11 avr. 2014
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 11 avr. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    All assets debenture
    Créé le 05 oct. 2011
    Livré le 10 oct. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 10 oct. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 16 févr. 2004
    Livré le 27 févr. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 27 févr. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 sept. 2014L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré de la charge (MR05)
    • 13 mai 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 14 mai 2003
    Livré le 29 mai 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All undertaking assets and rights.
    Personnes ayant droit
    • Rolled Alloys LTD
    Transactions
    • 29 mai 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 oct. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    All assets debenture deed
    Créé le 26 mars 2003
    Livré le 29 mars 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 29 mars 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 avr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage debenture
    Créé le 26 oct. 2000
    Livré le 01 nov. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 01 nov. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 févr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture deed
    Créé le 01 juil. 1998
    Livré le 09 juil. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 09 juil. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 févr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    All assets debenture deed
    Créé le 01 juil. 1998
    Livré le 08 juil. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 08 juil. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 oct. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 01 juil. 1998
    Livré le 04 juil. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company (formerly known as welding & brazing developments (cannock) limited) to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charge on all estates and interest in the property with all buildings fixtures (including trade and other fixtures) fixed plant machinery: f/h johnson house norton green lane norton cranes staffordshire t/n SF203472.
    Personnes ayant droit
    • 3I Group PLC
    Transactions
    • 04 juil. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 févr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A legal charge by way of statutory mortgage
    Créé le 19 juil. 1997
    Livré le 30 juil. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £20,000 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Number 5 factory heath road darlaston wednesbury west midlands t/n WM378424.
    Personnes ayant droit
    • Terence Stanford and Daniel Gordon Griffiths
    Transactions
    • 30 juil. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 juil. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattels mortgage
    Créé le 10 mars 1997
    Livré le 13 mars 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    20 ton double overhead travelling crane maker reddish stockport branded wharton 10 ton double girder overhead travelling crane maker koney agent weightlifter cranes smethwick.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 13 mars 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 oct. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 10 mars 1997
    Livré le 13 mars 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The property at johnson house, norton green lane, cannock, cannock chase, staffordshire with the benefit of all rights, licences, guarantees, rent deposits contracts, deeds, undertakings and warranties relating to the property; any shares or membership rights in any management company for the property; any goodwill of any business from time to time carried on at the property; any rental and other money payable under any lease, licence or other interest created in respect of the property; and all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 13 mars 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 oct. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 10 mars 1997
    Livré le 13 mars 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The property at unit 5 heath road, darlaston wednesbury west midlands with the benefit of all rights, licences, guarantees, rent deposits contracts, deeds, undertakings and warranties relating to the property; any shares or membership rights in any management company for the property; any goodwill of any business from time to time carried on at the property; any rental and other money payable under any lease, licence or other interest created in respect of the property; and all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 13 mars 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 oct. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed equitable charge
    Créé le 06 oct. 1995
    Livré le 11 oct. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of first equitable charge all book debts invoice debts accounts notes bills the subject of a factoring agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Griffin Factors Limited
    Transactions
    • 11 oct. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 oct. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 03 sept. 1993
    Livré le 08 sept. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • 3I Group PLC
    Transactions
    • 08 sept. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 01 oct. 1992
    Livré le 07 oct. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over goodwill bookdebts and patents. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 07 oct. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 oct. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 18 sept. 1992
    Livré le 24 sept. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over goodwill bookdebts and patents. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 24 sept. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 juil. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    ALMOR LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    08 juil. 2022Administration started
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Rebecca Jane Dacre
    First Floor 2 Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    practitioner
    First Floor 2 Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Scott Christian Bevan
    Mazars Llp First Floor, Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    practitioner
    Mazars Llp First Floor, Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0