TELEVISION SUPPORT SERVICES LIMITED

TELEVISION SUPPORT SERVICES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTELEVISION SUPPORT SERVICES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02743032
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TELEVISION SUPPORT SERVICES LIMITED ?

    • Activités de production de programmes de télévision (59113) / Information et communication
    • Création artistique (90030) / Activités artistiques, de loisirs et de divertissement

    Où se situe TELEVISION SUPPORT SERVICES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Hill House 1
    Little New Street
    EC4A 3TR London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de TELEVISION SUPPORT SERVICES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 juil. 2011

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour TELEVISION SUPPORT SERVICES LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour TELEVISION SUPPORT SERVICES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 12 déc. 2015

    20 pages4.68

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    22 pages4.71

    Résolution d'insolvabilité

    Resolution insolvency:res re liquidators account
    1 pagesLIQ MISC RES

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 12 déc. 2014

    14 pages4.68

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée

    2 pagesAD02

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 12 déc. 2013

    15 pages4.68

    Changement d'adresse du siège social de * Maple House 149 Tottenham Court Road London W1T 7NF* le 28 déc. 2012

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Résolution d'insolvabilité

    Resolution insolvency:special resolution ;- "in specie"
    2 pagesLIQ MISC RES

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation

    LRESSP

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Approve the implementation of those aspects of the simplification excise relating to the company and other company business 11/12/2012
    RES13

    Période comptable actuelle prolongée du 31 juil. 2012 au 31 déc. 2012

    1 pagesAA01

    Comptes annuels établis au 31 juil. 2011

    13 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Christian Thieme le 24 mars 2012

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Christian Thieme le 24 mars 2012

    2 pagesCH01

    Nomination de Mr Christian Thieme en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Geoffrey Walker en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Sukhjiwan Kaur Tung en tant que secrétaire

    3 pagesAP03

    Nomination de Mr Geoffrey Hulbert Walker en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Nomination de David Allmark en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Nomination de Edward Laurence Catchpole en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Jeffrey Dunn en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Sangeeta Desai en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de TELEVISION SUPPORT SERVICES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SALVO, Joseph Pasqualino
    Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House 1
    Secrétaire
    Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House 1
    Other135617080001
    TUNG, Sukhjiwan Kaur
    Vanwall Business Group
    Vanwall Road
    SL6 4UB Maidenhead
    Mattel House
    Berkshire
    Secrétaire
    Vanwall Business Group
    Vanwall Road
    SL6 4UB Maidenhead
    Mattel House
    Berkshire
    British167011710001
    ALLMARK, David
    Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House 1
    Administrateur
    Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House 1
    United StatesBritish166738850001
    CATCHPOLE, Edward Laurence
    Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House 1
    Administrateur
    Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House 1
    United KingdomBritish166738690001
    THIEME, Christian
    Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House 1
    Administrateur
    Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House 1
    EnglandGerman167467740002
    BYRNE, Katharine Helen
    The Old Coach House
    Stockbridge Road
    SO51 0NE Timsbury
    Romsey
    Secrétaire
    The Old Coach House
    Stockbridge Road
    SO51 0NE Timsbury
    Romsey
    British76551670002
    BYRNE, Katharine Helen
    The Old Coach House
    Stockbridge Road
    SO51 0NE Timsbury
    Romsey
    Secrétaire
    The Old Coach House
    Stockbridge Road
    SO51 0NE Timsbury
    Romsey
    British76551670002
    HILTON, Timothy James
    6 Ashton Cross
    East Wellow
    SO51 6AY Romsey
    Hampshire
    Secrétaire
    6 Ashton Cross
    East Wellow
    SO51 6AY Romsey
    Hampshire
    British45519470002
    PEARCE, Simon Marshall
    5 Oaklands Avenue
    KT10 8HX Esher
    Surrey
    Secrétaire
    5 Oaklands Avenue
    KT10 8HX Esher
    Surrey
    British38325900002
    ROWLAND, Janet Lesley
    2 Smith Terrace
    SW3 4DL London
    Secrétaire
    2 Smith Terrace
    SW3 4DL London
    British83715050001
    URIE, Suzanne
    Woodlands
    Ulcombe Road Langley
    ME17 3JE Maidstone
    Kent
    Secrétaire
    Woodlands
    Ulcombe Road Langley
    ME17 3JE Maidstone
    Kent
    British30145210002
    P S SECRETARIES LIMITED
    Suite One Second Floor
    1/4 Christina Street
    EC2A 4PA London
    Secrétaire désigné
    Suite One Second Floor
    1/4 Christina Street
    EC2A 4PA London
    900001620001
    BIRRELL, Nigel Norman
    40 St John's Park
    Blackheath
    SE3 7JH London
    Administrateur
    40 St John's Park
    Blackheath
    SE3 7JH London
    British72014940002
    CAMINADA, Charles Jerome
    56 Lamont Road
    SW10 0HX London
    Administrateur
    56 Lamont Road
    SW10 0HX London
    EnglandBritish114598050001
    DESAI, Sangeeta
    Maple House
    149 Tottenham Court Road
    W1T 7NF London
    Administrateur
    Maple House
    149 Tottenham Court Road
    W1T 7NF London
    United KingdomBritish80563180001
    DUNN, Jeffrey Doubleday
    Maple House
    149 Tottenham Court Road
    W1T 7NF London
    Administrateur
    Maple House
    149 Tottenham Court Road
    W1T 7NF London
    United StatesAmerican129211540001
    FALZON, Charles John
    R R 21
    Acton
    L7J 2L8 Ontario
    Canada
    Administrateur
    R R 21
    Acton
    L7J 2L8 Ontario
    Canada
    Canadian54681970001
    HARRIS, William Stuart
    Ash Lea Dixons Lane
    Broughton
    SO20 8AT Stockbridge
    Hampshire
    Administrateur
    Ash Lea Dixons Lane
    Broughton
    SO20 8AT Stockbridge
    Hampshire
    United KingdomBritish1444030002
    HILTON, Timothy James
    6 Ashton Cross
    East Wellow
    SO51 6AY Romsey
    Hampshire
    Administrateur
    6 Ashton Cross
    East Wellow
    SO51 6AY Romsey
    Hampshire
    British45519470002
    LAWES, Robert Ian
    9 Finlay Street
    SW6 6HE London
    Administrateur
    9 Finlay Street
    SW6 6HE London
    British24399410004
    PEARCE, David
    9 Saint Albans Avenue
    W4 5LL London
    Administrateur
    9 Saint Albans Avenue
    W4 5LL London
    EnglandBritish89691560001
    RICKETTS, Timothy Walker
    49 Lakewood Road
    SO53 1EU Chandlers Ford
    Hampshire
    Administrateur
    49 Lakewood Road
    SO53 1EU Chandlers Ford
    Hampshire
    EnglandBritish119035710001
    STEINBERG, Bruce David
    58 Frognal
    NW3 6XG London
    Administrateur
    58 Frognal
    NW3 6XG London
    United KingdomAmerican107396950001
    SULLIVAN, Sean Stephen
    Maple House
    149 Tottenham Court Road
    W1T 7NF London
    Administrateur
    Maple House
    149 Tottenham Court Road
    W1T 7NF London
    United StatesAmerican135856320001
    URIE, Peter
    Woodlands
    Ulcombe Road, Langley
    ME17 3JE Maidstone
    Kent
    Administrateur
    Woodlands
    Ulcombe Road, Langley
    ME17 3JE Maidstone
    Kent
    British66697340001
    WALKER, Geoffrey Hulbert
    Vanwall Business Park
    Vanwall Road
    SL6 4UB Maidenhead
    Mattel House
    Berkshire
    Administrateur
    Vanwall Business Park
    Vanwall Road
    SL6 4UB Maidenhead
    Mattel House
    Berkshire
    United KingdomAmerican158295080001
    WEIGHT, James Dominic
    11 Courtney Place
    KT11 2BE Cobham
    Surrey
    Administrateur
    11 Courtney Place
    KT11 2BE Cobham
    Surrey
    EnglandBritish73750450005
    P S NOMINEES LIMITED
    Suite One Second Floor
    1/4 Christina Street
    EC2A 4PA London
    Administrateur désigné
    Suite One Second Floor
    1/4 Christina Street
    EC2A 4PA London
    900001610001

    TELEVISION SUPPORT SERVICES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Second lien accession deed supplemental to the second lien debenture dated 23 november 2010 and
    Créé le 23 nov. 2010
    Livré le 10 déc. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee and/or the finance parties and/or any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Cantor Fitzgerald Securities
    Transactions
    • 10 déc. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 02 févr. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Security accession deed
    Créé le 23 nov. 2010
    Livré le 03 déc. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the administrative agent and/or the finance parties and/or any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All material property,fixed charge investments,book debts,intellectual property,bank balances see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Merrill Lynch Capital Corporation
    Transactions
    • 03 déc. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 02 févr. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 27 juil. 2001
    Livré le 14 août 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All obligations due or to become due from the company to the chargee as trustee for the secured parties (as defined) on the terms and conditions set out in the facility agreement (the "security trustee") or any of the other secured parties under or pursuant to the finance documents (as defined) (including the debenture) including any liability in respect of further advances made under the finance documents and on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 14 août 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 nov. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 19 mai 2000
    Livré le 31 mai 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 31 mai 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 oct. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    TELEVISION SUPPORT SERVICES LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    13 déc. 2012Commencement of winding up
    18 avr. 2016Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Christopher Richard Frederick Day
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    practitioner
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Stephen Roland Browne
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    practitioner
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0