NIKE MERCURIAL II LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéNIKE MERCURIAL II LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02744719
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de NIKE MERCURIAL II LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe NIKE MERCURIAL II LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Nike Camberwell Way
    Doxford International Business Park
    SR3 3XN Sunderland
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de NIKE MERCURIAL II LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    UMBRO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED02 juin 200002 juin 2000
    UMBRO EUROPE (HOLDINGS) LIMITED31 déc. 199631 déc. 1996
    UMBRO EUROPE LIMITED01 déc. 199301 déc. 1993
    UMBRO INTERNATIONAL (EUROPE) LIMITED24 févr. 199324 févr. 1993
    UMBRO INTERNATIONAL EUROPE LIMITED03 nov. 199203 nov. 1992
    BROOMCO (591) LIMITED03 sept. 199203 sept. 1992

    Quels sont les derniers comptes de NIKE MERCURIAL II LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mai 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour NIKE MERCURIAL II LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour NIKE MERCURIAL II LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Déclaration annuelle jusqu'au 29 août 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital26 sept. 2013

    État du capital au 26 sept. 2013

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Comptes établis au 31 mai 2013

    9 pagesAA

    Certificat de changement de nom

    Company name changed umbro international holdings LIMITED\certificate issued on 10/07/13
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name10 juil. 2013

    Changement de nom" par résolution

    NM01
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Nomination de Mr Evan Scott Reynolds en tant que secrétaire le 29 mai 2013

    1 pagesAP03

    Changement d'adresse du siège social de Umbro House, Lakeside Cheadle Royal Business Park Cheadle Cheshire SK8 3GQ le 29 mai 2013

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de David Andrew Hare en tant que secrétaire le 29 mai 2013

    1 pagesTM02

    Comptes annuels établis au 31 mai 2012

    19 pagesAA

    Nomination de Evan Scott Reynolds en tant qu'administrateur le 03 déc. 2012

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Gary James Brown en tant que directeur le 03 déc. 2012

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 29 août 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    legacy

    2 pagesSH20

    legacy

    2 pagesCAP-SS

    État du capital au 22 mai 2012

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    Résolutions

    Resolutions
    4 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Comptes annuels établis au 31 mai 2011

    14 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 29 août 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Cessation de la nomination de James Allaker en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Eunan Mclaughlin en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 29 août 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Grant Winston Hanson le 29 août 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire David Andrew Hare le 29 août 2010

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Gary James Brown le 29 août 2010

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 31 mai 2010

    12 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de NIKE MERCURIAL II LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    REYNOLDS, Evan Scott
    Camberwell Way
    Doxford International Business Park
    SR3 3XN Sunderland
    Nike
    England
    Secrétaire
    Camberwell Way
    Doxford International Business Park
    SR3 3XN Sunderland
    Nike
    England
    178624920001
    HANSON, Grant Winston
    Camberwell Way
    Doxford International Business Park
    SR3 3XN Sunderland
    Nike
    England
    Administrateur
    Camberwell Way
    Doxford International Business Park
    SR3 3XN Sunderland
    Nike
    England
    United StatesAmericanDirector128634930001
    REYNOLDS, Evan Scott
    Camberwell Way
    Doxford International Business Park
    SR3 3XN Sunderland
    Nike
    England
    Administrateur
    Camberwell Way
    Doxford International Business Park
    SR3 3XN Sunderland
    Nike
    England
    United StatesAmericanLegal Counsel174461900001
    CAMPBELL JNR, John M
    1 Petiver Lane
    Greenville
    South Carolina 29605
    United States
    Secrétaire
    1 Petiver Lane
    Greenville
    South Carolina 29605
    United States
    British31126770001
    DARWIN, Andrew David
    76 Ivy Park Road Ranmoor
    S10 3LD Sheffield
    South Yorkshire
    Secrétaire
    76 Ivy Park Road Ranmoor
    S10 3LD Sheffield
    South Yorkshire
    British14246940002
    ELLISON, Stephanie Joy
    Umbro International Limited
    PO BOX 33 Dallimore Road
    M23 9GJ Roundthorn Industrial Estate
    Manchester
    Secrétaire
    Umbro International Limited
    PO BOX 33 Dallimore Road
    M23 9GJ Roundthorn Industrial Estate
    Manchester
    British35963700001
    ELLISON, Stephanie Joy
    26 The Cobbles
    Cuddington
    CW8 2XH Northwich
    Cheshire
    Secrétaire
    26 The Cobbles
    Cuddington
    CW8 2XH Northwich
    Cheshire
    BritishCompany Secretary63214420001
    HARE, David Andrew
    Umbro House, Lakeside
    Cheadle Royal Business Park
    SK8 3GQ Cheadle
    Cheshire
    Secrétaire
    Umbro House, Lakeside
    Cheadle Royal Business Park
    SK8 3GQ Cheadle
    Cheshire
    British94574310001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Secrétaire désigné
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    900003810001
    ALLAKER, James
    Umbro House, Lakeside
    Cheadle Royal Business Park
    SK8 3GQ Cheadle
    Cheshire
    Administrateur
    Umbro House, Lakeside
    Cheadle Royal Business Park
    SK8 3GQ Cheadle
    Cheshire
    EnglandBritishDirector116430430001
    BIRD III, Lewis Leo
    6191 Sw Wilhelm Road
    Tualatin
    Or 97062
    Usa
    Administrateur
    6191 Sw Wilhelm Road
    Tualatin
    Or 97062
    Usa
    United StatesDirector125383590001
    BROWN, Gary James
    Umbro House, Lakeside
    Cheadle Royal Business Park
    SK8 3GQ Cheadle
    Cheshire
    Administrateur
    Umbro House, Lakeside
    Cheadle Royal Business Park
    SK8 3GQ Cheadle
    Cheshire
    EnglandBritishDirector125196870001
    COOK, Matthew Adrian
    Via Scornetta
    San Lazzaro Di Savena
    Bologna
    31
    Italy
    Administrateur
    Via Scornetta
    San Lazzaro Di Savena
    Bologna
    31
    Italy
    BritishBusiness Executive128768440001
    CORBIDGE, Mark Andrew
    1 Hurlingham Square
    SW6 3DZ London
    Administrateur
    1 Hurlingham Square
    SW6 3DZ London
    EnglandBritishCompany Director55506050001
    DINGES, Gregory Clark
    Terrace Drive
    97034 Lake Oswego
    907
    Oregon
    Usa
    Administrateur
    Terrace Drive
    97034 Lake Oswego
    907
    Oregon
    Usa
    AmericanDirector128857410001
    DUCKWORTH, Allan
    18 Firbank
    Church Park
    PR7 6HP Euxton
    Lancashire
    Administrateur
    18 Firbank
    Church Park
    PR7 6HP Euxton
    Lancashire
    EnglandBritishBusiness Administrator50488440001
    HARE, David Andrew
    12 Clifton Avenue
    M14 6UB Manchester
    Lancashire
    Administrateur
    12 Clifton Avenue
    M14 6UB Manchester
    Lancashire
    EnglandBritishDirector94574310001
    HATFIELD, Alan
    9 Cornfield
    SK15 2UA Stalybridge
    Cheshire
    Administrateur
    9 Cornfield
    SK15 2UA Stalybridge
    Cheshire
    BritishBusiness Administrator62250740001
    KENYON, Peter Francis
    24 Northumberland Place
    W2 5BS London
    Administrateur
    24 Northumberland Place
    W2 5BS London
    BritishDirector95799140001
    MAKIN, Steve Richard
    4 Shortsill Lane
    Coneythorpe
    HG5 0RL Knaresborough
    North Yorkshire
    Administrateur
    4 Shortsill Lane
    Coneythorpe
    HG5 0RL Knaresborough
    North Yorkshire
    United KingdomBritishCeo133477340001
    MCGUIGAN, Peter
    Green Walk
    Bowdon
    WA14 2SN Altrincham
    Telfa House
    Cheshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Green Walk
    Bowdon
    WA14 2SN Altrincham
    Telfa House
    Cheshire
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director136211350001
    MCLAUGHLIN, Eunan Patrick
    Umbro House, Lakeside
    Cheadle Royal Business Park
    SK8 3GQ Cheadle
    Cheshire
    Administrateur
    Umbro House, Lakeside
    Cheadle Royal Business Park
    SK8 3GQ Cheadle
    Cheshire
    NetherlandsIrishDirector146619970001
    MONAGHAN, Mark
    26 Beaufort Avenue
    M33 3WL Sale
    Cheshire
    Administrateur
    26 Beaufort Avenue
    M33 3WL Sale
    Cheshire
    BritishBusiness Administrator48690170001
    PRESTON, Steven
    Yew Tree Barn
    Yew Tree Farm Yew Tree Lane
    WA4 4QZ Appleton Thorn
    Cheshire
    Administrateur
    Yew Tree Barn
    Yew Tree Farm Yew Tree Lane
    WA4 4QZ Appleton Thorn
    Cheshire
    Northern IrelandBritishBusiness Administrator87165990001
    PROTHERO, Martin
    2 Juniper Court
    CH2 3EH Hoole
    Cheshire
    Administrateur
    2 Juniper Court
    CH2 3EH Hoole
    Cheshire
    BritishBusiness Administrator106133480001
    STONE, IV, Eugene Earl
    18 Persimmon Lane
    Greenville
    South Carolina 29609
    Usa
    Administrateur
    18 Persimmon Lane
    Greenville
    South Carolina 29609
    Usa
    AmericanDirector46647900001
    WEST, John Joseph
    Crows Nest
    GU25 4QN Virginia Water
    Surrey
    Administrateur
    Crows Nest
    GU25 4QN Virginia Water
    Surrey
    BritishCompany Director631130001
    DLA NOMINEES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Administrateur désigné
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    900003800001

    NIKE MERCURIAL II LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Guarantee & debenture
    Créé le 28 avr. 2004
    Livré le 06 mai 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the finance parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    Transactions
    • 06 mai 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 juil. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 23 avr. 1999
    Livré le 05 mai 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the finance documents (as defined) and this debenture
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bny International Limited,as "Trustee" (As Defined)
    Transactions
    • 05 mai 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 août 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 09 avr. 1997
    Livré le 16 avr. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of each loan document to which the chargor is a party except for any obligation which, if it were so included, would result in the deed contravening section 151 of the companies act 1985
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of America N.T. & S.A.(As Security Agent and Trustee for the Finance Parties )
    Transactions
    • 16 avr. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 mai 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over shares
    Créé le 31 août 1995
    Livré le 15 sept. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    All dividends and interest or other distributions on all stocks shares bonds and securities specified in the first schedule to the charge. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The First National Bank of Bostonas Agent for the Banks (As Defined)
    Transactions
    • 15 sept. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 juin 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 31 août 1995
    Livré le 15 sept. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The First National Bank of Bostonas Agent for the Banks (As Defined)
    Transactions
    • 15 sept. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 juin 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignment of contract monies
    Créé le 30 nov. 1993
    Livré le 17 déc. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or umbro international limited now k/a umbro U.K.limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Assignment of all monies due under the contract dated 24TH august 1993. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 17 déc. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 nov. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Floating charge
    Créé le 30 nov. 1993
    Livré le 17 déc. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Floating charge over the undertaking and all property and assets present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 17 déc. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 mai 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 30 nov. 1993
    Livré le 02 déc. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land hereditaments and premises k/a land on the west side of rossfield road rossmore trading estate ellesmere port cheshire t/n CH303293 land lying to the south west of hulley road macclesfield cheshire CH123396 plot 6 hurdsfield industrial estate macclesfield CH216273 and land at hulley road hurdsfield industr ial estate CH303292 with all fixtures and fittings. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 02 déc. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 mai 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 15 juin 1993
    Livré le 18 juin 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from umbro international limited and its subsidiaries to the chargee as agent and trustee for the banks under the terms of the revolving credit agreement dated 14 june 1993 or the other loan documents or the collateral instruments
    Brèves mentions
    (A)properties.(b)plant and machinery.(c)securities.(d)debts.(e)insurance(f)intangible property. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The First National Bank of Bostonas Agent and Trustee for the Banks
    Transactions
    • 18 juin 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 juin 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A memorandum of deposit and charge over securities
    Créé le 14 janv. 1993
    Livré le 25 janv. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys and other liabilities in excess of $4,500,000 due owing or incurred by stone manufacturing co. To the chargee (as agent and trustee for the lenders) or the lenders (as defined) pursuant to an amended and restated loan and security agreement dated 12TH january 1993 (as may be further amended or restated from time to time) and all other monies due pursuant to the charge.
    Brèves mentions
    160,000 ordinary shares of £1 each in the issued share capital of the company and/or all stocks,shares,bonds,debentures,certificates of deposit and other securities of any kind.please see doc M348C for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bancboston Financial Companyas Agent and Trustee for the Lenders
    Transactions
    • 25 janv. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 juin 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 30 sept. 1992
    Livré le 03 oct. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that f/h land and and buildings k/as 63 union street stockport greater manchester.t/no.gm 490382 by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant,machinery and fixtures and fittings,furniture,equipment,implements and utensils now and in the future at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 03 oct. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 août 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 30 sept. 1992
    Livré le 03 oct. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that l/h land on the west side of rossfield road rossmore trading estate,ellesmere port ellesmere port and neston,cheshire.t/no.ch 303293.by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant,machinery and fixtures and fittings,furniture,equipment,implements and utensils now and in the future at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 03 oct. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 août 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 30 sept. 1992
    Livré le 03 oct. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that f/h land and buildings k/as plot 6 hurdsfield industrial estate macclesfield cheshire.t/no. Ch 216273.by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant,machinery and fixtures and fittings,furniture,equipment,implements & utensils now and in the future at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 03 oct. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 août 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 30 sept. 1992
    Livré le 03 oct. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that f/h land at hulley road hurdsfield industrial estate macclesfield cheshire.t/nos.CH123396 and CH303292.by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property described above and the plant,machinery & fixtures and fittings,furniture,equipment,implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 03 oct. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 août 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0