MIX 96 LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | MIX 96 LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 02747321 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe MIX 96 LIMITED ?
| Adresse du siège social | Media House Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6EA Peterborough England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de MIX 96 LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2020 |
Quels sont les derniers dépôts pour MIX 96 LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||||||||||
Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 déc. 2020 | 8 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 05 sept. 2021 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
legacy | 46 pages | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 1 pages | AGREEMENT2 | ||||||||||
legacy | 3 pages | GUARANTEE2 | ||||||||||
Période comptable précédente prolongée du 30 sept. 2020 au 31 déc. 2020 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 30 sept. 2019 | 9 pages | AA | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
État du capital au 02 oct. 2020
| 3 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 14 sept. 2020
| 3 pages | SH01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 05 sept. 2020 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 20 août 2020
| 3 pages | SH01 | ||||||||||
Nomination de Bauer Group Secretariat Ltd en tant que secrétaire le 20 août 2020 | 2 pages | AP04 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Andrew Richard Preece en tant que directeur le 20 août 2020 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Max Richard Hailey en tant que directeur le 20 août 2020 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Andrew Preece en tant que secrétaire le 20 août 2020 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Statuts | 11 pages | MA | ||||||||||
Nomination de Mrs Deidre Ann Ford en tant qu'administrateur le 20 avr. 2020 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mrs Sarah Jane Vickery en tant qu'administrateur le 20 avr. 2020 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de MIX 96 LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAUER GROUP SECRETARIAT LTD | Secrétaire | Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6EA Peterborough Media House England |
| 270106790001 | ||||||||||
| FORD, Deidre Ann | Administrateur | Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6EA Peterborough Media House England | United Kingdom | British | 109666380002 | |||||||||
| KEENAN, Paul Anthony | Administrateur | Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6EA Peterborough Media House England | England | British | 243390510001 | |||||||||
| VICKERY, Sarah Jane | Administrateur | Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6EA Peterborough Media House England | England | British | 119137220004 | |||||||||
| AUBREY FLETCHER, Henry Egerton, Sir | Secrétaire | Town Hill Farm Dorton Road Chilton HP18 9NA Aylesbury Buckinghamshire | British | 22980850001 | ||||||||||
| FENNELL, Andrew Phillip | Secrétaire | Stanley Hill Avenue HP7 9BD Amersham 6 Buckinghamshire United Kingdom | English | 135981330001 | ||||||||||
| GILLIES, David | Secrétaire | Westfield High Street TN17 3EW Cranbrook Kent | British | 72136060001 | ||||||||||
| PREECE, Andrew | Secrétaire | Barncoose Industrial Estate TR15 3RQ Redruth Carn Brea Studios Cornwall United Kingdom | 186615470001 | |||||||||||
| SCHWARZ, Nathalie Esther | Secrétaire | Flat 10 28 Belsize Avenue NW3 4AU London | British | 59245010001 | ||||||||||
| WATERHOUSE, Ann Marguerite | Secrétaire | 32 Warelands RH15 9QD Burgess Hill West Sussex | British | 67890250002 | ||||||||||
| WELLS, Lynette Ann | Secrétaire | Little Croft Maple Walk TN39 4SN Bexhill On Sea East Sussex | British | 98242040001 | ||||||||||
| WOODS, Sian | Secrétaire | Barncoose Industrial Estate TR15 3RQ Redruth Carn Brea Studios Cornwall United Kingdom | British | 138145820001 | ||||||||||
| COPYSUBMIT LIMITED | Secrétaire | Sixth Floor 4 Carlton Gardens SW1Y 5AA London | 31516620001 | |||||||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secrétaire désigné | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||
| AUBREY FLETCHER, Henry Egerton, Sir | Administrateur | Town Hill Farm Dorton Road Chilton HP18 9NA Aylesbury Buckinghamshire | United Kingdom | British | 22980850001 | |||||||||
| DAVIES, Avril Cutland | Administrateur | 15 Chequers Lane Pitstone LU7 9AG Aylesbury Bedfordshire | United Kingdom | British | 172660700001 | |||||||||
| DAVIES, Ian Alexander | Administrateur | Park Farm Barn Topcroft NR35 2BE Bungay Suffolk | British | 58318990002 | ||||||||||
| FENNELL, Andrew Phillip | Administrateur | Stanley Hill Avenue HP7 9BD Amersham 6 Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | English | 135981330001 | |||||||||
| FLACK, Lydia | Administrateur | Barncoose Industrial Estate TR15 3RQ Redruth Carn Brea Studios Cornwall | United Kingdom | British | 151253330001 | |||||||||
| FLANAGAN, Mark Simon | Administrateur | 65 Butler Close Leckford Road OX2 6JQ Oxford | British | 69776160002 | ||||||||||
| HAILEY, Max Richard | Administrateur | Barncoose Industrial Estate TR15 3RQ Redruth Carn Brea Studios Cornwall United Kingdom | England | British | 180526600002 | |||||||||
| HUMM, Roger James | Administrateur | Dinghurst Road Churchill BS25 5PJ Winscombe Westfield Orchard Avon | England | British | 29914990003 | |||||||||
| JONES, Michael Adrian | Administrateur | 3 Old Shaftesbury Drive Old Blandford Road Harnham SP2 8QH Salisbury Wiltshire | United Kingdom | British | 77984700001 | |||||||||
| LLOYD, Humphrey Alexander | Administrateur | The Old Coach House Wycombe Road Studley Green HP14 3XB High Wycombe | British | 22345580004 | ||||||||||
| MACKENZIE, Alistair William | Administrateur | 142 Widmore Road BR1 3BP Bromley | British | 38279630005 | ||||||||||
| MARSHALL, Roger John Walter | Administrateur | Wayside Farm Billington LU7 9HH Leighton Buzzard Bedfordshire | British | 8347280001 | ||||||||||
| MORRIS ADAMS, Richard Egerton | Administrateur | Leap Hill Brill HP18 9SB Aylesbury Buckinghamshire | England | British | 8234370001 | |||||||||
| OLDHAM, Sally Ann | Administrateur | Lyle Cottage Chequers Lane Eversley RG27 0NT Basingstoke Hampshire | British | 25768940001 | ||||||||||
| PREECE, Andrew Richard | Administrateur | Carn Brea Studios Barncoose Industrial Estate TR15 3RQ Redruth Ukrd Group Limited Cornwall United Kingdom | England | British | 158905700001 | |||||||||
| ROGERS, William James Gerald | Administrateur | Barncoose Industrial Estate TR15 3RQ Redruth Carn Brea Studios Cornwall United Kingdom | England | British | 37957110009 | |||||||||
| SANDERSON, John | Administrateur | 51 Carters Close Sherington MK16 9NW Newport Pagnell Buckinghamshire | British | 62016080004 | ||||||||||
| SORBY-FIRTH, Erika | Administrateur | 45 Stanley Road SG2 0EE Stevenage Hertfordshire | British | 59119380001 | ||||||||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Administrateur désigné | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 | |||||||||||
| RADIO INVESTMENTS LIMITED | Administrateur | 11 Duke Street HP13 6EE High Wycombe Buckinghamshire | 107613840001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MIX 96 LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukrd Group Limited | 06 avr. 2016 | Barncoose Industrial Estate TR15 3RQ Redruth Carn Brea Studios Cornwall England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
MIX 96 LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Créé le 16 juin 2006 Livré le 29 juin 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0