MBG INTERNATIONAL LTD.

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMBG INTERNATIONAL LTD.
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02747938
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MBG INTERNATIONAL LTD. ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe MBG INTERNATIONAL LTD. ?

    Adresse du siège social
    47 Homefield Road
    Chiswalk
    W4 2LW London
    Uk
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MBG INTERNATIONAL LTD. ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    TRIO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED02 oct. 199202 oct. 1992
    LAWGRA (NO. 172) LIMITED16 sept. 199216 sept. 1992

    Quels sont les derniers comptes de MBG INTERNATIONAL LTD. ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2014

    Quels sont les derniers dépôts pour MBG INTERNATIONAL LTD. ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Déclaration annuelle jusqu'au 16 sept. 2015 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital22 oct. 2015

    État du capital au 22 oct. 2015

    • Capital: GBP 3,000,000
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2014

    3 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de Cannon Bridge 25 Dowgate Hill London EC4R 2BB à 47 Homefield Road Chiswalk London Uk W4 2LW le 30 mai 2015

    2 pagesAD01

    Divers

    Aud res section 519 CA2006
    3 pagesMISC

    Cessation de la nomination de Eamonn William Bradley en tant que secrétaire le 03 déc. 2014

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Eamonn William Bradley en tant que directeur le 03 déc. 2014

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 16 sept. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital29 oct. 2014

    État du capital au 29 oct. 2014

    • Capital: GBP 3,000,000
    SH01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2013

    15 pagesAA

    Inscription de la charge 027479380009

    20 pagesMR01

    Inscription de la charge 027479380008

    29 pagesMR01

    Déclaration annuelle jusqu'au 16 sept. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital15 oct. 2013

    État du capital au 15 oct. 2013

    • Capital: GBP 3,000,000
    SH01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2012

    14 pagesAA

    Cessation de la nomination de Alan Farnan en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de David Caplin en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Stephen Welch en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Eamonn William Bradley en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Eamonn William Bradley en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Jeremy Kraft en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Jeremy Kraft en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Déclaration annuelle jusqu'au 16 sept. 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2011

    13 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 16 sept. 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2010

    13 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de MBG INTERNATIONAL LTD. ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WELCH, Stephen
    Homefield Road
    Chiswalk
    W4 2LW London
    47
    Uk
    Administrateur
    Homefield Road
    Chiswalk
    W4 2LW London
    47
    Uk
    EnglandAustralianAccountant179384770001
    BRADLEY, Eamonn William
    Cannon Bridge
    25 Dowgate Hill
    EC4R 2BB London
    Secrétaire
    Cannon Bridge
    25 Dowgate Hill
    EC4R 2BB London
    177013070001
    KRAFT, Jeremy David
    27 Avenue Gardens
    TW11 0BH Teddington
    Middlesex
    Secrétaire
    27 Avenue Gardens
    TW11 0BH Teddington
    Middlesex
    BritishDirector71360190003
    THOMSON, John Stewart
    9 Upper Lattimore Road
    AL1 3UD St Albans
    Hertfordshire
    Secrétaire
    9 Upper Lattimore Road
    AL1 3UD St Albans
    Hertfordshire
    BritishChartered Accountant1644180002
    LAWGRAM SECRETARIES LIMITED
    More London Riverside
    SE1 2AU London
    4
    Secrétaire désigné
    More London Riverside
    SE1 2AU London
    4
    900004760001
    BRADLEY, Eamonn William
    Cannon Bridge
    25 Dowgate Hill
    EC4R 2BB London
    Administrateur
    Cannon Bridge
    25 Dowgate Hill
    EC4R 2BB London
    United KingdomBritishCertified Chartered Accountant177008470001
    CAPLIN, David Simon Montfort
    519 Ben Johnson House
    Barbican
    EC2Q 8DL London
    Administrateur
    519 Ben Johnson House
    Barbican
    EC2Q 8DL London
    EnglandBritishDirector104626850001
    CLARKE, Matthew James Stanhope
    22 Hazlitt Road
    W14 0JY London
    Administrateur
    22 Hazlitt Road
    W14 0JY London
    EnglandBritishChartered Accountant52586600001
    FARNAN, Alan Martin
    14 Roganstown Golf And Country Club
    Roganstown
    IRISH Swords
    County Dublin
    Administrateur
    14 Roganstown Golf And Country Club
    Roganstown
    IRISH Swords
    County Dublin
    IrelandIrishDirector88410720002
    HAGAN, David Lloyd
    Eastwoods
    Pitmore Lane
    SO41 6BW Sway
    Hampshire
    Administrateur
    Eastwoods
    Pitmore Lane
    SO41 6BW Sway
    Hampshire
    United KingdomBritishChartered Accountant50541510001
    KRAFT, Jeremy David
    27 Avenue Gardens
    TW11 0BH Teddington
    Middlesex
    Administrateur
    27 Avenue Gardens
    TW11 0BH Teddington
    Middlesex
    United KingdomBritishDirector71360190003
    MOORE, Christopher Hodgson
    8 Hammersmith Terrace
    W6 9TS London
    Administrateur
    8 Hammersmith Terrace
    W6 9TS London
    EnglandEnglishStockbroker5345930001
    MOORE, Peter David
    Glen House
    Deepdene Wood
    RH5 4BQ Dorking
    Surrey
    Administrateur
    Glen House
    Deepdene Wood
    RH5 4BQ Dorking
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director1644210001
    SPENCE, Christopher John
    Chieveley Manor Church Lane
    Chieveley
    RG20 8UT Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Chieveley Manor Church Lane
    Chieveley
    RG20 8UT Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritishCorporate Adviser3558990001
    THOMSON, John Stewart
    9 Upper Lattimore Road
    AL1 3UD St Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    9 Upper Lattimore Road
    AL1 3UD St Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritishChartered Accountant1644180002
    TURNER, Nicholas Spencer
    Flat 6 53 Shepherds Hill
    Highgate
    N6 5QP London
    Administrateur désigné
    Flat 6 53 Shepherds Hill
    Highgate
    N6 5QP London
    British900005470001

    MBG INTERNATIONAL LTD. a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 29 avr. 2014
    Livré le 15 mai 2014
    En cours
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Sns Portfolio Limited
    Transactions
    • 15 mai 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 29 avr. 2014
    Livré le 06 mai 2014
    En cours
    Brève description
    1. all registered or unregistered estates and interests in freehold and leasehold properties now or in the future owned by the obligors (as defined in the charge document) or in which the obligors have an interest from time to time; and. 2. any present or future interests (whether legal or equitable, and including the benefit of all licences) relating to any registered or unregistered trade marks, patents, copyrights, design rights, domain names, business names, confidential information, know-how and other intellectual property rights together with the rights to use any of the foregoing.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Sns Portfolio Limited
    Transactions
    • 06 mai 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    Deed of pledge
    Créé le 09 avr. 2008
    Livré le 15 avr. 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company or the borrowers to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All the issued sahres being 36,400 shares of 1 each together with all future shares together with rights attaching to those shares see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 15 avr. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    Guarantee and share pledge
    Créé le 17 mars 2008
    Livré le 25 mars 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company or the principal borrower to the chargee on any account whatsoevr
    Brèves mentions
    The shares together with all rights including dividends and other distributions arising in relation thereto.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 25 mars 2008Enregistrement d'une charge (395)
    Composite guarantee and debentures
    Créé le 17 mars 2008
    Livré le 25 mars 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 25 mars 2008Enregistrement d'une charge (395)
    Guarantee and share pledge
    Créé le 16 juil. 2007
    Livré le 18 juil. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Assigned all of the company's rights, title and interest, present and future, to receive money which may become payable pursuant to the share purchase agreement pledged the shares togther with all rights, including dividends and other distributions, arising in relation thereto.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee (The "Security Trustee")
    Transactions
    • 18 juil. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Accession agreement to the debenture
    Créé le 27 juin 2005
    Livré le 07 juil. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the principals (or any of them) to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Gresham LLP (The Security Trustee)
    Transactions
    • 07 juil. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Accession agreement relating to composite guarantee and debenture dated 11 march 2005
    Créé le 27 juin 2005
    Livré le 02 juil. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due by the principals or any of them to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • All Monies Due or to Become Due by the Principals or Any of Them to the Secured Parties on Any Whatsoever
    Transactions
    • 02 juil. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 10 juin 2005
    Livré le 16 juin 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due by the principals (or any of them) to the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee (For the Secured Parties)
    Transactions
    • 16 juin 2005Enregistrement d'une charge (395)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0