MBG INTERNATIONAL LTD.
Vue d'ensemble
Nom de la société | MBG INTERNATIONAL LTD. |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 02747938 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe MBG INTERNATIONAL LTD. ?
Adresse du siège social | 47 Homefield Road Chiswalk W4 2LW London Uk |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de MBG INTERNATIONAL LTD. ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 30 sept. 2014 |
Quels sont les derniers dépôts pour MBG INTERNATIONAL LTD. ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation d'office | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office | 1 pages | GAZ1 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 16 sept. 2015 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2014 | 3 pages | AA | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Cannon Bridge 25 Dowgate Hill London EC4R 2BB à 47 Homefield Road Chiswalk London Uk W4 2LW le 30 mai 2015 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Divers Aud res section 519 CA2006 | 3 pages | MISC | ||||||||||
Cessation de la nomination de Eamonn William Bradley en tant que secrétaire le 03 déc. 2014 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Eamonn William Bradley en tant que directeur le 03 déc. 2014 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 16 sept. 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes annuels établis au 30 sept. 2013 | 15 pages | AA | ||||||||||
Inscription de la charge 027479380009 | 20 pages | MR01 | ||||||||||
Inscription de la charge 027479380008 | 29 pages | MR01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 16 sept. 2013 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes annuels établis au 30 sept. 2012 | 14 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Alan Farnan en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de David Caplin en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Stephen Welch en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Eamonn William Bradley en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Eamonn William Bradley en tant que secrétaire | 1 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Jeremy Kraft en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Jeremy Kraft en tant que secrétaire | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 16 sept. 2012 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 30 sept. 2011 | 13 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 16 sept. 2011 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 30 sept. 2010 | 13 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de MBG INTERNATIONAL LTD. ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELCH, Stephen | Administrateur | Homefield Road Chiswalk W4 2LW London 47 Uk | England | Australian | Accountant | 179384770001 | ||||
BRADLEY, Eamonn William | Secrétaire | Cannon Bridge 25 Dowgate Hill EC4R 2BB London | 177013070001 | |||||||
KRAFT, Jeremy David | Secrétaire | 27 Avenue Gardens TW11 0BH Teddington Middlesex | British | Director | 71360190003 | |||||
THOMSON, John Stewart | Secrétaire | 9 Upper Lattimore Road AL1 3UD St Albans Hertfordshire | British | Chartered Accountant | 1644180002 | |||||
LAWGRAM SECRETARIES LIMITED | Secrétaire désigné | More London Riverside SE1 2AU London 4 | 900004760001 | |||||||
BRADLEY, Eamonn William | Administrateur | Cannon Bridge 25 Dowgate Hill EC4R 2BB London | United Kingdom | British | Certified Chartered Accountant | 177008470001 | ||||
CAPLIN, David Simon Montfort | Administrateur | 519 Ben Johnson House Barbican EC2Q 8DL London | England | British | Director | 104626850001 | ||||
CLARKE, Matthew James Stanhope | Administrateur | 22 Hazlitt Road W14 0JY London | England | British | Chartered Accountant | 52586600001 | ||||
FARNAN, Alan Martin | Administrateur | 14 Roganstown Golf And Country Club Roganstown IRISH Swords County Dublin | Ireland | Irish | Director | 88410720002 | ||||
HAGAN, David Lloyd | Administrateur | Eastwoods Pitmore Lane SO41 6BW Sway Hampshire | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 50541510001 | ||||
KRAFT, Jeremy David | Administrateur | 27 Avenue Gardens TW11 0BH Teddington Middlesex | United Kingdom | British | Director | 71360190003 | ||||
MOORE, Christopher Hodgson | Administrateur | 8 Hammersmith Terrace W6 9TS London | England | English | Stockbroker | 5345930001 | ||||
MOORE, Peter David | Administrateur | Glen House Deepdene Wood RH5 4BQ Dorking Surrey | United Kingdom | British | Company Director | 1644210001 | ||||
SPENCE, Christopher John | Administrateur | Chieveley Manor Church Lane Chieveley RG20 8UT Newbury Berkshire | United Kingdom | British | Corporate Adviser | 3558990001 | ||||
THOMSON, John Stewart | Administrateur | 9 Upper Lattimore Road AL1 3UD St Albans Hertfordshire | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 1644180002 | ||||
TURNER, Nicholas Spencer | Administrateur désigné | Flat 6 53 Shepherds Hill Highgate N6 5QP London | British | 900005470001 |
MBG INTERNATIONAL LTD. a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Créé le 29 avr. 2014 Livré le 15 mai 2014 | En cours | ||
Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 29 avr. 2014 Livré le 06 mai 2014 | En cours | ||
Brève description 1. all registered or unregistered estates and interests in freehold and leasehold properties now or in the future owned by the obligors (as defined in the charge document) or in which the obligors have an interest from time to time; and. 2. any present or future interests (whether legal or equitable, and including the benefit of all licences) relating to any registered or unregistered trade marks, patents, copyrights, design rights, domain names, business names, confidential information, know-how and other intellectual property rights together with the rights to use any of the foregoing. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Deed of pledge | Créé le 09 avr. 2008 Livré le 15 avr. 2008 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company or the borrowers to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All the issued sahres being 36,400 shares of 1 each together with all future shares together with rights attaching to those shares see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Guarantee and share pledge | Créé le 17 mars 2008 Livré le 25 mars 2008 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company or the principal borrower to the chargee on any account whatsoevr | |
Brèves mentions The shares together with all rights including dividends and other distributions arising in relation thereto. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Composite guarantee and debentures | Créé le 17 mars 2008 Livré le 25 mars 2008 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Guarantee and share pledge | Créé le 16 juil. 2007 Livré le 18 juil. 2007 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Assigned all of the company's rights, title and interest, present and future, to receive money which may become payable pursuant to the share purchase agreement pledged the shares togther with all rights, including dividends and other distributions, arising in relation thereto. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Accession agreement to the debenture | Créé le 27 juin 2005 Livré le 07 juil. 2005 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the principals (or any of them) to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Accession agreement relating to composite guarantee and debenture dated 11 march 2005 | Créé le 27 juin 2005 Livré le 02 juil. 2005 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due by the principals or any of them to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Composite guarantee and debenture | Créé le 10 juin 2005 Livré le 16 juin 2005 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due by the principals (or any of them) to the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0