THE WYCHWOOD BREWERY COMPANY LIMITED

THE WYCHWOOD BREWERY COMPANY LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTHE WYCHWOOD BREWERY COMPANY LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02748038
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de THE WYCHWOOD BREWERY COMPANY LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe THE WYCHWOOD BREWERY COMPANY LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Marstons House
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    West Midlands
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de THE WYCHWOOD BREWERY COMPANY LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au02 oct. 2021

    Quels sont les derniers dépôts pour THE WYCHWOOD BREWERY COMPANY LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    2 pagesDS01

    État du capital au 07 sept. 2022

    • Capital: GBP 1
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Cancel share premium account 05/09/2022
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital après une attribution d'actions au 05 sept. 2022

    • Capital: GBP 874,158
    3 pagesSH01

    Déclaration de confirmation établie le 27 juin 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 02 oct. 2021

    8 pagesAA

    Cessation de la nomination de Anne Marie Brennan en tant que secrétaire le 05 oct. 2021

    1 pagesTM02

    Nomination de Mrs Michelle Louise Woodall en tant que secrétaire le 05 oct. 2021

    2 pagesAP03

    Nomination de Edward Hancock en tant qu'administrateur le 05 oct. 2021

    2 pagesAP01

    Nomination de Robert Anthony Leach en tant qu'administrateur le 05 oct. 2021

    2 pagesAP01

    Nomination de Mrs Hayleigh Lupino en tant qu'administrateur le 05 oct. 2021

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Ralph Graham Findlay en tant que directeur le 02 oct. 2021

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 27 juin 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 03 oct. 2020

    8 pagesAA

    Cessation de la nomination de Richard James Westwood en tant que directeur le 30 oct. 2020

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 27 juin 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 28 sept. 2019

    8 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 27 juin 2019 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 29 sept. 2018

    8 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 27 juin 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2017

    8 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de THE WYCHWOOD BREWERY COMPANY LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WOODALL, Michelle Louise
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    Secrétaire
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    288186710001
    ANDREA, Andrew Andonis
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    West Midlands
    Administrateur
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    West Midlands
    EnglandBritishCompany Director137383120001
    HANCOCK, Edward John
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    Administrateur
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Surveyor288133210001
    LEACH, Robert Anthony
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    Administrateur
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    United KingdomBritishHead Of Treasury194085550001
    LUPINO, Hayleigh
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    Administrateur
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director207826950002
    ADAMS, Paul Francis
    Thurston House
    Weston Road
    BA1 2XU Bath
    Secrétaire
    Thurston House
    Weston Road
    BA1 2XU Bath
    British125526410001
    BIRCH, James
    7 Woods Close
    Sherston
    SN16 0LF Malmesbury
    Wiltshire
    Secrétaire
    7 Woods Close
    Sherston
    SN16 0LF Malmesbury
    Wiltshire
    BritishDirector116449180001
    BRENNAN, Anne Marie
    Marston's House
    WV1 4JT Wolverhampton
    West Midlands
    Secrétaire
    Marston's House
    WV1 4JT Wolverhampton
    West Midlands
    BritishCompany Secretary109935620001
    BRYAN, Nicholas George
    8 The Breach
    SN10 5BJ Devizes
    Wiltshire
    Secrétaire
    8 The Breach
    SN10 5BJ Devizes
    Wiltshire
    BritishCompany Director65460520003
    SHAH, Vimal
    9 Southfield Road
    Chiswick
    W4 1AG London
    Secrétaire
    9 Southfield Road
    Chiswick
    W4 1AG London
    British4692040001
    WEST, Alan
    29 Oak Manor Drive
    GL52 6SZ Cheltenham
    Gloucestershire
    Secrétaire
    29 Oak Manor Drive
    GL52 6SZ Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishFinancial Controller111318570001
    BONDLAW SECRETARIES LIMITED
    39-49 Commercial Road
    SO15 1GA Southampton
    Hampshire
    Secrétaire
    39-49 Commercial Road
    SO15 1GA Southampton
    Hampshire
    106817380001
    ADAMS, Paul Francis
    Thurston House
    Weston Road
    BA1 2XU Bath
    Administrateur
    Thurston House
    Weston Road
    BA1 2XU Bath
    EnglandBritishChartered Accountant125526410001
    ANDREW, Derek
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    West Midlands
    Administrateur
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    West Midlands
    BritishCompany Director39071260003
    BIRCH, James
    7 Woods Close
    Sherston
    SN16 0LF Malmesbury
    Wiltshire
    Administrateur
    7 Woods Close
    Sherston
    SN16 0LF Malmesbury
    Wiltshire
    BritishDirector116449180001
    BRYAN, Nicholas George
    8 The Breach
    SN10 5BJ Devizes
    Wiltshire
    Administrateur
    8 The Breach
    SN10 5BJ Devizes
    Wiltshire
    EnglandBritishCompany Director65460520003
    CHOWDHARY, Balvinder Kaur
    112 Park Road
    Hampton Hill
    TW12 1HR Hampton
    Middlesex
    Administrateur
    112 Park Road
    Hampton Hill
    TW12 1HR Hampton
    Middlesex
    EnglandBritishCompany Registration Agent4672940001
    COYLE, James Arthur
    Glen Ruther College Road
    Denstone
    ST14 5HR Uttoxeter
    Staffordshire
    Administrateur
    Glen Ruther College Road
    Denstone
    ST14 5HR Uttoxeter
    Staffordshire
    BritishSales Director63364040001
    DALZELL, Peter
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    Administrateur
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director163616170001
    DARBY, Alistair William
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    West Midlands
    Administrateur
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    West Midlands
    BritishCompany Director87846880002
    DAVIES, Martin William Oliver
    Dancing Waters
    The Friary
    SL4 2NS Old Windsor
    Berkshire
    Administrateur
    Dancing Waters
    The Friary
    SL4 2NS Old Windsor
    Berkshire
    BritishManaging Director40444030001
    DENNING, Roland John
    Swallowfield Grange
    The Street
    RG7 1RE Swallowfield
    Berkshire
    Administrateur
    Swallowfield Grange
    The Street
    RG7 1RE Swallowfield
    Berkshire
    EnglandBritishCompany Director95991510001
    FINDLAY, Ralph Graham
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marstons House
    West Midlands
    Administrateur
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marstons House
    West Midlands
    EnglandBritishCompany Director129897400001
    GRACE, David Allen
    Lark Rise Home Farm Court
    East End Adderbury
    OX17 3NW Banbury
    Oxon
    Administrateur
    Lark Rise Home Farm Court
    East End Adderbury
    OX17 3NW Banbury
    Oxon
    BritishCompany Director67926560001
    HAWTHORN, Stuart John
    3 Rutherford Close
    OX14 2AT Abingdon
    Oxfordshire
    Administrateur
    3 Rutherford Close
    OX14 2AT Abingdon
    Oxfordshire
    BritishDirector82240190001
    INGLETT, Paul
    Marston's House
    WV1 4JT Wolverhampton
    West Midlands
    Administrateur
    Marston's House
    WV1 4JT Wolverhampton
    West Midlands
    BritishCompany Director81617110002
    LUSCOMBE, Richard William
    Lauriston House
    Town Barton, Norton St. Philip
    BA2 7LN Bath
    Avon
    Administrateur
    Lauriston House
    Town Barton, Norton St. Philip
    BA2 7LN Bath
    Avon
    BritishCompany Director70464690001
    MOSS, Arthur Christopher
    80 Bridge Street
    OX2 0BD Oxford
    Oxfordshire
    Administrateur
    80 Bridge Street
    OX2 0BD Oxford
    Oxfordshire
    BritishBrewer30700880001
    OLIVER, Stephen John
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    West Midlands
    Administrateur
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    West Midlands
    BritishCompany Director66123690003
    ROGERS, Ian
    17 Burcott Park
    Burcott
    OX14 3DH Abingdon
    Oxfordshire
    Administrateur
    17 Burcott Park
    Burcott
    OX14 3DH Abingdon
    Oxfordshire
    BritishManaging Director30700870003
    THOMPSON, Rupert Geoffrey Ryland
    The Hermitage
    RG17 0HA Hungerford
    Berks
    Administrateur
    The Hermitage
    RG17 0HA Hungerford
    Berks
    EnglandBritishCompany Director30939200001
    WESTWOOD, Richard James
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    Administrateur
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director314691870001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur THE WYCHWOOD BREWERY COMPANY LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleUnited Kingdom
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement03981399
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    THE WYCHWOOD BREWERY COMPANY LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    Créé le 08 juil. 2002
    Livré le 09 juil. 2002
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts between the security holder and the company (including associated rights relating thereto) which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD (the Security Holder)
    Transactions
    • 09 juil. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 12 juin 2002
    Livré le 14 juin 2002
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 14 juin 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 nov. 2002Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    Debenture
    Créé le 29 oct. 1999
    Livré le 10 nov. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 10 nov. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 déc. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 19 janv. 1998
    Livré le 22 janv. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. a specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 22 janv. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 déc. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Book debts debenture
    Créé le 28 oct. 1996
    Livré le 30 oct. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    First fixed charge on all book debts and other debts of the company both present and future save for those book debts and other debts sold by the company and purchased by the chargee under an invoice discounting agreement and not purchased pursuant to the provisions thereof.
    Personnes ayant droit
    • New Court Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 30 oct. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 févr. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 10 avr. 1995
    Livré le 19 avr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    Leasehold property known as units 10 and 11 eagle industrial estate the crofts witney oxfordshire title number ON172245 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 19 avr. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 août 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 10 avr. 1995
    Livré le 19 avr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    Leasehold property known as unit 12 eagle industrial estate witney oxfordshire title number ON169190 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 19 avr. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 août 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Collateral debenture
    Créé le 17 oct. 1994
    Livré le 21 oct. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from hobgoblinns limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • 3I Group PLC
    Transactions
    • 21 oct. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 déc. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Counterpart rent deposit deed
    Créé le 11 août 1994
    Livré le 12 août 1994
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or hobgoblinns limited to the chargee under the terms of a lease dated 11TH august 1994 and this deed
    Brèves mentions
    £1066 or one quarter of the annual rent from time to time payable under the said lease dated 11TH august 1994 (whichever shall be the greater) together with a sum equivalent to the rate of V.A.T. currently charged on rent.
    Personnes ayant droit
    • Hambridge Investments (Newbury) Limited
    Transactions
    • 12 août 1994Enregistrement d'une charge (395)
    Rent deposit deed incorporating charge
    Créé le 12 mai 1994
    Livré le 13 mai 1994
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or hobgoblinns limited to the chargee under the terms of the lease dated 12TH may 1994.
    Brèves mentions
    £5,529 and all other monies deposited in the deposit account at lloyds bank PLC in the name of the chargee.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hambridge Investments (Newbury) Limited
    Transactions
    • 13 mai 1994Enregistrement d'une charge (395)
    Mortgage debenture
    Créé le 01 juil. 1993
    Livré le 08 juil. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 08 juil. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 juin 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 24 juin 1993
    Livré le 07 juil. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H-unit 9B two rivers industrial estate station lane witney oxfordshire. T/n-ON111965 and ON139732 and/or the proceeds of sale thereof and assigns the goodwill of the business and the full benefit of all licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 07 juil. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 août 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0