FLEXIT IH LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéFLEXIT IH LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02752646
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de FLEXIT IH LIMITED ?

    • (7011) /

    Où se situe FLEXIT IH LIMITED ?

    Adresse du siège social
    The Hart Shaw Building Europa Link
    Sheffield Business Park
    S9 1XU Sheffield
    South Yorkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de FLEXIT IH LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SHAREBALANCE PUBLIC LIMITED COMPANY02 oct. 199202 oct. 1992

    Quels sont les derniers comptes de FLEXIT IH LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2008

    Quels sont les derniers dépôts pour FLEXIT IH LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    3 pages4.71

    Changement d'adresse du siège social de Booths Park Chelford Road Knutsford Cheshire WA16 8QZ le 16 janv. 2010

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 17 déc. 2009

    LRESSP

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    3 pages288a

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    4 pages363a

    Comptes établis au 31 déc. 2008

    3 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages353

    Comptes établis au 31 déc. 2007

    3 pagesAA

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    3 pages363a

    Comptes établis au 31 déc. 2006

    3 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Comptes établis au 31 déc. 2005

    3 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Comptes établis au 31 déc. 2004

    3 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de FLEXIT IH LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HAND, Kim Andrea
    Sutton Field
    Whitegate
    CW8 2BD Northwich
    Cherry Trees,
    Cheshire
    Secrétaire
    Sutton Field
    Whitegate
    CW8 2BD Northwich
    Cherry Trees,
    Cheshire
    British141032930001
    FIDLER, Christopher Laskey
    Marlborough Avenue
    SK8 7AW Cheadle Hulme
    66
    Cheshire
    Administrateur
    Marlborough Avenue
    SK8 7AW Cheadle Hulme
    66
    Cheshire
    EnglandBritish141025870003
    AMEC NOMINEES LIMITED
    Booths Park
    Chelford Road
    WA16 8QZ Knutsford
    Cheshire
    Administrateur
    Booths Park
    Chelford Road
    WA16 8QZ Knutsford
    Cheshire
    32732300002
    FELLOWES, Colin
    9 Thistlewood Drive
    Summerfields
    SK9 2RF Wilmslow
    Cheshire
    Secrétaire
    9 Thistlewood Drive
    Summerfields
    SK9 2RF Wilmslow
    Cheshire
    British800670001
    FIDLER, Christopher Laskey
    Marlborough Avenue
    SK8 7AW Cheadle Hulme
    66
    Cheshire
    Secrétaire
    Marlborough Avenue
    SK8 7AW Cheadle Hulme
    66
    Cheshire
    British141025870003
    JACKSON, Stanley Robertson
    74 Olivers Battery Road North
    SO22 4JB Winchester
    Hampshire
    Secrétaire
    74 Olivers Battery Road North
    SO22 4JB Winchester
    Hampshire
    British4689630002
    SHELDON, Jeremy Nigel
    Pasturewood House
    Abinger Lane, Abinger Common
    RH5 6JH Dorking
    Surrey
    Secrétaire
    Pasturewood House
    Abinger Lane, Abinger Common
    RH5 6JH Dorking
    Surrey
    British80327250001
    RICHARD ELLIS FINANCIAL LIMITED
    C/O Richard Ellis
    55 Old Broad Street
    EC2M 1LP London
    Secrétaire
    C/O Richard Ellis
    55 Old Broad Street
    EC2M 1LP London
    32874470003
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    COX, Michael John
    Holly Tree House
    Brandy Bottom Yateley Common
    GU17 6BE Camberley
    Surrey
    Administrateur
    Holly Tree House
    Brandy Bottom Yateley Common
    GU17 6BE Camberley
    Surrey
    British28998990001
    COX, Michael John
    Holly Tree House
    Brandy Bottom Yateley Common
    GU17 6BE Camberley
    Surrey
    Administrateur
    Holly Tree House
    Brandy Bottom Yateley Common
    GU17 6BE Camberley
    Surrey
    British28998990001
    COX, Michael John
    Holly Tree House
    Brandy Bottom Yateley Common
    GU17 6BE Camberley
    Surrey
    Administrateur
    Holly Tree House
    Brandy Bottom Yateley Common
    GU17 6BE Camberley
    Surrey
    British28998990001
    DEVINE, Stephen Colm
    4 Fernbank
    Finchampstead
    RG11 4XB Wokingham
    Berkshire
    Administrateur
    4 Fernbank
    Finchampstead
    RG11 4XB Wokingham
    Berkshire
    Irish6552570001
    DEVINE, Stephen Colm
    4 Fernbank
    Finchampstead
    RG11 4XB Wokingham
    Berkshire
    Administrateur
    4 Fernbank
    Finchampstead
    RG11 4XB Wokingham
    Berkshire
    Irish6552570001
    ELLINGHAM, Hugh Vere Alexander
    Stonepitts Manor
    Seal
    TN15 0ER Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    Stonepitts Manor
    Seal
    TN15 0ER Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritish36926690001
    FITZGERALD, Michael Thomas
    Whin Cottage St Michaels Drive
    TN14 5SA Otford
    Kent
    Administrateur
    Whin Cottage St Michaels Drive
    TN14 5SA Otford
    Kent
    British62403370002
    FRASER, Richard Lindsay
    Meadowgarth Bowbridge Lane
    Prestbury
    GL52 3BJ Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    Meadowgarth Bowbridge Lane
    Prestbury
    GL52 3BJ Cheltenham
    Gloucestershire
    British13770640001
    HOLLAND, Peter James
    Woodside House
    Wynnstay Lane, Marford
    LL12 8LH Wrexham
    Administrateur
    Woodside House
    Wynnstay Lane, Marford
    LL12 8LH Wrexham
    WalesBritish75624260001
    JACKSON, Stanley Robertson
    74 Olivers Battery Road North
    SO22 4JB Winchester
    Hampshire
    Administrateur
    74 Olivers Battery Road North
    SO22 4JB Winchester
    Hampshire
    British4689630002
    JACKSON, Stanley Robertson
    74 Olivers Battery Road North
    SO22 4JB Winchester
    Hampshire
    Administrateur
    74 Olivers Battery Road North
    SO22 4JB Winchester
    Hampshire
    British4689630002
    PEARCE, Daniel Norton Idris, Sir
    G3 Albany
    Piccadilly
    W1J 0AT London
    Administrateur
    G3 Albany
    Piccadilly
    W1J 0AT London
    British45656280001
    RATCLIFFE, Michael Arthur
    9 Leigh Court Close
    KT11 2HT Cobham
    Surrey
    Administrateur
    9 Leigh Court Close
    KT11 2HT Cobham
    Surrey
    United KingdomBritish11387510001
    ROUGHTON, Dominic David
    10 Danbury Street
    Islington
    N1 8JU London
    Administrateur
    10 Danbury Street
    Islington
    N1 8JU London
    British30738920001
    SHELDON, Jeremy Nigel
    Pasturewood House
    Abinger Lane, Abinger Common
    RH5 6JH Dorking
    Surrey
    Administrateur
    Pasturewood House
    Abinger Lane, Abinger Common
    RH5 6JH Dorking
    Surrey
    British80327250001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur désigné
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    FLEXIT IH LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 01 juin 1994
    Livré le 03 juin 1994
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 11.1 of the put and call option deed dated 14TH january 1993
    Brèves mentions
    Plot 58 regents gate foxholes hertford hertfordshire.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 03 juin 1994Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 19 avr. 1994
    Livré le 20 avr. 1994
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 11.1 of a put and call option deed dated 14TH january 1993
    Brèves mentions
    Plot 58 on the company's estate at phase 2(a) regents gate foxholes, hertford hertfordshire.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 20 avr. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 09 févr. 1994
    Livré le 10 févr. 1994
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 11.1 of the put and call option deed dated 14TH january 1993
    Brèves mentions
    Plot 14 crusaders court st. Johns terrace road earlswood redhill, plots 9 17 and 25 manor drive wembley. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 10 févr. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 09 févr. 1994
    Livré le 10 févr. 1994
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee arising from or as a result of a material breach by the company of one or more of the covenants and undertakings given by the company pursuant to clause 11.1 of the put and call option deed for the sale and purchase of the business of the company dated 14 january 1993
    Brèves mentions
    Plot 160 carreg yr afon glan yr afon graig newydd godre'r graig pontardawe west glamorgan.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 10 févr. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 09 févr. 1994
    Livré le 10 févr. 1994
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee arising from or as a result of a material breach by the company of one or more of the covenants and undertakings given by the company pursuant to clause 11.1 of the put and call option deed for the sale and purchase of the business of the company dated 14 january 1993
    Brèves mentions
    Plot 78 herons reach blackpool.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 10 févr. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 21 déc. 1993
    Livré le 07 janv. 1994
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 11.1 of a put and call option deed dated 14TH january 1993
    Brèves mentions
    Plot 43 impala drive cherry hinton.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 07 janv. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 29 nov. 1993
    Livré le 01 déc. 1993
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 11.1 of a put and call option deed dated 14TH january 1993
    Brèves mentions
    Plot 150.3 glan-yr-afon, godre'r graig, pontardawe, swansea.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 01 déc. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 11 nov. 1993
    Livré le 17 nov. 1993
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 11.1 of a put and call option deed dated 14TH january 1993
    Brèves mentions
    Plots 32,33,34 and 39 salters lane, waterside mews, newport.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 17 nov. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 01 nov. 1993
    Livré le 02 nov. 1993
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 11.1 of a put and call option deed dated 14TH january 1993
    Brèves mentions
    Plot 115 cyclops wharf, west ferry road, london.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 02 nov. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 12 oct. 1993
    Livré le 15 oct. 1993
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 11.1 of a put and call option deed dated 14TH january 1993
    Brèves mentions
    Plots 169 and 170 barley croft, station road, elmswell, suffolk.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 15 oct. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 14 sept. 1993
    Livré le 21 sept. 1993
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to 11.1 of the put and call option deed dated 14/1/93
    Brèves mentions
    Plot 88 herons reach blackpool.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 21 sept. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 30 juil. 1993
    Livré le 05 août 1993
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 11.1 of a put and call option deed dated 14TH january 1993
    Brèves mentions
    Plot 902 cyclops wharf, west ferry road, london.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 05 août 1993Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 23 juil. 1993
    Livré le 07 août 1993
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 11.1 of a put and call option deed dated 14TH january 1993
    Brèves mentions
    Plot 502 cyclops wharf west ferry road, london.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 07 août 1993Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 21 juil. 1993
    Livré le 23 juil. 1993
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 11.1 of the put and call option deed dated 14/1/193
    Brèves mentions
    Plots 95, 32, 29 and 49 spring gardens ince.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 23 juil. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 02 juil. 1993
    Livré le 07 juil. 1993
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 11.1 of a put and call option deed dated 14TH january 1993
    Brèves mentions
    Plot 144 godre'r graig, swansea.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 07 juil. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 25 juin 1993
    Livré le 02 juil. 1993
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 11.1 of a put and call option deed dated 14TH january 1993
    Brèves mentions
    326 cyclops wharf, west ferry road, london.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 02 juil. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 24 juin 1993
    Livré le 02 juil. 1993
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 11.1 of a put and call option deed dated 14TH january 1993
    Brèves mentions
    516 cyclops wharf, west ferry road, london.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 02 juil. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 04 juin 1993
    Livré le 17 juin 1993
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Plots 2.01, 5.16 and 6.19 king and queen wharf, rotherhithe. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 17 juin 1993Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 17 mai 1993
    Livré le 20 mai 1993
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Plots 59,64,65 willow green,robertsbridge; plot 45 lytton gate,woolmer green.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 20 mai 1993Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 22 févr. 1993
    Livré le 25 févr. 1993
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 11.1 of the put and call option deed dated 14TH january 1993
    Brèves mentions
    Plot 7 on the company's estate at the ridings, paddock wood t/no: k 684686 (see ch microfiche for full details).
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 25 févr. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 14 janv. 1993
    Livré le 01 févr. 1993
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 11.1 of the put and call options deed of even date and under the terms of the charge
    Brèves mentions
    See 395 for full details and property details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 01 févr. 1993Enregistrement d'une charge (395)

    FLEXIT IH LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    17 déc. 2009Commencement of winding up
    10 avr. 2011Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Christopher John Brown
    The Hart Shaw Building Europa Link
    Sheffield Business Park
    S9 1XU Sheffield
    South Yorkshire
    practitioner
    The Hart Shaw Building Europa Link
    Sheffield Business Park
    S9 1XU Sheffield
    South Yorkshire

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0