SHANOC ELECTRONIC SYSTEMS LIMITED

SHANOC ELECTRONIC SYSTEMS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSHANOC ELECTRONIC SYSTEMS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02754404
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SHANOC ELECTRONIC SYSTEMS LIMITED ?

    • (3130) /

    Où se situe SHANOC ELECTRONIC SYSTEMS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o WAGSTAFF ACCOUNTANTS
    Richmond House Pond Close
    Walkern Road
    SG1 3QP Stevenage
    Herts
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SHANOC ELECTRONIC SYSTEMS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    READYCOPY LIMITED09 oct. 199209 oct. 1992

    Quels sont les derniers comptes de SHANOC ELECTRONIC SYSTEMS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 avr. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour SHANOC ELECTRONIC SYSTEMS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Achèvement de la liquidation

    1 pagesL64.07

    Résumé des recettes et paiements du superviseur de l'accord volontaire jusqu'au 08 juin 2012

    8 pages1.3

    Ordonnance du tribunal pour liquider

    3 pagesCOCOMP

    Cessation de la nomination de Patrick John James William Wallace en tant que directeur le 31 mai 2011

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Mark John Sargent en tant que secrétaire le 31 mai 2011

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr Marcus George Henchley Newton en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Résumé des recettes et paiements du superviseur de l'accord volontaire jusqu'au 08 juin 2011

    13 pages1.3

    legacy

    8 pagesMG01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 avr. 2010

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 déc. 2010 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital27 janv. 2011

    État du capital au 27 janv. 2011

    • Capital: GBP 109
    SH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 oct. 2010 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Patrick John James William Wallace le 01 oct. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Mark John Sargent le 01 oct. 2010

    1 pagesCH03

    legacy

    3 pagesMG02

    Période comptable précédente prolongée du 31 déc. 2009 au 30 avr. 2010

    3 pagesAA01

    Avis au registre des sociétés de l'accord volontaire prenant effet

    4 pages1.1

    Changement d'adresse du siège social de Pond Close Walkern Road Stevenage Herts SG1 3QP le 20 avr. 2010

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 oct. 2009 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Patrick Wallace le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2008

    4 pagesAA

    legacy

    5 pages395

    legacy

    5 pages363a

    legacy

    2 pages88(2)

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2007

    7 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de SHANOC ELECTRONIC SYSTEMS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    NEWTON, Marcus George Henchley
    c/o Wagstaff Accountants
    Pond Close
    Walkern Road
    SG1 3QP Stevenage
    Richmond House
    Herts
    England
    Administrateur
    c/o Wagstaff Accountants
    Pond Close
    Walkern Road
    SG1 3QP Stevenage
    Richmond House
    Herts
    England
    EnglandBritishCompany Director153955450002
    HOUGHTON, Andrew Clive
    Briar Cottage
    Bromley Road
    CO4 3JG Colchester
    Essex
    Secrétaire
    Briar Cottage
    Bromley Road
    CO4 3JG Colchester
    Essex
    BritishArchitectural Design85996260001
    MOORE, Wayne
    2 Eaton Park
    Eaton Bray
    LU6 2SR Dunstable
    Bedfordshire
    Secrétaire
    2 Eaton Park
    Eaton Bray
    LU6 2SR Dunstable
    Bedfordshire
    BritishCompany Director31422920001
    RUTTER, Laurence
    Cockaynes House
    Cockaynes Lane, Alresford
    CO7 8BZ Colchester
    Essex
    Secrétaire
    Cockaynes House
    Cockaynes Lane, Alresford
    CO7 8BZ Colchester
    Essex
    BritishChief Executive78086920008
    RUTTER, Laurence Philip
    12 Sussex Road
    CO3 3QH Colchester
    Essex
    Secrétaire
    12 Sussex Road
    CO3 3QH Colchester
    Essex
    BritishChief Executive78086920012
    SARGENT, Mark John
    c/o Wagstaff Accountants
    Pond Close
    Walkern Road
    SG1 3QP Stevenage
    Richmond House
    Herts
    England
    Secrétaire
    c/o Wagstaff Accountants
    Pond Close
    Walkern Road
    SG1 3QP Stevenage
    Richmond House
    Herts
    England
    BritishCompany Director44446550002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    HOUGHTON, Andrew Clive
    Briar Cottage
    Bromley Road
    CO4 3JG Colchester
    Essex
    Administrateur
    Briar Cottage
    Bromley Road
    CO4 3JG Colchester
    Essex
    EnglandBritishArchitectural Design85996260001
    JENKINS, Dan George
    Parsonage Farm
    Preston
    CT3 1DP Canterbury
    Kent
    Administrateur
    Parsonage Farm
    Preston
    CT3 1DP Canterbury
    Kent
    BritishManaging Director116155380001
    MOORE, Wayne
    2 Eaton Park
    Eaton Bray
    LU6 2SR Dunstable
    Bedfordshire
    Administrateur
    2 Eaton Park
    Eaton Bray
    LU6 2SR Dunstable
    Bedfordshire
    BritishChartered Engineer31422920001
    RUTTER, Laurence
    Pippins
    White Hart Lane
    CO6 3DB West Bergholt
    Essex
    Administrateur
    Pippins
    White Hart Lane
    CO6 3DB West Bergholt
    Essex
    BritishBanker78086920002
    WALLACE, Patrick John James William
    c/o Wagstaff Accountants
    Pond Close
    Walkern Road
    SG1 3QP Stevenage
    Richmond House
    Herts
    England
    Administrateur
    c/o Wagstaff Accountants
    Pond Close
    Walkern Road
    SG1 3QP Stevenage
    Richmond House
    Herts
    England
    United KingdomBritishInvestor141162430001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur désigné
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    SHANOC ELECTRONIC SYSTEMS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 25 mars 2011
    Livré le 12 avr. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Jeffrey Green Russell,Solicitors
    Transactions
    • 12 avr. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 30 juin 2009
    Livré le 04 juil. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transactions
    • 04 juil. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 oct. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 09 juin 2004
    Livré le 16 juin 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 16 juin 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 18 janv. 1999
    Livré le 21 janv. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an asset sale agreement of even date and/or the debenture
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • R H Electronics Limited
    Transactions
    • 21 janv. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 mai 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 08 déc. 1992
    Livré le 29 déc. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £30,000 due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    See form 395. undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Maurice Raymond Dorrington
    • Steven George Taylor
    Transactions
    • 29 déc. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 juin 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    SHANOC ELECTRONIC SYSTEMS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    09 juin 2010Date of meeting to approve CVA
    Corporate voluntary arrangement (CVA)
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Andrew John Whelan
    Marks Bloom
    60/62 Old London Road
    KT2 6QZ Kingston Upon Thames
    Surrey
    practitioner
    Marks Bloom
    60/62 Old London Road
    KT2 6QZ Kingston Upon Thames
    Surrey
    2
    DateType
    28 déc. 2012Conclusion of winding up
    29 déc. 2011Petition date
    13 mars 2012Commencement of winding up
    04 avr. 2013Dissolved on
    Compulsory liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    The Official Receiver Or St Albans
    1st Floor
    Trident House
    AL1 3HR 42-48 Victoria Street
    St Albans
    practitioner
    1st Floor
    Trident House
    AL1 3HR 42-48 Victoria Street
    St Albans

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0