PERFECT INFORMATION LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPERFECT INFORMATION LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02758652
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PERFECT INFORMATION LIMITED ?

    • Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82990) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe PERFECT INFORMATION LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Ion 10 Queen St Place
    2nd Floor
    EC4R 1BE London
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PERFECT INFORMATION LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BREAMCO 91 LIMITED23 oct. 199223 oct. 1992

    Quels sont les derniers comptes de PERFECT INFORMATION LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2022

    Quels sont les derniers dépôts pour PERFECT INFORMATION LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 déc. 2022

    23 pagesAA

    legacy

    68 pagesPARENT_ACC

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Déclaration de confirmation établie le 08 oct. 2023 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Nomination de Mr Paul Robert Evans en tant qu'administrateur le 01 sept. 2023

    2 pagesAP01

    État du capital au 08 juin 2023

    • Capital: GBP 0.85
    5 pagesSH19

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Cancel share premium 05/06/2023
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    legacy

    1 pagesSH20

    Cessation de Mergermarket Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 déc. 2022

    1 pagesPSC07

    Notification de Andrea Pignataro en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 janv. 2023

    2 pagesPSC01

    Déclaration de confirmation établie le 08 oct. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 déc. 2021

    22 pagesAA

    legacy

    72 pagesPARENT_ACC

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2

    Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 déc. 2020

    19 pagesAA

    legacy

    60 pagesPARENT_ACC

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    Qui sont les dirigeants de PERFECT INFORMATION LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    GRIFFIN, Neil
    10 Queen St Place
    2nd Floor
    EC4R 1BE London
    C/O Ion
    England
    Secrétaire
    10 Queen St Place
    2nd Floor
    EC4R 1BE London
    C/O Ion
    England
    288134100001
    EVANS, Paul Robert
    10 Queen St Place
    2nd Floor
    EC4R 1BE London
    C/O Ion
    England
    Administrateur
    10 Queen St Place
    2nd Floor
    EC4R 1BE London
    C/O Ion
    England
    EnglandBritishDirector189847980001
    GULLAPALLI, Kunal Venkat
    10 Queen St Place
    2nd Floor
    EC4R 1BE London
    C/O Ion
    England
    Administrateur
    10 Queen St Place
    2nd Floor
    EC4R 1BE London
    C/O Ion
    England
    United StatesAmericanDirector263990370001
    BATY, Claire Vanessa
    79 Wells Street
    W1T 3QN London
    Wells Point
    United Kingdom
    Secrétaire
    79 Wells Street
    W1T 3QN London
    Wells Point
    United Kingdom
    172523570001
    BATY, Claire Vanessa
    St Giles House
    50 Poland Street
    W1F 7AX London
    Secrétaire
    St Giles House
    50 Poland Street
    W1F 7AX London
    British154576220001
    BENYON, Nicholas Spencer
    39 Daryngton Drive
    UB6 8BQ Greenfield
    Middlesex
    Secrétaire
    39 Daryngton Drive
    UB6 8BQ Greenfield
    Middlesex
    British51507140003
    JONES, Matthew David Alexander
    79 Wells Street
    W1T 3QN London
    Wells Point
    United Kingdom
    Secrétaire
    79 Wells Street
    W1T 3QN London
    Wells Point
    United Kingdom
    184798470001
    KEITH, Philippa Anne
    79 Wells Street
    W1T 3QN London
    Wells Point
    United Kingdom
    Secrétaire
    79 Wells Street
    W1T 3QN London
    Wells Point
    United Kingdom
    163453820001
    ROBERTS, Ian Paul Hartin
    St Giles House
    50 Poland Street
    W1F 7AX London
    Secrétaire
    St Giles House
    50 Poland Street
    W1F 7AX London
    British73221640002
    BREAMS REGISTRARS AND NOMINEES LIMITED
    Bedford Row
    WC1R 4LR London
    52
    Secrétaire désigné
    Bedford Row
    WC1R 4LR London
    52
    900002310001
    BENYON, Nicholas Spencer
    39 Daryngton Drive
    UB6 8BQ Greenfield
    Middlesex
    Administrateur
    39 Daryngton Drive
    UB6 8BQ Greenfield
    Middlesex
    BritishDirector51507140003
    BLACK, Andrew William
    143 Lumley Mansions Pimlico Road
    Belgravia
    SW1W London
    Administrateur
    143 Lumley Mansions Pimlico Road
    Belgravia
    SW1W London
    BritishManagement Director43068270001
    COLEMAN, James
    4 Hambledon Road
    Southfields
    SW18 5UB London
    Administrateur
    4 Hambledon Road
    Southfields
    SW18 5UB London
    EnglandBritishIt Director108846660001
    FRIEDMAN, Peter
    37 Evelyn Road
    LU5 4NG Dunstable
    Bedfordshire
    Administrateur
    37 Evelyn Road
    LU5 4NG Dunstable
    Bedfordshire
    EnglandBritishComputer Consultant38417560001
    GIBB, Andria Louise
    79 Wells Street
    W1T 3QN London
    Wells Point
    United Kingdom
    Administrateur
    79 Wells Street
    W1T 3QN London
    Wells Point
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector80326880001
    GOMER, Jonathan Frederick
    One New Change,
    EC4M 9AF London,
    C/O Ion, 3rd Floor,
    England
    Administrateur
    One New Change,
    EC4M 9AF London,
    C/O Ion, 3rd Floor,
    England
    EnglandBritishNone101479980001
    HARRIS, Peter Jonathan
    79 Wells Street
    W1T 3QN London
    Wells Point
    United Kingdom
    Administrateur
    79 Wells Street
    W1T 3QN London
    Wells Point
    United Kingdom
    EnglandBritishFinance Director40917640001
    HOWELL, Martin James
    41 Hatherley Road
    SO22 6RR Winchester
    Hampshire
    Administrateur
    41 Hatherley Road
    SO22 6RR Winchester
    Hampshire
    BritishSales Executive36861660003
    KERSWELL, Mark Henry
    79 Wells Street
    W1T 3QN London
    Wells Point
    United Kingdom
    Administrateur
    79 Wells Street
    W1T 3QN London
    Wells Point
    United Kingdom
    EnglandBritishAccountant82609620003
    LALLY, Michael
    St Giles House
    50 Poland Street
    W1F 7AX London
    Administrateur
    St Giles House
    50 Poland Street
    W1F 7AX London
    United KingdomBritishFinance Director57649530002
    MATTHEWS, Hamilton Ian
    10 Queen St Place
    2nd Floor
    EC4R 1BE London
    C/O Ion
    England
    Administrateur
    10 Queen St Place
    2nd Floor
    EC4R 1BE London
    C/O Ion
    England
    EnglandBritishNone177684510001
    MCLAREN, Anthony John Gibbs
    79 Wells Street
    W1T 3QN London
    Wells Point
    United Kingdom
    Administrateur
    79 Wells Street
    W1T 3QN London
    Wells Point
    United Kingdom
    EnglandEnglishManager54302920001
    MORTIMER, Ian Francis Davis
    1 Louise Road
    SS6 8LW Rayleigh
    Essex
    Administrateur
    1 Louise Road
    SS6 8LW Rayleigh
    Essex
    BritishIt Director65661510001
    NARES, Anthony James
    8 Bloomfield Terrace
    SW1W 8PG London
    Administrateur
    8 Bloomfield Terrace
    SW1W 8PG London
    BritishCompany Director14680200001
    RAW, John Whitfield
    Shoreham House
    Ewhurst Green
    TN32 5RE Robertsbridge
    East Sussex
    Administrateur
    Shoreham House
    Ewhurst Green
    TN32 5RE Robertsbridge
    East Sussex
    United KingdomBritishChartered Accountant4765070001
    SCOTT-BARRETT, Jonathan
    Midgham Park
    Midgham
    RG7 5UG Reading
    Walnut Cottage
    Berkshire
    England
    Administrateur
    Midgham Park
    Midgham
    RG7 5UG Reading
    Walnut Cottage
    Berkshire
    England
    United KingdomBritishPublisher132426100001
    SCRUBY, Basil Thomas Richard
    The Barn
    Hambleden
    RG9 6RT Henley On Thames
    Oxfordshire
    Administrateur
    The Barn
    Hambleden
    RG9 6RT Henley On Thames
    Oxfordshire
    EnglandBritishChartered Accountant49858960002
    SHERREN, Graham Veere
    St Giles House
    50 Poland Street
    W1F 7AX London
    Administrateur
    St Giles House
    50 Poland Street
    W1F 7AX London
    United KingdomBritishDirector147338330001
    SIMIDIAN, Gregory Peter, Dr
    One New Change,
    EC4M 9AF London,
    C/O Ion, 3rd Floor,
    England
    Administrateur
    One New Change,
    EC4M 9AF London,
    C/O Ion, 3rd Floor,
    England
    Hong KongBritishChief Executive Officer62291070004
    WARNER ALLEN, Charles Bruce
    10 Bellevue Road
    SW13 0BJ London
    Administrateur
    10 Bellevue Road
    SW13 0BJ London
    BritishExecutive59458750001
    WILMOT, Geoffrey Tristan Descarriers
    79 Wells Street
    W1T 3QN London
    Wells Point
    United Kingdom
    Administrateur
    79 Wells Street
    W1T 3QN London
    Wells Point
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director46123680003
    BREAMS CORPORATE SERVICES
    16 Bedford Street
    Covent Garden
    WC2E 9HF London
    Administrateur désigné
    16 Bedford Street
    Covent Garden
    WC2E 9HF London
    900002300001
    BREAMS REGISTRARS AND NOMINEES LIMITED
    Bedford Row
    WC1R 4LR London
    52
    Administrateur désigné
    Bedford Row
    WC1R 4LR London
    52
    900002310001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur PERFECT INFORMATION LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Andrea Pignataro
    10 Queen St Place
    2nd Floor
    EC4R 1BE London
    C/O Ion
    England
    01 janv. 2023
    10 Queen St Place
    2nd Floor
    EC4R 1BE London
    C/O Ion
    England
    Non
    Nationalité: Italian
    Pays de résidence: Switzerland
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur les activités d'une société de personnes qui, en vertu de la loi qui la régit, n'est pas une personne morale ; et les membres de cette société de personnes (en cette qualité) ont le droit d'exercer, ou exercent effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.
    Queen Street Place
    EC4R 1BE London
    10
    England
    06 avr. 2016
    Queen Street Place
    EC4R 1BE London
    10
    England
    Oui
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement03879547
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    PERFECT INFORMATION LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 02 sept. 2014
    Livré le 18 sept. 2014
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Registered no: 2268220. classes of services covered: 9, 16, 35, 36 41. please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Ubs Ag, Stamford Branch as Security Trustee
    Transactions
    • 18 sept. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 17 août 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 02 sept. 2014
    Livré le 18 sept. 2014
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Registered no: 2268220. classes of services covered: 9, 16, 35, 36 41. please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Ubs Ag, Stamford Branch as Security Trustee
    Transactions
    • 18 sept. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 17 août 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 02 sept. 2014
    Livré le 15 sept. 2014
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Registered no: 2999472. application no:76327821. Please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Ubs Ag, Stamford Branch as Collateral Agent
    Transactions
    • 15 sept. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 17 août 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 02 sept. 2014
    Livré le 15 sept. 2014
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Registered no: 2999472. application no:76327821. Please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Ubs Ag, Stamford Branch as Collateral Agent
    Transactions
    • 15 sept. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 17 août 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 02 sept. 2014
    Livré le 15 sept. 2014
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Registered no: 2999472. application no:76327821. Please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Ubs Ag, Stamford Branch as Collateral Agent
    Transactions
    • 15 sept. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 17 août 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 02 sept. 2014
    Livré le 15 sept. 2014
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Registered no: 2999472. application no:76327821. Please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Ubs Ag, Stamford Branch as Collateral Agent
    Transactions
    • 15 sept. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 17 août 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 14 avr. 2003
    Livré le 17 avr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 17 avr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 févr. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage debenture
    Créé le 14 juin 1993
    Livré le 21 juin 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 21 juin 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 août 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0