CONSUMER ADVANTAGE LTD

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCONSUMER ADVANTAGE LTD
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02763680
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CONSUMER ADVANTAGE LTD ?

    • (7487) /

    Où se situe CONSUMER ADVANTAGE LTD ?

    Adresse du siège social
    Ambassador House
    2 White Kennett Street
    E1 7BS London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CONSUMER ADVANTAGE LTD ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SALISBURY COMMUNICATIONS LIMITED03 avr. 200003 avr. 2000
    SALISBURY ASSOCIATES LIMITED08 févr. 199308 févr. 1993
    PODFIELD LIMITED11 nov. 199211 nov. 1992

    Quels sont les derniers comptes de CONSUMER ADVANTAGE LTD ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2001

    Quels sont les derniers dépôts pour CONSUMER ADVANTAGE LTD ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    La procédure de radiation d'office a été suspendue

    1 pagesDISS16(SOAS)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Nomination d'un liquidateur

    1 pages4.31

    Ordonnance du tribunal avis de liquidation

    2 pagesF14

    Divers

    Written res re: SECT381(a) w/up
    1 pagesMISC

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages288b

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages225

    Certificat de changement de nom

    Company name changed salisbury communications LIMITED\certificate issued on 15/02/02
    2 pagesCERTNM

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    7 pages363s
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    annual-return14 nov. 2001

    legacy

    363(288)

    Comptes annuels établis au 30 juin 2001

    14 pagesAA

    legacy

    2 pages88(2)R

    legacy

    2 pages88(2)R

    legacy

    2 pages88(2)R

    legacy

    3 pages395

    legacy

    12 pages363s
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    annual-return19 déc. 2000

    legacy

    363(288)

    Comptes annuels établis au 30 juin 2000

    15 pagesAA

    legacy

    2 pages288a

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    legacy

    1 pages225

    Qui sont les dirigeants de CONSUMER ADVANTAGE LTD ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HANCOCK, David Arthur
    24 Malwood Road
    SW12 8EN London
    Administrateur
    24 Malwood Road
    SW12 8EN London
    British43635030001
    ANTRAM, Carline
    6 Yule Close
    Bricket Wood
    AL2 3XZ St Albans
    Hertfordshire
    Secrétaire
    6 Yule Close
    Bricket Wood
    AL2 3XZ St Albans
    Hertfordshire
    British27422370001
    FORBES, Andrew
    12 Denham Green Place
    EH5 3PB Edinburgh
    Secrétaire
    12 Denham Green Place
    EH5 3PB Edinburgh
    British42335140001
    STANLEY, David George Edward
    34 Holden Corner
    Southborough
    TN4 0LP Tunbridge Wells
    Kent
    Secrétaire
    34 Holden Corner
    Southborough
    TN4 0LP Tunbridge Wells
    Kent
    British42761910001
    LARPENT NEWTON & COMPANY LIMITED
    4th Floor
    24-26 Baltic Street West
    EC1Y 0UR London
    Secrétaire
    4th Floor
    24-26 Baltic Street West
    EC1Y 0UR London
    14160390001
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Secrétaire désigné
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    SPENCER
    50 Church Road
    Ramsden Heath
    CM11 1PA Billericay
    Essex
    Secrétaire
    50 Church Road
    Ramsden Heath
    CM11 1PA Billericay
    Essex
    57788120001
    ANTRAM, Carline
    6 Yule Close
    Bricket Wood
    AL2 3XZ St Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    6 Yule Close
    Bricket Wood
    AL2 3XZ St Albans
    Hertfordshire
    British27422370001
    BISHOP, Leslie Albert
    Little Germains
    Fullers Hill
    HP5 1LS Chesham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Little Germains
    Fullers Hill
    HP5 1LS Chesham
    Buckinghamshire
    British7970540001
    BISHOP, Leslie Albert
    Little Germains
    Fullers Hill
    HP5 1LS Chesham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Little Germains
    Fullers Hill
    HP5 1LS Chesham
    Buckinghamshire
    British7970540001
    BISHOP, Leslie Albert
    Little Germains
    Fullers Hill
    HP5 1LS Chesham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Little Germains
    Fullers Hill
    HP5 1LS Chesham
    Buckinghamshire
    British7970540001
    BREESE, Charles Jonathon
    Steane Grounds Farm
    Steane
    NN13 5NP Brackley
    Northamptonshire
    Administrateur
    Steane Grounds Farm
    Steane
    NN13 5NP Brackley
    Northamptonshire
    United KingdomBritish33215780004
    CATTELL, Michael Guthrie
    Silverwood Townfield Lane
    CH1 6LB Chester
    Cheshire
    Administrateur
    Silverwood Townfield Lane
    CH1 6LB Chester
    Cheshire
    EnglandBritish52412370003
    CATTELL, Michael Guthrie
    Silverwood Townfield Lane
    CH1 6LB Chester
    Cheshire
    Administrateur
    Silverwood Townfield Lane
    CH1 6LB Chester
    Cheshire
    EnglandBritish52412370003
    FORBES, Andrew
    12 Denham Green Place
    EH5 3PB Edinburgh
    Administrateur
    12 Denham Green Place
    EH5 3PB Edinburgh
    ScotlandBritish42335140001
    HALL, Peter Laurence
    Holly House
    Sherbourne Place
    CV32 5SW Leamington Spa
    Warwickshire
    Administrateur
    Holly House
    Sherbourne Place
    CV32 5SW Leamington Spa
    Warwickshire
    British102708210001
    QUINLAN, Ian
    1 Linden Court
    Middleton Road
    GU15 3TU Camberley
    Surrey
    Administrateur
    1 Linden Court
    Middleton Road
    GU15 3TU Camberley
    Surrey
    British2521720001
    SMITH, Martyn Gregory Leigh
    53 Durnsford Avenue
    GU52 7TA Fleet
    Hampshire
    Administrateur
    53 Durnsford Avenue
    GU52 7TA Fleet
    Hampshire
    EnglandBritish77538260001
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Administrateur désigné
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001500001
    SPENCER
    50 Church Road
    Ramsden Heath
    CM11 1PA Billericay
    Essex
    Administrateur
    50 Church Road
    Ramsden Heath
    CM11 1PA Billericay
    Essex
    57788120001

    CONSUMER ADVANTAGE LTD a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Rent deposit deed
    Créé le 08 déc. 2000
    Livré le 19 déc. 2000
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease dated 19TH may 2000
    Brèves mentions
    All monies (including all interest accruing THERET0) standing to the credit of a bank deposit account opened by the chargee in which the sum of £63,855 has been deposited.
    Personnes ayant droit
    • M1 Limited
    Transactions
    • 19 déc. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    Mortgage debenture
    Créé le 24 févr. 1998
    Livré le 17 mars 1998
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 17 mars 1998Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 04 déc. 1995
    Livré le 07 déc. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Yorkshire Bank PLC
    Transactions
    • 07 déc. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 juin 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deposit deed
    Créé le 25 nov. 1994
    Livré le 14 déc. 1994
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease of even date
    Brèves mentions
    All the interest in the deposit account and all money from time to time withdrawn therefrom.
    Personnes ayant droit
    • Ndemi Investments Limited
    Transactions
    • 14 déc. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    Mortgage debenture
    Créé le 24 août 1994
    Livré le 30 août 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 30 août 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 juin 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 24 févr. 1993
    Livré le 05 mars 1993
    En cours
    Montant garanti
    £50,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this debenture
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • Larpent Newton & Co.Limited
    Transactions
    • 05 mars 1993Enregistrement d'une charge (395)

    CONSUMER ADVANTAGE LTD a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    31 juil. 2003Petition date
    17 sept. 2003Commencement of winding up
    Compulsory liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Timothy James Bramston
    Kingston Smith & Partners
    105 St Peter'S Street
    ALI 3EJ St Albans
    Hertfordshire
    practitioner
    Kingston Smith & Partners
    105 St Peter'S Street
    ALI 3EJ St Albans
    Hertfordshire
    The Official Receiver Or London
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS
    practitioner
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS
    Nicholas John Miller
    Kingston Smith & Partners Llp
    Devonshire House
    EC1M 7AD 60 Goswell Road
    London
    practitioner
    Kingston Smith & Partners Llp
    Devonshire House
    EC1M 7AD 60 Goswell Road
    London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0