SCHAEFF LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSCHAEFF LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02763681
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SCHAEFF LIMITED ?

    • Autres activités de services n.c.a. (96090) / Autres activités de services

    Où se situe SCHAEFF LIMITED ?

    Adresse du siège social
    The Pinnacle
    170 Midsummer Boulevard
    MK9 1FE Milton Keynes
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SCHAEFF LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    POLYPLAN LIMITED11 nov. 199211 nov. 1992

    Quels sont les derniers comptes de SCHAEFF LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2022

    Quels sont les derniers dépôts pour SCHAEFF LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Satisfaction de la charge 1 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 2 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    1 pagesMR04

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Scott Jonathan Posner le 12 août 2023

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Scott Jonathan Posner le 12 août 2023

    1 pagesCH03

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2022

    9 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 11 nov. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2021

    8 pagesAA

    Cessation de la nomination de John Daniel Sheehan en tant que directeur le 31 déc. 2021

    1 pagesTM01

    Nomination de Julie Ann Beck en tant qu'administrateur le 31 déc. 2021

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 11 nov. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2020

    7 pagesAA

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2019

    7 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 11 nov. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Eric I Cohen en tant que secrétaire le 31 déc. 2019

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Eric I Cohen en tant que directeur le 31 déc. 2019

    1 pagesTM01

    Nomination de Scott Jonathan Posner en tant que secrétaire le 31 déc. 2019

    2 pagesAP03

    Nomination de Scott Jonathan Posner en tant qu'administrateur le 31 déc. 2019

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 11 nov. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018

    7 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de SCHAEFF LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    POSNER, Scott Jonathan
    Glover Avenue
    4th Floor
    06850 Norwalk
    45
    Connecticut
    United States
    Secrétaire
    Glover Avenue
    4th Floor
    06850 Norwalk
    45
    Connecticut
    United States
    265672730001
    BECK, Julie Ann
    4th Floor
    06850 Norwalk
    45 Glover Avenue
    United States
    Administrateur
    4th Floor
    06850 Norwalk
    45 Glover Avenue
    United States
    United StatesAmericanSenior Vice President - Finance291080940001
    POSNER, Scott Jonathan
    Glover Avenue
    4th Floor
    06850 Norwalk
    45
    Connecticut
    United States
    Administrateur
    Glover Avenue
    4th Floor
    06850 Norwalk
    45
    Connecticut
    United States
    United StatesAmericanLawyer264901900001
    ADAMI, Oliver
    Weinstrasse 77
    Erlenbach
    74235
    Germany
    Secrétaire
    Weinstrasse 77
    Erlenbach
    74235
    Germany
    German65547770001
    COHEN, Eric I
    Burnham Hill Road
    Westport
    Connecticut, 06880
    32
    Fairfield
    United States
    Secrétaire
    Burnham Hill Road
    Westport
    Connecticut, 06880
    32
    Fairfield
    United States
    AmericanLawyer65582430009
    MOUNTFORD, Richard
    Quaker House 19 Quaker Close
    Wath Upon Dearne
    S63 6LQ Rotherham
    South Yorkshire
    Secrétaire
    Quaker House 19 Quaker Close
    Wath Upon Dearne
    S63 6LQ Rotherham
    South Yorkshire
    British30399850001
    WETTER, Ulrich
    39 Turton Heights
    BL2 3DU Bolton
    Lancashire
    Secrétaire
    39 Turton Heights
    BL2 3DU Bolton
    Lancashire
    GermanCompany Director69221890001
    WYMER, Maurice Craig
    11 Chapel Close
    Skelmanthorpe
    HD8 9AT Huddersfield
    Secrétaire
    11 Chapel Close
    Skelmanthorpe
    HD8 9AT Huddersfield
    New ZealanderFinancial Controller67583380003
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Secrétaire désigné
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    ADAMI, Oliver
    Weinstrasse 77
    Erlenbach
    74235
    Germany
    Administrateur
    Weinstrasse 77
    Erlenbach
    74235
    Germany
    GermanChief Controller Schaeff Group65547770001
    APUZZO, Joseph
    190 Sturges Ridge Road
    Wilton
    Fairfield
    06897
    Usa
    Administrateur
    190 Sturges Ridge Road
    Wilton
    Fairfield
    06897
    Usa
    AmericanExecutive66269020001
    BAILLIE, Fergus Cumming
    4 Abinger Gardens
    Murrayfield
    EH12 6DE Edinburgh
    Scotland
    Administrateur
    4 Abinger Gardens
    Murrayfield
    EH12 6DE Edinburgh
    Scotland
    BritishCompany Director924340002
    BRADLEY, Kevin Patrick
    Hickory Lane
    Connecticut 06824
    32
    Fairfield
    Usa
    Administrateur
    Hickory Lane
    Connecticut 06824
    32
    Fairfield
    Usa
    Untied States Of AmericaAmericanSenior Vice President, Chief Financial Officer176590390001
    COHEN, Eric I
    Burnham Hill Road
    Westport
    Connecticut, 06880
    32
    Fairfield
    United States
    Administrateur
    Burnham Hill Road
    Westport
    Connecticut, 06880
    32
    Fairfield
    United States
    United StatesAmericanLawyer65582430009
    DEFEO, Ronald Matthew
    Beachside Avenue
    Westport
    45
    Connecticut 06880
    Usa
    Administrateur
    Beachside Avenue
    Westport
    45
    Connecticut 06880
    Usa
    United StatesAmericanDirector94656950001
    PRIEDEMANN, Udo Wolfgang
    Ritzwiesen Str 35
    Riegelsberg 66292
    Germany
    Administrateur
    Ritzwiesen Str 35
    Riegelsberg 66292
    Germany
    GermanDirector Controlling74633840001
    ROBERTSON, Colin
    4 Leemuir View
    ML8 4AN Carluke
    South Lanarkshire
    Administrateur
    4 Leemuir View
    ML8 4AN Carluke
    South Lanarkshire
    BritishDirector77076440001
    SCHAEFF, Alexander
    Oedenbuehlsteige 12
    Schwaebisch Hall 74523
    Germany
    Administrateur
    Oedenbuehlsteige 12
    Schwaebisch Hall 74523
    Germany
    GermanManaging Director67583320001
    SHEEHAN, John Daniel
    200 Nyala Farm Road
    06880 Westport
    C/O Terex Corporation
    United States
    Administrateur
    200 Nyala Farm Road
    06880 Westport
    C/O Terex Corporation
    United States
    United StatesAmericanChief Financial Officer226001330001
    STEHR, Leo
    Suhlweg 45
    7183 Langenburg
    Germany
    Administrateur
    Suhlweg 45
    7183 Langenburg
    Germany
    GermanCompany Director32022420001
    WETTER, Ulrich
    39 Turton Heights
    BL2 3DU Bolton
    Lancashire
    Administrateur
    39 Turton Heights
    BL2 3DU Bolton
    Lancashire
    GermanCompany Director69221890001
    WIDMAN, Phillip Charles
    25 Old Stone Crossing
    West Simsbury
    Connecticut 06092
    Usa
    Administrateur
    25 Old Stone Crossing
    West Simsbury
    Connecticut 06092
    Usa
    UsaAmericanDirector144249950001
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Administrateur désigné
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001500001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SCHAEFF LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Terex Corporation
    Suite 400
    Wilmington
    2711 Centerville Road
    De
    United States
    06 avr. 2016
    Suite 400
    Wilmington
    2711 Centerville Road
    De
    United States
    Non
    Forme juridiqueCorporation
    Pays d'enregistrementUnited States
    Autorité légaleThe Laws Of United States
    Lieu d'enregistrementUnited States
    Numéro d'enregistrement333-144796
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.

    SCHAEFF LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Assignment
    Créé le 08 août 1996
    Livré le 16 août 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the hire purchase agreement dated 25TH march 1996
    Brèves mentions
    All right title interest and benefit in the lease including all rights to receive payments including all rights to serve notices and/or make demands thereunder and all rights of action in respect of any breach thereof and all rights to receive damages or obtain relief in respect thereo. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Jcb Credit Limited
    Transactions
    • 16 août 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 sept. 2023Satisfaction d'une charge (MR04)
    Assignment
    Créé le 08 août 1996
    Livré le 16 août 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the hire purchase agreement dated 25TH march 1996
    Brèves mentions
    All right title interest and benefit in the lease including all rights to receive payments including all rights to serve notices and/or make demands thereunder and all rights of action in respect of any breach thereof and all rights to receive damages or obtain relief in respect thereo. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Jcb Credit Limited
    Transactions
    • 16 août 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 sept. 2023Satisfaction d'une charge (MR04)
    Assignment
    Créé le 08 août 1996
    Livré le 16 août 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the hire purchase agreement dated 25TH july 1996
    Brèves mentions
    All right title interest and benefit in the lease including all rights to receive payments including all rights to serve notices and/or make demands thereunder and all rights of action in respect of any breach thereof and all rights to receive damages or obtain relief in respect thereo. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Jcb Credit Limited
    Transactions
    • 16 août 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 sept. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over rental agreement
    Créé le 15 mars 1996
    Livré le 19 mars 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the rental agreement dated 31ST october 1993
    Brèves mentions
    All rights title interest and benefit present and future of the assignor in the lease including all rights to receive payment:-re one fuchs mhl 350 mobile loading machine serial number 2250/20/0159. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Jcb Credit Limited
    Transactions
    • 19 mars 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 sept. 2023Satisfaction d'une charge (MR04)
    Charge over rental agreement
    Créé le 31 mars 1994
    Livré le 18 avr. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease agreement or in any manner whatsoever
    Brèves mentions
    All right title interest and benefit present and future of the assignor in the lease including all rights to receive payments of whatsoever nature thereunder.rental agreement dated 1.2.94 in respect of the hire of one fuchs F350R tracked loading machine,serial no.3500 500 003.
    Personnes ayant droit
    • Jcb Credit LTD.
    Transactions
    • 18 avr. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 sept. 2023Satisfaction d'une charge (MR04)
    Charge over rental agreement
    Créé le 31 mars 1994
    Livré le 18 avr. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease agreement or in any manner whatsoever
    Brèves mentions
    All right title interest and benefit present and future of the assignor in the lease including all rights to receive payments of whatsoever nature thereunder.rental agreement dated 31.10.93 in respect of the hire of one fuchs L350M loading machine,serial no.2250/20/0055.
    Personnes ayant droit
    • Jcb Credit LTD.
    Transactions
    • 18 avr. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 sept. 2023Satisfaction d'une charge (MR04)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0