SANDBECK MOTORS (WETHERBY) LIMITED

SANDBECK MOTORS (WETHERBY) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSANDBECK MOTORS (WETHERBY) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02766185
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SANDBECK MOTORS (WETHERBY) LIMITED ?

    • Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82990) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe SANDBECK MOTORS (WETHERBY) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Nidd Vale Motors Limited
    Nidd Vale Corner 91 Leeds Road
    HG2 8EY Harrogate
    North Yorkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SANDBECK MOTORS (WETHERBY) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    UPPINGTON (WETHERBY) LIMITED17 févr. 199317 févr. 1993
    HART (POULTON-LE-FYLDE) LIMITED 20 nov. 199220 nov. 1992

    Quels sont les derniers comptes de SANDBECK MOTORS (WETHERBY) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour SANDBECK MOTORS (WETHERBY) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 sept. 2012 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital25 sept. 2012

    État du capital au 25 sept. 2012

    • Capital: GBP 346,070
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Nigel Waite Pullan le 31 juil. 2012

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Nigel Waite Pullan le 31 juil. 2012

    1 pagesCH03

    Période comptable actuelle raccourcie du 31 déc. 2011 au 30 juin 2011

    1 pagesAA01

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2010

    10 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 sept. 2011 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 sept. 2010 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01

    Nomination de Mr Neil Martin Crossley en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2009

    9 pagesAA

    Cessation de la nomination de Paul Stokes en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2008

    8 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages288c

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2007

    9 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    2 pages288c

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'assistance financière pour l'acquisition d'actions

    RES07

    legacy

    8 pages363s

    legacy

    9 pages155(6)a

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    3 pages288a

    Qui sont les dirigeants de SANDBECK MOTORS (WETHERBY) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    PULLAN, Nigel Waite
    C/O Nidd Vale Motors Limited
    Nidd Vale Corner 91 Leeds Road
    HG2 8EY Harrogate
    North Yorkshire
    Secrétaire
    C/O Nidd Vale Motors Limited
    Nidd Vale Corner 91 Leeds Road
    HG2 8EY Harrogate
    North Yorkshire
    BritishComapny Director79509270001
    CROSSLEY, Neil Martin
    C/O Nidd Vale Motors Limited
    Nidd Vale Corner 91 Leeds Road
    HG2 8EY Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    C/O Nidd Vale Motors Limited
    Nidd Vale Corner 91 Leeds Road
    HG2 8EY Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritishManaging Director155003300001
    JACKSON, Charles Richard
    Loftus Hill
    Ferrensby
    HG5 9JT Knaresborough
    North Yorkshire
    Administrateur
    Loftus Hill
    Ferrensby
    HG5 9JT Knaresborough
    North Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director1676810002
    PULLAN, Nigel Waite
    C/O Nidd Vale Motors Limited
    Nidd Vale Corner 91 Leeds Road
    HG2 8EY Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    C/O Nidd Vale Motors Limited
    Nidd Vale Corner 91 Leeds Road
    HG2 8EY Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director79509270002
    WATSON, Tony Mortimer
    8 Stump Cross
    Boroughbridge
    YO51 9HU York
    North Yorkshire
    Administrateur
    8 Stump Cross
    Boroughbridge
    YO51 9HU York
    North Yorkshire
    United KingdomBritishAccounts Director91716790001
    JACKSON, Charles Richard
    Loftus Hill
    Ferrensby
    HG5 9JT Knaresborough
    North Yorkshire
    Secrétaire
    Loftus Hill
    Ferrensby
    HG5 9JT Knaresborough
    North Yorkshire
    BritishCompany Director1676810002
    SMITH, Robert John
    Fairfield Layton Road
    Horsforth
    LS18 5ET Leeds
    Secrétaire
    Fairfield Layton Road
    Horsforth
    LS18 5ET Leeds
    BritishCompany Director7211250002
    STOKES, Paul
    Rose Cottage
    Water End Brompton
    DL6 2RN Northallerton
    Secrétaire
    Rose Cottage
    Water End Brompton
    DL6 2RN Northallerton
    BritishCommercial Director90970840003
    MOTORS DIRECTORS LIMITED
    4 Chiswell Street
    EC1Y 4UP London
    Secrétaire
    4 Chiswell Street
    EC1Y 4UP London
    69096550002
    MOTORS SECRETARIES LIMITED
    6th Floor Thavies Inn House
    3-4 Holborn Circus
    EC1N 2HA London
    Secrétaire
    6th Floor Thavies Inn House
    3-4 Holborn Circus
    EC1N 2HA London
    50844980001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BROWN, Jonathan Thomas
    39 Cannon Street
    AL3 5JR St Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    39 Cannon Street
    AL3 5JR St Albans
    Hertfordshire
    BritishSolicitor56279550001
    CLARK, Simon Nicholas
    16 Oakdale Manor
    HG1 2NA Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    16 Oakdale Manor
    HG1 2NA Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritishDirector91716650001
    GLADWIN, Peter William
    Lakeside Lodge
    79 Wedgwood Avenue Blakelands
    MK14 5JZ Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Lakeside Lodge
    79 Wedgwood Avenue Blakelands
    MK14 5JZ Milton Keynes
    Buckinghamshire
    BritishInvestment Manager26965400002
    GORDON, Ray
    19 Skelwith Drive
    Wincobank
    S4 8BN Sheffield
    Administrateur
    19 Skelwith Drive
    Wincobank
    S4 8BN Sheffield
    BritishService Director92008080001
    HAINSTOCK, Colin George
    Pheasants Hill
    Kilburn
    YO61 4AG York
    Administrateur
    Pheasants Hill
    Kilburn
    YO61 4AG York
    BritishCompany Director94619630001
    HARVEY, John
    146 Altrincham Road
    SK9 5NQ Wilmslow
    Cheshire
    Administrateur
    146 Altrincham Road
    SK9 5NQ Wilmslow
    Cheshire
    BritishInvestment Manager1306000001
    HICKS, Jeremy Christopher
    48 Station Road
    Woburn Sands
    MK17 8RU Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Administrateur
    48 Station Road
    Woburn Sands
    MK17 8RU Milton Keynes
    Buckinghamshire
    BritishInvestment Manager31366620002
    JACKSON, Charles Richard
    Loftus Hill
    Ferrensby
    HG5 9JT Knaresborough
    North Yorkshire
    Administrateur
    Loftus Hill
    Ferrensby
    HG5 9JT Knaresborough
    North Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director1676810002
    JACKSON, John David
    Red Oaks Manor House Lane
    LS17 9JD Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    Red Oaks Manor House Lane
    LS17 9JD Leeds
    West Yorkshire
    BritishDirector1051970002
    PULLAN, Nigel Waite
    Firs Drive
    HG2 9HB Harrogate
    18
    North Yorkshire
    Administrateur
    Firs Drive
    HG2 9HB Harrogate
    18
    North Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director79509270001
    SMITH, Robert John
    Fairfield Layton Road
    Horsforth
    LS18 5ET Leeds
    Administrateur
    Fairfield Layton Road
    Horsforth
    LS18 5ET Leeds
    United KingdomBritishCompany Director7211250002
    STOKES, Paul
    Becca Lane
    Aberford
    LS25 3BD Leeds
    Becca House
    West Yorkshire
    Administrateur
    Becca Lane
    Aberford
    LS25 3BD Leeds
    Becca House
    West Yorkshire
    EnglandBritishCommercial Director90970840006
    UPPINGTON, William John
    Windrush Cottage
    Syke Lane, Scarcroft
    LS14 3BQ Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    Windrush Cottage
    Syke Lane, Scarcroft
    LS14 3BQ Leeds
    West Yorkshire
    BritishManaging Director33965130001
    WALKER, Ian Geoffrey
    17 Newcastle Close
    Drighlington
    BD11 1DF Bradford
    West Yorkshire
    Administrateur
    17 Newcastle Close
    Drighlington
    BD11 1DF Bradford
    West Yorkshire
    BritishDirector91715880001

    SANDBECK MOTORS (WETHERBY) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 01 août 2003
    Livré le 05 août 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land at sandbeck lane and deighton road wetherby t/n WYK532593, WYK95425, WYK83540 and WYK721531. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 05 août 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 avr. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 01 août 2003
    Livré le 05 août 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 05 août 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 avr. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 03 mars 2000
    Livré le 11 mars 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 11 mars 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 août 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 08 juin 1993
    Livré le 22 juin 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 22 juin 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 août 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 08 juin 1993
    Livré le 15 juin 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Sandbeck garage deighton road wetherby W.yorks. And 14,16,18,deighton road aforesaid proceeds of sale and assignment of goodwill and benefit of all licences t/n wyk 85215. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 15 juin 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 août 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 08 juin 1993
    Livré le 11 juin 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Vauxhall Motors Limited
    Transactions
    • 11 juin 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 août 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0