MORTAR INVESTMENTS INTERNATIONAL LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | MORTAR INVESTMENTS INTERNATIONAL LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 02767051 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe MORTAR INVESTMENTS INTERNATIONAL LIMITED ?
| Adresse du siège social | The Akzonobel Building Wexham Road SL2 5DS Slough United Kingdom |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de MORTAR INVESTMENTS INTERNATIONAL LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 30 déc. 2025 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour MORTAR INVESTMENTS INTERNATIONAL LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 13 juin 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 27 juin 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 13 juin 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour MORTAR INVESTMENTS INTERNATIONAL LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Comptes annuels établis au 31 déc. 2024 | 20 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 13 juin 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Nomination de Mr Vaibhav Ahuja en tant qu'administrateur le 21 mai 2025 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de David Upton en tant que directeur le 05 mars 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2023 | 20 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 13 juin 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Nomination de Mr David Upton en tant qu'administrateur le 22 mai 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Michael Smalley en tant que directeur le 07 mai 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Benjamin Williams en tant que directeur le 31 déc. 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2022 | 20 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 13 juin 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2021 | 20 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 13 juin 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2020 | 20 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 13 juin 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2019 | 18 pages | AA | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2018 | 18 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de David Allan Turner en tant que directeur le 01 sept. 2020 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mr Benjamin Williams en tant qu'administrateur le 01 sept. 2020 | 2 pages | AP01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 30 mai 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 16 mai 2019 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||
Nomination de David Allan Turner en tant qu'administrateur le 31 août 2018 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Fergal Joseph O'shea en tant que directeur le 31 août 2018 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2017 | 18 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Lynette Jean Cherryl Carter en tant que secrétaire le 31 mai 2018 | 1 pages | TM02 | ||
Qui sont les dirigeants de MORTAR INVESTMENTS INTERNATIONAL LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHUJA, Vaibhav, Mr. | Administrateur | Wexham Road SL2 5DS Slough The Akzonobel Building United Kingdom | England | Indian | 327784660001 | |||||
| RAY, Stephen Bruce | Administrateur | Wexham Road SL2 5DS Slough The Akzonobel Building United Kingdom | England | British | 177266980002 | |||||
| CARTER, Lynette Jean Cherryl | Secrétaire | Wexham Road SL2 5DS Slough The Akzonobel Building United Kingdom | 232329760001 | |||||||
| CHEATLE, Penelope Anne | Secrétaire | 9 Cherry Court 2a St Johns Road DA14 4HB Sidcup Kent | British | 34645590001 | ||||||
| DAVIS, Philip Stephen James | Secrétaire | Two Pearman Cottages 29 Chertsey Road GU24 8PD Chobham Surrey | British | 71932630001 | ||||||
| GROSSET, Margaret Wilhelmina | Secrétaire | 7 Arnprior Place KA7 4PT Alloway Ayrshire | British | 54009620001 | ||||||
| GROSSET, Margaret Wilhelmina | Secrétaire | 7 Arnprior Place KA7 4PT Alloway Ayrshire | British | 54009620001 | ||||||
| LACHLAN, Cacilia Maria | Secrétaire désigné | 10 Guernsey Farm Drive Horsell Rise GU21 4BE Woking Surrey | British | 900008880001 | ||||||
| MCCARTHY, Anne Patricia | Secrétaire | 46 Torcross Road HA4 0TD South Ruislip Middlesex | British | 8702280009 | ||||||
| SPARKS, Raymond Richard | Secrétaire | 19 Queens Road Byfleet KT14 7AD West Byfleet Surrey | British | 35662370002 | ||||||
| THORN-DAVIS, Scott Peter | Secrétaire | 5 Latham Road TW1 1BN Twickenham Middlesex | British | 68718610003 | ||||||
| TURNER, George St John | Secrétaire | The Manse Main Street PE28 0QR Bythorn Cambridgeshire | British | 88865090002 | ||||||
| O.H. SECRETARIAT LIMITED | Secrétaire | Wexham Road SL2 5DS Slough The Akzonobel Building United Kingdom | 129226660002 | |||||||
| BLACKWOOD, David Charles | Administrateur | 7 Mizen Close KT11 2RJ Cobham Surrey | United Kingdom | British, | 69535430001 | |||||
| BLOK, Harm | Administrateur | Bressenden Place SW1E 5BG London 26th Floor Portland House | The Netherlands | Dutch | 176466280001 | |||||
| BOLLAND, Christopher | Administrateur | Bressenden Place SW1E 5BG London 26th Floor Portland House | United Kingdom | British | 111301880002 | |||||
| BOURNE, Anthony John, Dr | Administrateur | 138 Cambridge Street SW1V 4QF London | England | British | 12074490001 | |||||
| CHANDLER, Allan Illingworth | Administrateur | 95 Silverdale Avenue KT12 1EJ Walton On Thames Surrey | British | 73841170001 | ||||||
| CHARLTON, John Michael | Administrateur | Dunstone 5 Broomfield Ride KT22 0LR Oxshott Surrey | England | British | 73081460001 | |||||
| CHEATLE, Penelope Anne | Administrateur | 9 Cherry Court 2a St Johns Road DA14 4HB Sidcup Kent | British | 34645590001 | ||||||
| CHEATLE, Penelope Anne | Administrateur | 9 Cherry Court 2a St Johns Road DA14 4HB Sidcup Kent | British | 34645590001 | ||||||
| CRIBB, Nigel Rupert Evelyn | Administrateur | 7 White Friars TN13 1QG Sevenoaks Kent | England | British | 77813530002 | |||||
| GEE, David John | Administrateur | Manchester Square W1U 3AN London 20 | England | British | 43451240003 | |||||
| GILLETT, Philip John | Administrateur | Cedar House Rockfield Road RH8 0EJ Oxted Surrey | United Kingdom | British | 6838010001 | |||||
| GRAY, Frederick Philp | Administrateur | Torran 22 The Ridings KT24 5BN East Horsley Surrey | England | British | 11184160001 | |||||
| HERLIHY, Michael Hugh Creedon | Administrateur | Greensands Pine Grove PO19 3PN Chichester West Sussex England | United Kingdom | British | 34548990001 | |||||
| HIRST, John Raymond | Administrateur | 53b Windsor Road SL6 2DN Maidenhead Buckinghamshire | British | 59246220001 | ||||||
| LACHLAN, Cacilia Maria | Administrateur désigné | 10 Guernsey Farm Drive Horsell Rise GU21 4BE Woking Surrey | British | 900008880001 | ||||||
| LADD, Ian Richard | Administrateur | Flat 4, 22 Greencroft Gardens NW6 3LS London | British | 42846300002 | ||||||
| O'SHEA, Fergal Joseph | Administrateur | Wexham Road SL2 5DS Slough The Akzonobel Building United Kingdom | United Kingdom | Irish | 202596380001 | |||||
| RADDER, Helmut Kurt Hans | Administrateur | Flat F 11 Queens Gate Terrace SW7 5PR London | German | 73769570001 | ||||||
| REVILL, Ian | Administrateur | 11 Kevan Drive Send GU23 7BU Woking Surrey | United Kingdom | British | 33088030001 | |||||
| ROSS, Robert Leonard Gordon Knox | Administrateur | Bressenden Place SW1E 5BG London 26th Floor Portland House | United Kingdom | British | 103698440001 | |||||
| SEARLES, David Arthur | Administrateur | Oak Tree Cottage Tower Road Coleshill HP7 0LB Amersham Buckinghamshire | British | 40322970002 | ||||||
| SINGH, Brune | Administrateur | Floor Portland House Bressenden Place SW1E 5BG London 26th United Kingdom | Netherlands | British | 135902980002 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MORTAR INVESTMENTS INTERNATIONAL LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergon Investments Uk Limited | 20 mai 2016 | Wexham Road SL2 5DS Slough The Akzonobel Building Berkshire United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0