KIRKHEATON WIND LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | KIRKHEATON WIND LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 02771937 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe KIRKHEATON WIND LIMITED ?
| Adresse du siège social | Alexander House 1 Mandarin Road Rainton Bridge Business Park DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland England England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de KIRKHEATON WIND LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2021 |
Quels sont les derniers dépôts pour KIRKHEATON WIND LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
La procédure de radiation volontaire a été suspendue. | 1 pages | SOAS(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Nomination de Mr Ian Jessop en tant qu'administrateur le 01 août 2023 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
État du capital au 03 juil. 2023
| 3 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 15 mai 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Laura Katherine Chare en tant que secrétaire le 24 nov. 2022 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Nomination de Ms Melanie Shanker en tant que secrétaire le 24 nov. 2022 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2021 | 32 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr Piero Maggio en tant qu'administrateur le 16 mai 2022 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Pierre-Arthur, Maurice, Michel Lestrade en tant que directeur le 16 mai 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 15 mai 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Mr Pierre-Arthur, Maurice, Michel Lestrade en tant qu'administrateur le 22 déc. 2021 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Matthieu Thomas Hue en tant que directeur le 22 déc. 2021 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2020 | 33 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 15 mai 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Susan Elizabeth Lind en tant que secrétaire le 23 nov. 2020 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Nomination de Mrs Laura Katherine Chare en tant que secrétaire le 23 nov. 2020 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2019 | 31 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 15 mai 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2018 | 29 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de KIRKHEATON WIND LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANKER, Melanie | Secrétaire | 1 Mandarin Road Rainton Bridge Business Park DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland Alexander House England England | 303067320001 | |||||||
| JESSOP, Ian | Administrateur | 1 Mandarin Road Rainton Bridge Business Park DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland Alexander House England England | Scotland | British | 312208460001 | |||||
| MAGGIO, Piero | Administrateur | 1 Mandarin Road, Rainton Bridge Business Park DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland Alexander House England | England | British | 296324960001 | |||||
| MAJID, Hassaan | Administrateur | 1 Mandarin Road Rainton Bridge Business Park DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland Alexander House England England | England | British | 227170770002 | |||||
| CHARE, Laura Katherine | Secrétaire | 1 Mandarin Road Rainton Bridge Business Park DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland Alexander House England England | 280497220001 | |||||||
| ELLIOTT, John | Secrétaire | 18 Frosterley Drive DH3 4SJ Great Lumley County Durham | British | 157550030001 | ||||||
| GILES, Gail Valerie | Secrétaire | North Sundaysight Bellingham NE48 2JE Hexham Northumberland | British | 108926390001 | ||||||
| HIGSON, Robert Ian | Secrétaire | Springfield Calvert Road RH4 1LT Dorking Surrey | British | 61249910002 | ||||||
| KACZOROWSKI, Stephane | Secrétaire | Grosvenor Place Victoria SW1X 7EN London 40 England England | 187107410001 | |||||||
| LIND, Susan Elizabeth | Secrétaire | 1 Mandarin Road Rainton Bridge Business Park DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland Alexander House England England | 200530650001 | |||||||
| SOUTO, Joe | Secrétaire | 40 Grosvenor Place Victoria SW1X 7EN London | 146431380001 | |||||||
| DICKINSON DEES | Secrétaire désigné | St Anns Wharf 112 Quayside NE99 1SB Newcastle Upon Tyne | 900005460001 | |||||||
| ANCEAU, Geraldine Marie Roseline | Administrateur | Grosvenor Place Victoria SW1X 7EN London 40 England England | France | French | 220722130001 | |||||
| BAKER, David Simon George | Administrateur | 40 Grosvenor Place Victoria SW1X 7EN London | United Kingdom | British | 197462530001 | |||||
| CARE, Timothy James | Administrateur désigné | West House Whorlton Hall Farm Westerhope NE5 1NP Newcastle Upon Tyne | British | 900005450001 | ||||||
| CHANDLER, Malcolm George | Administrateur | 40 Earnshaw Way Beaumont Park NE25 9UN Whitley Bay Tyne & Wear | British | 32594940001 | ||||||
| CONNOR, Phillip Eric | Administrateur | Billy Hill House Stanley DL15 9QS Crook County Durham | England | English | 72946860001 | |||||
| CUTTILL, Paul Andrew | Administrateur | 25 Bushey Avenue South Woodford E18 2DT London | British | 116268290001 | ||||||
| DANIELS, Christopher John | Administrateur | Mistletoe Cottage 57 Wickham Hill BN6 9NR Hurstpierpoint West Sussex | British | 72808850001 | ||||||
| DIXON, Adrian | Administrateur | 155 Norwich Road Wroxham NR12 8RZ Norwich Norfolk | United Kingdom | British | 125881320001 | |||||
| FORSTER, Owen John Henry | Administrateur | 1 Mandarin Road Rainton Bridge Business Park DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland Alexander House England England | England | British | 208859480001 | |||||
| FORSTER, Owen John Henry | Administrateur | 1 Mandarin Road Rainton Bridge Business Park DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland Alexander House England England | England | British | 208859480001 | |||||
| GUYLER, Robert | Administrateur | 40 Grosvenor Place Victoria SW1X 7EN London | Scotland | British | 183996210001 | |||||
| HUE, Matthieu Thomas | Administrateur | 1 Mandarin Road Rainton Bridge Business Park DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland Alexander House England England | England | French | 183883770001 | |||||
| LARSEN, Bruno Kold | Administrateur | 40 Grosvenor Place Victoria SW1X 7EN London | Denmark | Danish | 178861250001 | |||||
| LAWLESS, Philip Stewart, Dr | Administrateur | Old Courthouse Kirkwhelpington NE19 2RS Newcastle Upon Tyne | England | British | 92885220001 | |||||
| LAWRENCE, Martin Charles | Administrateur | Grosvenor Place Victoria SW1X 7EN London 40 United Kingdom | England | British | 121114690001 | |||||
| LESTRADE, Pierre-Arthur, Maurice, Michel | Administrateur | 1 Mandarin Road Rainton Bridge Business Park DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland Alexander House England England | Greece | French | 276922120001 | |||||
| LINGE, Kenneth | Administrateur | Drystones Heugh House Lane NE47 6ND Haydon Bridge Northumberland | England | British | 52698930001 | |||||
| LORY, Ronan Emmanuel | Administrateur | 40 Grosvenor Place Victoria SW1X 7EN London | United Kingdom | French | 163104520001 | |||||
| NORMAN, Angus Tindale | Administrateur | 11 Granville Road Walmer CT14 7LU Deal Kent | British | 80532370001 | ||||||
| STILL, David John | Administrateur | Redpath Haltwhistle NE49 0LG Northumberland Ivy Cottage England England | United Kingdom | British | 9482280007 | |||||
| TAYLOR, Richard Charles | Administrateur | 3 King Edwards Court Front Street Tynemouth NE30 4DZ North Shields Tyne & Wear | British | 69207290003 | ||||||
| VERDI, Joseph | Administrateur | Fairlight Cottage Off Holtye Road RH19 3QF East Grinstead West Sussex | British | 103102930001 | ||||||
| WINGROVE, Gerald Langdon | Administrateur | 96 Albert Street NW1 7NE London | United Kingdom | British | 34815220001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur KIRKHEATON WIND LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edf Energy Renewables Holdings Limited | 06 avr. 2016 | 1 Mandarin Road Rainton Bridge Business Park DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland Alexander House England England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0