MSX INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

MSX INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMSX INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02772420
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MSX INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED ?

    • (7499) /

    Où se situe MSX INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    The Octagon
    Middleborough
    CO1 1TG Colchester
    Essex
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MSX INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MSX INTERNATIONAL LIMITED08 nov. 199608 nov. 1996
    MASCOTECH LIMITED20 janv. 199420 janv. 1994
    MASCO INDUSTRIES LIMITED09 mars 199309 mars 1993
    EAST CENTRAL SYSTEMS LIMITED10 déc. 199210 déc. 1992

    Quels sont les derniers comptes de MSX INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour MSX INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2010

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 déc. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital14 déc. 2010

    État du capital au 14 déc. 2010

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2009

    20 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 déc. 2009 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Période comptable précédente prolongée du 31 déc. 2008 au 30 juin 2009

    1 pagesAA01

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes consolidés établis au 31 déc. 2007

    37 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages190

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    1 pages169

    legacy

    3 pages173

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'autorisation d'achat d'actions propres sur capital

    RES08

    legacy

    2 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2006

    17 pagesAA

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution des statuts

    RES01

    legacy

    1 pages287

    Qui sont les dirigeants de MSX INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BIGNALL, John
    Coombe Lane
    HP14 4QR Naphill
    Coombe Farm
    Bucks
    Secrétaire
    Coombe Lane
    HP14 4QR Naphill
    Coombe Farm
    Bucks
    British907580004
    DEL MAR, Sam
    Boxted
    IP29 4JY Bury St. Edmunds
    Street House
    Suffolk
    Administrateur
    Boxted
    IP29 4JY Bury St. Edmunds
    Street House
    Suffolk
    EnglandBritish139074500001
    MINTURN, Frederick Karl
    50 Renaud
    Grosse Pointe Shores
    Mi 48236
    Usa
    Administrateur
    50 Renaud
    Grosse Pointe Shores
    Mi 48236
    Usa
    United StatesAmerican229585020002
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Secrétaire désigné
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    BALLS, Graham Francis
    Beethovenstrasse 71
    71711 Steinheim
    Germany
    Administrateur
    Beethovenstrasse 71
    71711 Steinheim
    Germany
    British46242630001
    BIGNALL, John
    Mistletoe Farm
    Cuckoo Hill
    HA5 2BB Pinner
    Middlesex
    Administrateur
    Mistletoe Farm
    Cuckoo Hill
    HA5 2BB Pinner
    Middlesex
    British907580001
    BILLIG, Erwin Henry
    750 Wallace Street Birmingham
    Michigan 48009
    FOREIGN Usa
    Administrateur
    750 Wallace Street Birmingham
    Michigan 48009
    FOREIGN Usa
    British49978590001
    BILLIG, Erwin Henry
    750 Wallace Street Birmingham
    Michigan 48009
    FOREIGN Usa
    Administrateur
    750 Wallace Street Birmingham
    Michigan 48009
    FOREIGN Usa
    British49978590001
    CREEL, Carol
    111 Royal Avenue
    Royal Oak
    48073 Oakland
    Michigan
    Usa
    Administrateur
    111 Royal Avenue
    Royal Oak
    48073 Oakland
    Michigan
    Usa
    Us Citizen60120810001
    GARNETT, John Stewart
    33 Ashingdon Heights
    SS4 3TH Rochford
    Essex
    Administrateur
    33 Ashingdon Heights
    SS4 3TH Rochford
    Essex
    United KingdomBritish51955170004
    KURTH, Wolfgang
    Im Heisenbusch 8
    51491 Overath
    51491
    Germany
    Administrateur
    Im Heisenbusch 8
    51491 Overath
    51491
    Germany
    German96034130001
    LEGER, Peter Marcel
    1221 Ash Lawn Drive
    Lake Forest
    Illinois Il60045
    Usa
    Administrateur
    1221 Ash Lawn Drive
    Lake Forest
    Illinois Il60045
    Usa
    Us Citizen127145610001
    SHAW, Reginald Dennis
    Pine Croft Lodge Road
    Hurst
    RG10 0SG Reading
    Berkshire
    Administrateur
    Pine Croft Lodge Road
    Hurst
    RG10 0SG Reading
    Berkshire
    British26034160001
    SHAW, Reginald Dennis
    Pine Croft Lodge Road
    Hurst
    RG10 0SG Reading
    Berkshire
    Administrateur
    Pine Croft Lodge Road
    Hurst
    RG10 0SG Reading
    Berkshire
    British26034160001
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Administrateur désigné
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    MSX INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 30 mars 2007
    Livré le 05 avr. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any company to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bny Midwest Trust Company as Trustee and Collateral Agent for the Secured Parties
    Transactions
    • 05 avr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 déc. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 30 juin 2006
    Livré le 12 juil. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The secured liabilities under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Wells Fargo Foothill, Inc
    Transactions
    • 12 juil. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 juin 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental agreement to guarantee and debenture
    Créé le 01 août 2003
    Livré le 18 août 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company msx international limited, msx international australia pty LTD (the australian borrower), msx international netherlands B.V. (the netherlands borrower) to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Bank One Na (The Agent)
    Transactions
    • 18 août 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 oct. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture between msx international limited, msx international holdings limited and bank one, na on behalf of itself and the banks and financial institutions from time to time parties to the secured documents (as defined)
    Créé le 26 avr. 2000
    Livré le 10 mai 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys obligations and liabilities from time to time due owing or incurred by the company under or pursuant to the secured documents, the guarantees and indemnities given by the company under the debenture which secure all the obligations under the secured documents and all other provisions of the debenture
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Bank One Na
    Transactions
    • 10 mai 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 oct. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Pledge agreement
    Créé le 03 janv. 1997
    Livré le 24 janv. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the pledge agreement (which incorporates by reference the bridge credit agreement of 3RD january 1997)
    Brèves mentions
    65 ordinary shares of the company subject to the terms of the pledge agreement with all interest and dividends thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Citycorp Venture Capital Limited
    Transactions
    • 24 janv. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 avr. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0