NURSING PROFESSIONALS LIMITED

NURSING PROFESSIONALS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéNURSING PROFESSIONALS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02774484
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de NURSING PROFESSIONALS LIMITED ?

    • (7450) /

    Où se situe NURSING PROFESSIONALS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Wilkins Kennedy
    Bridge House
    SE1 9QR London Bridge
    London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de NURSING PROFESSIONALS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    WORKBASE RESOURCES LIMITED17 déc. 199217 déc. 1992

    Quels sont les derniers comptes de NURSING PROFESSIONALS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 avr. 2004

    Quels sont les derniers dépôts pour NURSING PROFESSIONALS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 27 avr. 2012

    6 pages4.68

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    3 pages4.72

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 28 janv. 2012

    7 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 28 juil. 2011

    6 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 28 janv. 2011

    6 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 28 juil. 2010

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 28 janv. 2010

    6 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 28 juil. 2009

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 28 janv. 2009

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 28 juil. 2008

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs

    6 pages4.68

    Avis de cessation d'agir en tant que liquidateur volontaire

    1 pages4.40

    Divers

    C/O replacement of liquidator
    6 pagesMISC

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Avis de transition de l'administration à la liquidation volontaire des créanciers

    19 pages2.34B

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    28 pages2.24B

    Résultat de la réunion des créanciers

    3 pages2.23B

    Déclaration des affaires

    5 pages2.16B

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    74 pages2.17B

    legacy

    1 pages287

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    Comptes pour une petite entreprise établis au 30 avr. 2004

    6 pagesAA

    legacy

    7 pages363a

    legacy

    2 pages288a

    Qui sont les dirigeants de NURSING PROFESSIONALS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BENAISSA, Mourad
    6 Craiglands
    AL4 9AH St. Albans
    Hertfordshire
    Secrétaire
    6 Craiglands
    AL4 9AH St. Albans
    Hertfordshire
    BritishDirector84666120001
    NICHOLLS, Clifford Lewis Benjamin
    12a Avenue Road
    AL1 3QQ St Albans
    Hertfordshire
    Secrétaire
    12a Avenue Road
    AL1 3QQ St Albans
    Hertfordshire
    British68543850003
    BARKER, Robert James
    99 Trowley Hill Road
    AL3 8DL Flamstead
    Hertfordshire
    Administrateur
    99 Trowley Hill Road
    AL3 8DL Flamstead
    Hertfordshire
    BritishFinance Director102910860001
    BENAISSA, Mourad
    6 Craiglands
    AL4 9AH St. Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    6 Craiglands
    AL4 9AH St. Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritishDirector84666120001
    BYSOUTH, Susan Elizabeth
    4 Greenbanks
    AL1 1JA St. Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    4 Greenbanks
    AL1 1JA St. Albans
    Hertfordshire
    BritishCompany Director90893690001
    NICHOLLS, Clifford Lewis Benjamin
    12a Avenue Road
    AL1 3QQ St Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    12a Avenue Road
    AL1 3QQ St Albans
    Hertfordshire
    BritishCompany Director68543850003
    REISMAN, Daren James
    8 Forest Heights
    Epping New Road
    IG9 5TE Buckhurst Hill
    Essex
    Administrateur
    8 Forest Heights
    Epping New Road
    IG9 5TE Buckhurst Hill
    Essex
    United KingdomBritishRecruitment Manager90144700002
    BENAISSA, Mourad
    6 Craiglands
    AL4 9AH St. Albans
    Hertfordshire
    Secrétaire
    6 Craiglands
    AL4 9AH St. Albans
    Hertfordshire
    BritishDirector84666120001
    KENNEDY, Irad Ferdinand
    Stonehayes
    Allington
    SN14 6LJ Chippenham
    Wiltshire
    Secrétaire
    Stonehayes
    Allington
    SN14 6LJ Chippenham
    Wiltshire
    British32044460002
    FIRST SECRETARIES LIMITED
    72 New Bond Street
    W1S 1RR London
    Secrétaire désigné
    72 New Bond Street
    W1S 1RR London
    900000780001
    BENAISSA, Mourad
    6 Craiglands
    AL4 9AH St. Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    6 Craiglands
    AL4 9AH St. Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritishDirector84666120001
    KENNEDY, Elizabeth Annette
    Stonehayes
    Allington
    SN14 6LJ Chippenham
    Wiltshire
    Administrateur
    Stonehayes
    Allington
    SN14 6LJ Chippenham
    Wiltshire
    EnglandEnglishFinancial Director32044470002
    KENNEDY, Irad Ferdinand
    Stonehayes
    Allington
    SN14 6LJ Chippenham
    Wiltshire
    Administrateur
    Stonehayes
    Allington
    SN14 6LJ Chippenham
    Wiltshire
    United KingdomBritishTechnical Director (Proposed)32044460002
    PHILLIPS, Charles George
    51 Fir Glen Drive
    Yateley
    GU17 7TR Camberley
    Surrey
    Administrateur
    51 Fir Glen Drive
    Yateley
    GU17 7TR Camberley
    Surrey
    BritishPartner Of A Nursing Agency32044490001
    PHILLIPS, Doreen Marie
    51 Fir Glen Drive
    Yateley
    GU17 7TR Camberley
    Surrey
    Administrateur
    51 Fir Glen Drive
    Yateley
    GU17 7TR Camberley
    Surrey
    BritishPartner Nurses Agency32044500001

    NURSING PROFESSIONALS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 31 mars 2005
    Livré le 02 avr. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Venture Finance PLC
    Transactions
    • 02 avr. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Fixed and floating charge
    Créé le 01 sept. 2004
    Livré le 04 sept. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transactions
    • 04 sept. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 28 févr. 2004
    Livré le 02 mars 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 02 mars 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Fixed and floating charge
    Créé le 18 juil. 2003
    Livré le 19 juil. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transactions
    • 19 juil. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    Rent deposit deed
    Créé le 28 févr. 2000
    Livré le 06 mars 2000
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease dated 28 february 2000
    Brèves mentions
    £2,750.
    Personnes ayant droit
    • Taylor Woodrow Property Company Limited
    Transactions
    • 06 mars 2000Enregistrement d'une charge (395)
    Charge
    Créé le 21 déc. 1999
    Livré le 22 déc. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    A first fixed charge on all book and other debts as are not sold or bought by alex lawrie receivables financing limited under an agreement dated 21 december 1999 and a floating charge all proceeds of book and other debts with the payment of any sum due or owing to alex lawrie receivables financing limited under or in connection with any bill of exchange or other negotiable instrument to which both the company and alex lawrie receivables financing limited are a party.
    Personnes ayant droit
    • Alex Lawrie Receivables Financing Limited
    Transactions
    • 22 déc. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 juil. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 22 mai 1993
    Livré le 29 mai 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 29 mai 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 juin 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    NURSING PROFESSIONALS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    31 janv. 2006Administration started
    29 janv. 2007Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Simon James Underwood
    Wilkins Kennedy
    Bridge House
    SE1 9QR London Bridge
    London
    practitioner
    Wilkins Kennedy
    Bridge House
    SE1 9QR London Bridge
    London
    Keith Aleric Stevens
    Wilkins Kennedy
    Bridge House
    SE1 9QR London Bridge
    London
    practitioner
    Wilkins Kennedy
    Bridge House
    SE1 9QR London Bridge
    London
    2
    DateType
    29 janv. 2007Commencement of winding up
    09 août 2012Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Simon James Underwood
    Wilkins Kennedy
    Bridge House
    SE1 9QR London Bridge
    London
    practitioner
    Wilkins Kennedy
    Bridge House
    SE1 9QR London Bridge
    London
    Keith Aleric Stevens
    Wilkins Kennedy
    Bridge House
    SE1 9QR London Bridge
    London
    practitioner
    Wilkins Kennedy
    Bridge House
    SE1 9QR London Bridge
    London
    Anthony Malcolm Cork
    92 London Street
    RG1 4SJ Reading
    Berkshire
    practitioner
    92 London Street
    RG1 4SJ Reading
    Berkshire

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0