NEWCO9999 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéNEWCO9999 LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02778520
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de NEWCO9999 LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe NEWCO9999 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o STANLEY GIBBONS LTD
    399 Strand
    WC2R 0LX London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de NEWCO9999 LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    DREWEATTS 1759 LIMITED11 nov. 200911 nov. 2009
    BRISTOL AUCTION ROOMS LIMITED11 janv. 199311 janv. 1993

    Quels sont les derniers comptes de NEWCO9999 LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2022

    Quels sont les derniers dépôts pour NEWCO9999 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Cessation de la nomination de Tom Pickford en tant que directeur le 01 août 2023

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Kevin Fitzpatrick en tant que directeur le 01 août 2023

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Kevin Fitzpatrick en tant que secrétaire le 01 août 2023

    1 pagesTM02

    Déclaration de confirmation établie le 11 janv. 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Tom Pickford le 11 janv. 2023

    2 pagesCH01

    Nomination de Mr Tom Pickford en tant qu'administrateur le 01 janv. 2023

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Graham Elliott Shircore en tant que directeur le 01 janv. 2023

    1 pagesTM01

    Comptes de micro-entité établis au 31 mars 2022

    3 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 11 janv. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr Kevin Fitzpatrick en tant qu'administrateur le 15 nov. 2021

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Kevin Fitzpatrick en tant que secrétaire le 15 nov. 2021

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Anthony Michael Gee en tant que secrétaire le 15 nov. 2021

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Anthony Michael Gee en tant que directeur le 15 nov. 2021

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2021

    1 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 11 janv. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr Graham Elliott Shircore en tant qu'administrateur le 02 nov. 2020

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Richard Kenneth Purkis en tant que directeur le 02 nov. 2020

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Anthony Michael Gee en tant que secrétaire le 02 nov. 2020

    2 pagesAP03

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2020

    1 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 11 janv. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2019

    1 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 11 janv. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Qui sont les dirigeants de NEWCO9999 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    EWING, Nicholas Ian Hamilton
    35 Castle Road
    Clevedon
    BS21 7DA Bristol
    Avon
    Secrétaire
    35 Castle Road
    Clevedon
    BS21 7DA Bristol
    Avon
    EnglishChartered Surveyor34310610001
    FITZPATRICK, Kevin
    c/o Stanley Gibbons Ltd
    Strand
    WC2R 0LX London
    399
    Secrétaire
    c/o Stanley Gibbons Ltd
    Strand
    WC2R 0LX London
    399
    289595610001
    FLOYD, Peter John Laurence
    Hadlow Road
    TN9 1QD Tonbridge
    87a
    Kent
    United Kingdom
    Secrétaire
    Hadlow Road
    TN9 1QD Tonbridge
    87a
    Kent
    United Kingdom
    BritishConsultant49924690002
    GEE, Anthony Michael
    c/o Stanley Gibbons Ltd
    Strand
    WC2R 0LX London
    399
    Secrétaire
    c/o Stanley Gibbons Ltd
    Strand
    WC2R 0LX London
    399
    276063690001
    BRISTOL LEGAL SERVICES LIMITED
    Pembroke House
    7 Brunswick Square
    BS2 8PE Bristol
    Avon
    Secrétaire désigné
    Pembroke House
    7 Brunswick Square
    BS2 8PE Bristol
    Avon
    900001040001
    BRAXTON, James William
    Adelphi Terrace
    WC2N 6BJ London
    11
    United Kingdom
    Administrateur
    Adelphi Terrace
    WC2N 6BJ London
    11
    United Kingdom
    United KingdomBritishAuctioneer150022350001
    ELLIOTT SHIRCORE, Graham
    c/o Stanley Gibbons Ltd
    Strand
    WC2R 0LX London
    399
    Administrateur
    c/o Stanley Gibbons Ltd
    Strand
    WC2R 0LX London
    399
    EnglandBritishCompany Executive276026200001
    EWING, Nicholas Ian Hamilton
    35 Castle Road
    Clevedon
    BS21 7DA Bristol
    Avon
    Administrateur
    35 Castle Road
    Clevedon
    BS21 7DA Bristol
    Avon
    EnglandEnglishChartered Surveyor34310610001
    FITZPATRICK, Kevin
    c/o Stanley Gibbons Ltd
    Strand
    WC2R 0LX London
    399
    Administrateur
    c/o Stanley Gibbons Ltd
    Strand
    WC2R 0LX London
    399
    EnglandIrishChief Finance Officer117212260001
    FLOYD, Peter John Laurence
    c/o Stanley Gibbons Ltd
    Strand
    WC2R 0LX London
    399
    England
    Administrateur
    c/o Stanley Gibbons Ltd
    Strand
    WC2R 0LX London
    399
    England
    EnglandBritishConsultant49924690005
    FLOYD, Peter John Laurence
    Hunters Hall Oast
    Cousley Wood
    TN5 6QX Wadhurst
    East Sussex
    Administrateur
    Hunters Hall Oast
    Cousley Wood
    TN5 6QX Wadhurst
    East Sussex
    BritishBusiness Consultant49924690001
    GEE, Anthony Michael
    c/o Stanley Gibbons Ltd
    Strand
    WC2R 0LX London
    399
    Administrateur
    c/o Stanley Gibbons Ltd
    Strand
    WC2R 0LX London
    399
    United KingdomBritishOperations Director181780820001
    LUDWIG, Stephan Carl Eduard
    c/o Stanley Gibbons Ltd
    Strand
    WC2R 0LX London
    399
    England
    Administrateur
    c/o Stanley Gibbons Ltd
    Strand
    WC2R 0LX London
    399
    England
    Great BritainGermanCompany Director63396130002
    MCCLINTOCK, William Ashe
    The Old Vicarage
    Lockerley
    SO51 0JJ Romsey
    Hampshire
    Administrateur
    The Old Vicarage
    Lockerley
    SO51 0JJ Romsey
    Hampshire
    United KingdomBritishChartered Surveyor36110280001
    PICKFORD, Tom
    c/o Stanley Gibbons Ltd
    Strand
    WC2R 0LX London
    399
    Administrateur
    c/o Stanley Gibbons Ltd
    Strand
    WC2R 0LX London
    399
    EnglandBritishChief Executive Officer303763600003
    PURKIS, Richard Kenneth
    c/o Stanley Gibbons Ltd
    Strand
    WC2R 0LX London
    399
    Administrateur
    c/o Stanley Gibbons Ltd
    Strand
    WC2R 0LX London
    399
    EnglandBritishCompany Secretary50467140001
    THOMS, Michael Charles
    Leigh House
    Witherenden Hill
    TN19 7JN Burwash
    East Sussex
    Administrateur
    Leigh House
    Witherenden Hill
    TN19 7JN Burwash
    East Sussex
    EnglandBritishCompany Director67268260002
    BOURSE SECURITIES LIMITED
    Pembroke House
    7 Brunswick Square
    BS2 8PE Bristol
    Avon
    Administrateur désigné
    Pembroke House
    7 Brunswick Square
    BS2 8PE Bristol
    Avon
    900001030001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur NEWCO9999 LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Strand
    WC2R 0LX London
    Stanley Gibbons Limited, 399
    England
    06 avr. 2016
    Strand
    WC2R 0LX London
    Stanley Gibbons Limited, 399
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement03839469
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    NEWCO9999 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 14 juil. 2004
    Livré le 20 juil. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 20 juil. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 mai 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 31 oct. 2003
    Livré le 18 nov. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Stephan Ludwig
    Transactions
    • 18 nov. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 août 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    • 20 déc. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage debenture
    Créé le 11 déc. 1998
    Livré le 21 déc. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. a specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 21 déc. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 févr. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0