MILL LANE ENGINEERING (COACHWORKS) LTD.

MILL LANE ENGINEERING (COACHWORKS) LTD.

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMILL LANE ENGINEERING (COACHWORKS) LTD.
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02778767
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MILL LANE ENGINEERING (COACHWORKS) LTD. ?

    • Commerce de détail de pièces et accessoires pour véhicules automobiles (45320) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles

    Où se situe MILL LANE ENGINEERING (COACHWORKS) LTD. ?

    Adresse du siège social
    102 Sunlight House Quay Street
    M3 3JZ Manchester
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de MILL LANE ENGINEERING (COACHWORKS) LTD. ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour MILL LANE ENGINEERING (COACHWORKS) LTD. ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    16 pagesLIQ14

    Changement d'adresse du siège social de 2nd Floor 33 Blagrave Street Reading RG1 1PW à 102 Sunlight House Quay Street Manchester M3 3JZ le 08 oct. 2019

    2 pagesAD01

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 10 juil. 2019

    17 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 10 juil. 2018

    17 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 10 juil. 2017

    18 pagesLIQ03

    Avis de cessation d'agir en tant que liquidateur volontaire

    1 pages4.40

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 10 juil. 2016

    17 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 10 juil. 2015

    19 pages4.68

    Changement d'adresse du siège social de * 4 St Giles Court Southampton Street Reading RG1 2QL* le 19 févr. 2014

    2 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de * M L G House Blackwater Way Aldershot Hampshire GU12 4DN* le 22 juil. 2013

    1 pagesAD01

    Déclaration des affaires avec le formulaire 4.19 attaché

    8 pages4.20

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation

    LRESEX

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    legacy

    2 pagesMG02

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 janv. 2013 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital14 janv. 2013

    État du capital au 14 janv. 2013

    • Capital: GBP 15,000
    SH01

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Comptes pour une petite entreprise établis au 30 juin 2011

    17 pagesAA

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Cessation de la nomination de Louise May en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 janv. 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    legacy

    3 pagesMG02

    Cessation de la nomination de Tony Rimell en tant que directeur

    1 pagesTM01

    legacy

    8 pagesMG01

    Qui sont les dirigeants de MILL LANE ENGINEERING (COACHWORKS) LTD. ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MAY, Nicholas Martin Samuel
    Cowick Farm
    Hilmarton
    SN11 8RZ Calne
    Wiltshire
    Administrateur
    Cowick Farm
    Hilmarton
    SN11 8RZ Calne
    Wiltshire
    EnglandBritish3462360002
    MAY, Louise Janet
    Cowick Farm
    Hilmarton
    SN11 8RZ Calne
    Wiltshire
    Secrétaire
    Cowick Farm
    Hilmarton
    SN11 8RZ Calne
    Wiltshire
    British58032980003
    SLY, Robin
    10 Hillside Road
    Camelsdale
    GU27 3RL Haslemere
    Surrey
    Secrétaire
    10 Hillside Road
    Camelsdale
    GU27 3RL Haslemere
    Surrey
    British96306510001
    WISEMAN, Shalom David
    2 Woodville Gardens
    Ealing
    W5 2LG London
    Secrétaire
    2 Woodville Gardens
    Ealing
    W5 2LG London
    British32990150001
    CHETTLEBURGH INTERNATIONAL LIMITED
    Temple House
    20 Holywell Row
    EC2A 4JB London
    Secrétaire désigné
    Temple House
    20 Holywell Row
    EC2A 4JB London
    900000860001
    RIMELL, Tony John
    Penrith Road
    RG21 8XE Basingstoke
    21
    Hampshire
    England
    Administrateur
    Penrith Road
    RG21 8XE Basingstoke
    21
    Hampshire
    England
    United KingdomBritish55415300004
    CHETTLEBURGH INTERNATIONAL LIMITED
    Temple House
    20 Holywell Row
    EC2A 4JB London
    Administrateur désigné
    Temple House
    20 Holywell Row
    EC2A 4JB London
    900000860001

    MILL LANE ENGINEERING (COACHWORKS) LTD. a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 18 mai 2011
    Livré le 20 mai 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bibby Financial Services Limited
    Transactions
    • 20 mai 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 27 févr. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    All assets debenture
    Créé le 20 nov. 2008
    Livré le 22 nov. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All assets of the company by way of first fixed and floating charge.
    Personnes ayant droit
    • Eurofactor (UK) Limited
    Transactions
    • 22 nov. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 juin 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Guarantee & debenture
    Créé le 01 déc. 2004
    Livré le 22 déc. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 22 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Mortgage debenture
    Créé le 19 mai 1997
    Livré le 23 mai 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 23 mai 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 oct. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattel mortgage
    Créé le 31 déc. 1996
    Livré le 08 janv. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The plant machinery chattels or other equipment set out in the schedule being xk 120 jaguar chassis no: 660002 together with any part or parts thereof and all additions alterations accessories replacements and renewals of component parts thereto with the benefit of any obligations and warranties and the benefit of all maintenance agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 08 janv. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 août 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Single debenture
    Créé le 27 sept. 1994
    Livré le 03 oct. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Including trade fixtures. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 03 oct. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 août 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 01 févr. 1993
    Livré le 13 févr. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 13 févr. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 oct. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    MILL LANE ENGINEERING (COACHWORKS) LTD. a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    11 juil. 2013Commencement of winding up
    30 juil. 2020Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Paul Douglas Glenn Walker
    Harrisons
    4 St Giles Court
    RG1 2QL Southampton Street
    Reading
    practitioner
    Harrisons
    4 St Giles Court
    RG1 2QL Southampton Street
    Reading
    David Michael Clements
    4 St Giles Court Southampton Street
    RG1 2QL Reading
    Berkshire
    practitioner
    4 St Giles Court Southampton Street
    RG1 2QL Reading
    Berkshire

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0