FREEPORT (NOMINEE 5) LIMITED

FREEPORT (NOMINEE 5) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéFREEPORT (NOMINEE 5) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02787094
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de FREEPORT (NOMINEE 5) LIMITED ?

    • Autre location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués (68209) / Activités immobilières

    Où se situe FREEPORT (NOMINEE 5) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Pwc 7 More London
    Riverside
    SE1 2RT London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de FREEPORT (NOMINEE 5) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    HORNSEA FREEPORT LIMITED19 mars 199319 mars 1993
    DAISYKIRK LIMITED05 févr. 199305 févr. 1993

    Quels sont les derniers comptes de FREEPORT (NOMINEE 5) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2013

    Quels sont les derniers dépôts pour FREEPORT (NOMINEE 5) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    18 pages4.72

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 13 juil. 2016

    18 pages4.68

    Déclaration des affaires avec le formulaire 4.19 attaché

    5 pages4.20

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation au 14 juil. 2015

    LRESEX

    Changement d'adresse du siège social de Lansdowne House 57 Berkeley Square London W1J 6ER à Pwc 7 More London Riverside London SE1 2RT le 03 août 2015

    2 pagesAD01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Cessation de la nomination de Hafiz Mohamed Ali en tant que directeur le 31 août 2014

    2 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mai 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital22 sept. 2014

    État du capital au 22 sept. 2014

    • Capital: GBP 2
    SH01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de 100 Pall Mall London SW1Y 5HP à Lansdown House 57 Berkeley Square London W1J 6ER

    1 pagesAD02

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2013

    6 pagesAA

    Nomination de Hafiz Mohamed Ali en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Robert Hodges en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Robert Konigsberg en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Eric Sasson en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Robert Hodges en tant que secrétaire

    2 pagesTM02

    Nomination de Matthew Lo Russo en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mai 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital05 juin 2013

    État du capital au 05 juin 2013

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2012

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mai 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2011

    6 pagesAA

    legacy

    15 pagesMG01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mai 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Résolutions

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Section 175 18/01/2011
    RES13

    Qui sont les dirigeants de FREEPORT (NOMINEE 5) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    LO RUSSO, Matthew Joseph
    7 More London
    Riverside
    SE1 2RT London
    Pwc
    Administrateur
    7 More London
    Riverside
    SE1 2RT London
    Pwc
    United KingdomAmerican180444800001
    BROWNSTEIN, Ian Jeffrey
    Conifers 59 Deacons Hill Road
    Elstree
    WD6 3HZ Borehamwood
    Hertfordshire
    Secrétaire
    Conifers 59 Deacons Hill Road
    Elstree
    WD6 3HZ Borehamwood
    Hertfordshire
    British44779830001
    HODGES, Robert Edward
    Lansdowne House
    57 Berkeley Square
    W1J 6ER London
    Secrétaire
    Lansdowne House
    57 Berkeley Square
    W1J 6ER London
    British92265800002
    KERSHAW, Christopher Sydney Sagar
    Woodlands Stable Cottage
    77 Sun Street
    BD22 8AH Haworth
    West Yorkshire
    Secrétaire
    Woodlands Stable Cottage
    77 Sun Street
    BD22 8AH Haworth
    West Yorkshire
    British1554150002
    LOVESEY, Morgan David
    6 Moriston Road
    MK41 7UG Bedford
    Bedfordshire
    Secrétaire
    6 Moriston Road
    MK41 7UG Bedford
    Bedfordshire
    British7991670001
    NEWMAN, Richard Henry
    59 Hendon Wood Lane
    Mill Hill
    NW7 4HT London
    Secrétaire
    59 Hendon Wood Lane
    Mill Hill
    NW7 4HT London
    British21881120001
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Secrétaire désigné
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    ALI, Hafiz Mohamed
    Lansdowne House
    57 Berkeley Square
    W1J 6ER London
    Administrateur
    Lansdowne House
    57 Berkeley Square
    W1J 6ER London
    UkCanadian160037050001
    COLLIDGE, Sean Mervyn
    Apartment 4a4 Block B L' Hersilia
    33 Rue Du Portier
    98000 Monaco
    Administrateur
    Apartment 4a4 Block B L' Hersilia
    33 Rue Du Portier
    98000 Monaco
    British38994860002
    HODGES, Robert Edward
    Lansdowne House
    57 Berkeley Square
    W1J 6ER London
    Administrateur
    Lansdowne House
    57 Berkeley Square
    W1J 6ER London
    United KingdomBritish92265800002
    KONIGSBERG, Robert Charles
    Lansdowne House
    57 Berkeley Square
    W1J 6ER London
    Administrateur
    Lansdowne House
    57 Berkeley Square
    W1J 6ER London
    United StatesAmerican157527950001
    LISTER, Robert Stephen
    High Ash Farm West Morton
    BD20 5UP Keighley
    West Yorkshire
    Administrateur
    High Ash Farm West Morton
    BD20 5UP Keighley
    West Yorkshire
    British1554190002
    NEWMAN, Richard Henry
    59 Hendon Wood Lane
    Mill Hill
    NW7 4HT London
    Administrateur
    59 Hendon Wood Lane
    Mill Hill
    NW7 4HT London
    United KingdomBritish21881120001
    RUSSELL, Gary Allan Mason
    Apartment 1181 4th Floor, Palais De
    La Scala 1 Avenue Henri Dunnant
    98000 Monaco
    Administrateur
    Apartment 1181 4th Floor, Palais De
    La Scala 1 Avenue Henri Dunnant
    98000 Monaco
    British57226640002
    SASSON, Eric
    Lansdowne House
    57 Berkeley Square
    W1J 6ER London
    Administrateur
    Lansdowne House
    57 Berkeley Square
    W1J 6ER London
    FranceFrench133392700002
    SWANN, David Sydney
    Greenfield Lane
    DA123LD Shorne
    Green Acre
    Kent
    Administrateur
    Greenfield Lane
    DA123LD Shorne
    Green Acre
    Kent
    United KingdomBritish141368200001
    WOOLLEY, Peter Thomas Griffith
    Apartment 5a2 Block A Le Montaigne
    2 Avenue De La Madone
    98000 Monaco
    Administrateur
    Apartment 5a2 Block A Le Montaigne
    2 Avenue De La Madone
    98000 Monaco
    British39676720009
    YATES, Robert Joseph
    The Square House
    Main Street Burton In Kendal
    LA6 1LX Carnforth
    Lancashire
    Administrateur
    The Square House
    Main Street Burton In Kendal
    LA6 1LX Carnforth
    Lancashire
    British79333850002
    YEWDALL, Neil Stuart
    9 Long Meadows
    Bramhope
    LS16 9DA Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    9 Long Meadows
    Bramhope
    LS16 9DA Leeds
    West Yorkshire
    British17046770001
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Administrateur désigné
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    FREEPORT (NOMINEE 5) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Security agreement
    Créé le 20 sept. 2011
    Livré le 24 sept. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Finance Acquisition No. 1 S.a R.L
    Transactions
    • 24 sept. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Confirmatory security agreement
    Créé le 30 sept. 2009
    Livré le 12 oct. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Banc of America Securities Limited
    Transactions
    • 12 oct. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    Security agreement
    Créé le 25 oct. 2007
    Livré le 14 nov. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All shares stocks debentures bonds or other securities and investments, any dividend, first floating charge all assets not at any time otherwise mortgaged charged or assigned by way of fixed mortgage charge or assignment under clause 2 of the deed,. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of America Securities Limited (Facility Agent)
    Transactions
    • 14 nov. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Security agreement
    Créé le 06 juil. 2004
    Livré le 15 juil. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due by any obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    1) pledge of shares: as security for the full and timely performance by the obligors of the secured obligations, the company granted a first ranking pledge in favour of the finance parties over the shares and the inherent rights, 2) pledge of shareholders' rights, as security for the full and timely performances by the obligors of the secured obligations;. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 15 juil. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 26 juin 2001
    Livré le 10 juil. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 10 juil. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 juin 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 28 juin 1996
    Livré le 10 juil. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land and buildings on the west side of rolston road hornsea east riding of yorkshire t/no. HS237817.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 10 juil. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 juin 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    FREEPORT (NOMINEE 5) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    14 juil. 2015Commencement of winding up
    25 août 2017Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Zelf Hussain
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Robert Nicholas Lewis
    Pricewaterhousecoopers Llp
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    Pricewaterhousecoopers Llp
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0