REVIVAL BLUE LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | REVIVAL BLUE LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 02788087 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe REVIVAL BLUE LIMITED ?
| Adresse du siège social | 66 High Street HP20 1SE Aylesbury England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de REVIVAL BLUE LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2025 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour REVIVAL BLUE LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 20 mai 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 03 juin 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 20 mai 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour REVIVAL BLUE LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2024 | 9 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Ruben Horatio Moggee en tant qu'administrateur le 30 juil. 2025 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Purmpal Singh Taggar en tant qu'administrateur le 30 juil. 2025 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Teresa Anne Owen en tant que directeur le 31 juil. 2025 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 20 mai 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2023 | 9 pages | AA | ||||||||||
Modification des détails de Mr Paul Hayman en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 28 juin 2024 | 2 pages | PSC04 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Paul Hayman le 28 juin 2024 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 20 mai 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 027880870015 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2022 | 9 pages | AA | ||||||||||
Notification de Paul Hayman en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 oct. 2022 | 2 pages | PSC01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 20 mai 2023 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 30 avr. 2022 | 9 pages | AA | ||||||||||
Certificat de changement de nom Company name changed chem-dry U.K. LIMITED\certificate issued on 02/11/22 | 3 pages | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Période comptable actuelle raccourcie du 30 avr. 2023 au 31 déc. 2022 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Stuart Pace en tant que directeur le 31 oct. 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Gold Round Limited en tant que directeur le 31 oct. 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Paul Hayman en tant qu'administrateur le 31 oct. 2022 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Rjp Secretaries Limited en tant que secrétaire le 31 oct. 2022 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Nomination de Mrs Teresa Anne Owen en tant qu'administrateur le 31 oct. 2022 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Ground Floor, Egerton House 68 Baker Street Weybridge Surrey KT13 8AL United Kingdom à 66 High Street Aylesbury HP20 1SE le 01 nov. 2022 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Notification de Revival Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 oct. 2022 | 2 pages | PSC02 | ||||||||||
Cessation de Gold Round Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 oct. 2022 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||
Cessation de Aghoco 1022 Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 oct. 2022 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de REVIVAL BLUE LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAYMAN, Paul | Administrateur | High Street HP20 1SE Aylesbury 66 England | England | British | 301751690002 | |||||||||
| MOGGEE, Ruben Horatio | Administrateur | High Street HP20 1SE Aylesbury 66 England | South Africa | South African | 339105840001 | |||||||||
| TAGGAR, Purmpal Singh | Administrateur | High Street HP20 1SE Aylesbury 66 England | England | British | 336524050001 | |||||||||
| GREY, Robin Francis | Secrétaire | 8 Keepers Gate Four Oaks B74 2NL Sutton Coldfield West Midlands | British | 33733380001 | ||||||||||
| HUTCHINSON, Angela Denise | Secrétaire | Southwold 36 Greenstiles Lane HU14 3NH Swanland North Humberside | British | 49658870002 | ||||||||||
| JOHNSTON, Iain | Secrétaire | 3 Scholes Park Road YO12 6RE Scarborough North Yorkshire | Uk | 702270001 | ||||||||||
| MAUGHAN, Anna | Secrétaire | 404 Chester Road Boldmere B73 5BS Sutton Coldfield | British | 53071850001 | ||||||||||
| THOMAS, Caroline Emma Roberts | Secrétaire | 5 Broomsleigh Street NW6 1QQ London | British | 154322040001 | ||||||||||
| WARD, Shirley | Secrétaire | 27 South Parade Leven HU17 5LJ Beverley North Humberside | British | 10362760001 | ||||||||||
| RJP SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | 68 Baker Street KT13 8AL Weybridge Ground Floor, Egerton House Surrey United Kingdom |
| 61999120002 | ||||||||||
| SEVERNSIDE SECRETARIAL LIMITED | Secrétaire désigné | 14-18 City Road CF24 3DL Cardiff | 900003990001 | |||||||||||
| ANNISON, Roger Neil | Administrateur | 19 Sackville Close HU17 8XF Beverley East Yorkshire | British | 69954830003 | ||||||||||
| BELK, Andrew John | Administrateur | Pen Plannau Moelfre SY10 7QL Llansilin North Wales | British | 65603000003 | ||||||||||
| BELL, Jonathan | Administrateur | Swinemoor Lane HU17 0LS Beverley Colonial House East Yorkshire United Kingdom | England | British | 123082590001 | |||||||||
| BENNETT, Martin John | Administrateur | St Peters Church Lane WR9 7AN Droitwich St Peters Manor Worcestershire | England | British | 69181180003 | |||||||||
| BROWN, David Mckelvie | Administrateur | 40 Bedford Road SG6 4DR Letchworth Hertfordshire | England | British | 3307440001 | |||||||||
| CABLE, Richard John | Administrateur | 8 Ambleside Walk LS22 6DP Wetherby West Yorkshire | British | 94183400001 | ||||||||||
| CARLISLE, Ian | Administrateur | The Clock House West End Road Box End MK43 8RT Kempston Rural Bedfordshire | England | British | 146715900001 | |||||||||
| DAVISON, Jonathan Charles | Administrateur | 75 Megson Way Walkington HU17 8YA Beverley North Humberside | England | British | 54751860002 | |||||||||
| DICKINSON, Louise | Administrateur | Caxton Road Fulwood PR2 9NZ Preston 6 Fulwood Park Lancashire | England | British | 139480580001 | |||||||||
| ELVIDGE, Paul Samuel | Administrateur | 237 The Ridgeway AL4 9XG St Albans Hertfordshire | United Kingdom | British | 41258150002 | |||||||||
| ELVIDGE, Rowland Edward | Administrateur | 1 York Road AL1 4PL St Albans Hertfordshire | British | 3297450001 | ||||||||||
| FORD, Simon | Administrateur | 9 Eversfield Close Kingswood HU7 3EQ Hull North Humberside | British | 117421040001 | ||||||||||
| GREY, Robin Francis | Administrateur | 5272 Goldspring Place Chillingwalk FOREIGN British Colombia V 2r 373 Canada | British | 33733380005 | ||||||||||
| HORTON, Alan Albert | Administrateur | 68 Baker Street KT13 8AL Weybridge Ground Floor, Egerton House Surrey United Kingdom | England | British | 182208240001 | |||||||||
| HUTCHINSON, Jonathan Mark | Administrateur | 7509 Dickenson Place V42 1JG Chilliwack Bc Canada | British | 35378250005 | ||||||||||
| JOHNSTON, Iain | Administrateur | 3 Scholes Park Road YO12 6RE Scarborough North Yorkshire | United Kingdom | Uk | 702270001 | |||||||||
| JOLLY, Adrian Richard | Administrateur | Caxton Road Fulwood PR2 9NZ Preston 6 Fulwood Park Lancashire | United Kingdom | British | 87664160001 | |||||||||
| LAKIN, William John | Administrateur | 56 Fairway ST16 3TN Stafford | United Kingdom | British | 54337740003 | |||||||||
| LEE, Peter Francis | Administrateur | Caxton Road Fulwood PR2 9NZ Preston 6 Fulwood Park Lancashire | England | British | 207608120001 | |||||||||
| LEES, Stuart | Administrateur | High Street KT7 0SR Thames Ditton 2 A C Court Surrey England | England | British | 70032700001 | |||||||||
| LETHEREN, Ralph | Administrateur | 44 Lichfield Close HU17 8PX Beverley East Yorkshire | England | British | 61272570001 | |||||||||
| LLOYD-JONES, Andrew Mark | Administrateur | Caxton Road Fulwood PR2 9NZ Preston 6 Fulwood Park Lancashire | England | British | 149155620001 | |||||||||
| OWEN, Teresa Anne | Administrateur | High Street HP20 1SE Aylesbury 66 England | England | British | 82172400002 | |||||||||
| PACE, Stuart | Administrateur | High Street HP20 1SE Aylesbury 66 England | England | British | 207506130003 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur REVIVAL BLUE LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revival Group Limited | 31 oct. 2022 | High Street HP20 1SE Aylesbury 66 England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Mr Paul Hayman | 31 oct. 2022 | High Street HP20 1SE Aylesbury 66 England | Non | ||||||||||
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Gold Round Limited | 18 avr. 2016 | 24 Old Bond Street W1S 4AW Mayfair 4th Floor London United Kingdom | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Aghoco 1022 Limited | 06 avr. 2016 | 68 Baker Street KT13 8AL Weybridge Ground Floor, Egerton House Surrey United Kingdom | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Gold Round Limited | 06 avr. 2016 | 24 Old Bond Street Mayfair W1S 4AW London 5th Floor United Kingdom | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0