TJH GROUP LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTJH GROUP LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02788607
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TJH GROUP LIMITED ?

    • (7415) /

    Où se situe TJH GROUP LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Lynton House
    Ackhurst Park Foxhole Road
    PR7 1NY Chorley
    Lancashire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de TJH GROUP LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CITY MANOR LIMITED10 févr. 199310 févr. 1993

    Quels sont les derniers comptes de TJH GROUP LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour TJH GROUP LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    legacy

    4 pagesMG02

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Comptes annuels établis au 31 mars 2011

    11 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 06 juin 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital09 juin 2011

    État du capital au 09 juin 2011

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2010

    9 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 06 juin 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur John Clement Kay le 06 juin 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Mark Lorimer Widders le 06 juin 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Miss Kathryn Revitt le 06 juin 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire John David Holden le 06 juin 2010

    1 pagesCH03

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2009

    9 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    3 pages403a

    Résolutions

    Resolutions
    10 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    11 pages395

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Approve board minutes 26/02/2009
    RES13

    Comptes établis au 31 mars 2008

    9 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    Comptes établis au 31 mars 2007

    9 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Qui sont les dirigeants de TJH GROUP LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HOLDEN, John David
    Lynton House
    Ackhurst Park Foxhole Road
    PR7 1NY Chorley
    Lancashire
    Secrétaire
    Lynton House
    Ackhurst Park Foxhole Road
    PR7 1NY Chorley
    Lancashire
    BritishAccountant137210330001
    KAY, John Clement
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Gleadhill House
    Lancashire
    Administrateur
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Gleadhill House
    Lancashire
    EnglandBritishDirector27891540001
    REVITT, Kathryn
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Gleadhill House
    Lancashire
    Administrateur
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Gleadhill House
    Lancashire
    United KingdomBritishCompany Solicitor49315020001
    WIDDERS, Mark Lorimer
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Gleadhill House
    Lancashire
    Administrateur
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Gleadhill House
    Lancashire
    EnglandBritishDirector2272770002
    KAY, John Clement
    7 Beechfield Road
    Mayfield
    PR25 3BG Leyland
    Lancashire
    Secrétaire
    7 Beechfield Road
    Mayfield
    PR25 3BG Leyland
    Lancashire
    British27891540001
    LIVESEY, Frederick Joseph
    Wal Mar
    Dawbers Lane, Euxton
    PR7 6ED Chorley
    Lancashire
    Secrétaire
    Wal Mar
    Dawbers Lane, Euxton
    PR7 6ED Chorley
    Lancashire
    BritishAccountant32145610004
    SIMMONDS, Gordon Graham
    Flat 1 20 Harrington Gardens
    SW7 4LS London
    Secrétaire
    Flat 1 20 Harrington Gardens
    SW7 4LS London
    British34446930003
    STOTT, St John
    17 Uplands Chase
    Fulwood
    PR2 7AW Preston
    Secrétaire
    17 Uplands Chase
    Fulwood
    PR2 7AW Preston
    BritishAccountant83024660001
    WIDDERS, Mark Lorimer
    12 Clovelly Drive
    Hillside
    PR8 3AJ Southport
    Merseyside
    Secrétaire
    12 Clovelly Drive
    Hillside
    PR8 3AJ Southport
    Merseyside
    BritishCompany Director2272770002
    GRAVITAS COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    25-31 Moorgate
    London
    Secrétaire désigné
    25-31 Moorgate
    London
    900007520001
    HEMMINGS, Trevor James
    The Penthouse Retraite De La Mielle
    Route De La Haule St Brelade
    JE3 8BA Jersey
    Channel Islands
    Administrateur
    The Penthouse Retraite De La Mielle
    Route De La Haule St Brelade
    JE3 8BA Jersey
    Channel Islands
    United KingdomBritishCompany Director65090920001
    JACKSON, Nigel Spencer
    27 St Johns Road
    NW11 0PE London
    Administrateur
    27 St Johns Road
    NW11 0PE London
    EnglandBritishSolicitor53249050001
    JOHNS, Michael Stephen Mackelcan
    22 Bowerdean Street
    London
    Administrateur désigné
    22 Bowerdean Street
    London
    British900007510001
    KAY, John Clement
    7 Beechfield Road
    Mayfield
    PR25 3BG Leyland
    Lancashire
    Administrateur
    7 Beechfield Road
    Mayfield
    PR25 3BG Leyland
    Lancashire
    EnglandBritishFinance Director27891540001
    KENT-LEMON, Nigel William
    29 Queensdale Road
    W11 4SB London
    Administrateur
    29 Queensdale Road
    W11 4SB London
    BritishCompany Director6467990001
    LIVESEY, Frederick Joseph
    Wal Mar
    Dawbers Lane, Euxton
    PR7 6ED Chorley
    Lancashire
    Administrateur
    Wal Mar
    Dawbers Lane, Euxton
    PR7 6ED Chorley
    Lancashire
    BritishAccountant32145610004
    STOTT, St John
    17 Uplands Chase
    Fulwood
    PR2 7AW Preston
    Administrateur
    17 Uplands Chase
    Fulwood
    PR2 7AW Preston
    United KingdomBritishAccountant83024660001
    WIDDERS, Mark Lorimer
    12 Clovelly Drive
    Hillside
    PR8 3AJ Southport
    Merseyside
    Administrateur
    12 Clovelly Drive
    Hillside
    PR8 3AJ Southport
    Merseyside
    EnglandBritishCompany Director2272770002

    TJH GROUP LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 27 févr. 2009
    Livré le 09 mars 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Secured Parties or Any Person Appointed as Security Trustee from Time to Time in Accordance Withe the Terms of the Facility Agreement
    Transactions
    • 09 mars 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 mars 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Supplemental debenture between the company and the governor and company of the bank of scotland as agent and security trustee for the secured parties (the security trustee)
    Créé le 15 sept. 2000
    Livré le 02 oct. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The actual contingent present and/or future obligations and liabilities of the company to any of the secured parties under or pursuant to the supplemental debenture and any of the financing documents
    Brèves mentions
    The company assigned (as continuing security in favour of the security trustee) (as defined) with full title guarantee by way of security all of its rights title and interest (both present and future) in all and each of the acquisition documents (as defined).
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 02 oct. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 avr. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture
    Créé le 01 oct. 1993
    Livré le 19 oct. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this charge and any of the financing documents (as therein defined)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotlandas Agent and Trustee for the Secured Parties (As Therein Defined)
    Transactions
    • 19 oct. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 avr. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0