NP CO REALISATIONS LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | NP CO REALISATIONS LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 02788727 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe NP CO REALISATIONS LIMITED ?
| Adresse du siège social | c/o AMY CHISMON 7 More London Riverside SE1 2RT London England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de NP CO REALISATIONS LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2015 |
Quels sont les derniers dépôts pour NP CO REALISATIONS LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation d'office | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office | 1 pages | GAZ1 | ||||||||||
Cessation de la nomination de David Patrick Dancaster en tant que directeur le 11 nov. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 103 Baker Street London W1U 6LN à C/O Amy Chismon 7 More London Riverside London SE1 2RT le 15 nov. 2016 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015 | 4 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 24 juin 2016 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Angad Paul en tant que directeur le 08 nov. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Certificat de changement de nom Company name changed nupac LIMITED\certificate issued on 29/12/15 | 4 pages | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Avis de changement de nom" | 2 pages | CONNOT | ||||||||||
Cessation de la nomination de Claire Smith en tant que directeur le 03 déc. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 24 juin 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014 | 6 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mrs Claire Smith en tant qu'administrateur le 17 févr. 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Georgina Mason en tant que directeur le 16 févr. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de David Patrick Dancaster en tant que directeur le 01 oct. 2014 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013 | 6 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 24 juin 2014 avec liste compl ète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012 | 6 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 24 juin 2013 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Satisfaction de la charge 2 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Matthew Hyland en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Miss Georgina Mason en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Michael Stilwell en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Michael Stilwell en tant que secrétaire | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2011 | 6 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de NP CO REALISATIONS LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAILEY, Stephen Geoffrey | Secrétaire | Abbey Gardens ST18 0RY Great Haywood 1 Staffordshire | British | 108203800001 | ||||||
| SMITH, John Godfrey | Secrétaire | Chequerfield House 32 Showell Lane Lower Penn WV4 4TT Wolverhampton West Midlands | British | 56051330001 | ||||||
| STEELE, Colin Grant | Secrétaire | Hindrum Cokes Lane HP8 4UD Chalfont St Giles Buckinghamshire | British | 10618480001 | ||||||
| STILWELL, Michael James | Secrétaire | 103 Baker Street London W1U 6LN | 150812690001 | |||||||
| RUTLAND SECRETARIES LIMITED | Secrétaire désigné | Rutland House 148 Edmund Street B3 2JR Birmingham | 900005290001 | |||||||
| BAILEY, Stephen Geoffrey | Administrateur | Abbey Gardens ST18 0RY Great Haywood 1 Staffordshire | England | British | 108203800001 | |||||
| BRITTON, Charles Jonathan | Administrateur | 19 High Street Avening GL8 8NF Tetbury Gloucestershire | British | 34146250001 | ||||||
| DANCASTER, David Patrick | Administrateur | 103 Baker Street W1U 6LN London Caparo House | England | British | 55380530001 | |||||
| DANCASTER, David Patrick | Administrateur | Baker Street W1U 6LN London Caparo House 103 | England | British | 55380530001 | |||||
| DICKINSON, John Alan | Administrateur | Moor Old Lodge 6 Moor Hall Drive Four Oaks B75 6LP Sutton Coldfield West Midlands | British | 28823880001 | ||||||
| HYLAND, Matthew William Edward | Administrateur | Popes Lane B69 4PJ Oldbury Caparo House West Midlands United Kingdom | United Kingdom | British | 152453950001 | |||||
| LEEK, James Anthony | Administrateur | 8 Atherton Drive Wimbledon SW19 5LB London | British | 11293430001 | ||||||
| MASON, Georgina | Administrateur | 103 Baker Street London W1U 6LN | England | British | 173302440001 | |||||
| PAUL, Angad, The Honorable | Administrateur | Ambika House 9a Portland Place W1B 1PR London The Penthouse Flat | United Kingdom | United Kingdom | 130813310001 | |||||
| ROBERTSON, Christopher Douglas | Administrateur | 18 Tudor Way CH3 5XQ Deva Park Chemor | British | 44883240001 | ||||||
| SMITH, Claire | Administrateur | 103 Baker Street London W1U 6LN | England | British | 195772990001 | |||||
| SMITH, John Godfrey | Administrateur | Chequerfield House 32 Showell Lane Lower Penn WV4 4TT Wolverhampton West Midlands | United Kingdom | British | 56051330001 | |||||
| STEELE, Colin Grant | Administrateur | Hindrum Cokes Lane HP8 4UD Chalfont St Giles Buckinghamshire | United Kingdom | British | 10618480001 | |||||
| STILWELL, Michael James | Administrateur | 103 Baker Street London W1U 6LN | United Kingdom | British | 142098630001 | |||||
| WALKER, Craig Anthony | Administrateur | 30 Corncrake Way OX26 6UE Bicester Oxfordshire | New Zealander | 75201130003 | ||||||
| WOOD, John Franklin | Administrateur | 27 Oak Hill Drive Edgbaston B15 3UG Birmingham West Midlands | England | British | 1397720001 | |||||
| RUTLAND DIRECTORS LIMITED | Administrateur désigné | Rutland House 148 Edmund Street B3 2JR Birmingham | 900005280001 |
NP CO REALISATIONS LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Security agreement | Créé le 30 juil. 2010 Livré le 06 août 2010 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from any obligor to the chargee and from any pension trustee obligor to the pension trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Fixed charge on purchased debts which fail to vest and on other debts and floating charge on proceeds of other debts | Créé le 31 janv. 2002 Livré le 14 févr. 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions (I) fixed equitable charge any debt(as defined in the agreement) purchased or purported to be purchased by the chargee pursuant to the agreement including its related rights (purchased debts) both present and future which fail to vest absolutely and effectively in the chargee for any reason and (ii) fixed equitable charge all amounts of indebtedness now or at any time owing or becoming due to the company on any account whatsoever incuding the related rights, other than any purchased debt (other debts) and (iii) floating charge such monies the company may receive in respect of the other debts. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0