SINGLEPOINT (4U) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSINGLEPOINT (4U) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02795597
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SINGLEPOINT (4U) LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe SINGLEPOINT (4U) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SINGLEPOINT (4U) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    4U LIMITED03 oct. 199403 oct. 1994
    CAUDWELL AIRTIME SERVICES LIMITED28 mai 199328 mai 1993
    HAJCO 117 LIMITED03 mars 199303 mars 1993

    Quels sont les derniers comptes de SINGLEPOINT (4U) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2019

    Quels sont les derniers dépôts pour SINGLEPOINT (4U) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 15 mars 2021

    • Capital: GBP 1
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Nomination de Mrs Janine Butler en tant qu'administrateur le 23 févr. 2021

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de David Nigel Evans en tant que directeur le 23 févr. 2021

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 14 févr. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    2 pagesMR04

    Déclaration de confirmation établie le 14 févr. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 mars 2019

    10 pagesAA

    legacy

    256 pagesPARENT_ACC

    legacy

    2 pagesAGREEMENT2

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    Nomination de Mr Andrew Michael Yorston en tant qu'administrateur le 02 avr. 2019

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Diane Josephine Mcintyre en tant que directeur le 16 mars 2019

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 14 févr. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2018

    5 pagesAA

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    2 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 1 en totalité

    2 pagesMR04

    Déclaration de confirmation établie le 14 févr. 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2017

    5 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 14 févr. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Qui sont les dirigeants de SINGLEPOINT (4U) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    VODAFONE CORPORATE SECRETARIES LIMITED
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Secrétaire
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    75473330004
    BUTLER, Janine
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    EnglandBritish277534960001
    YORSTON, Andrew Michael
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish257275320001
    BENNETT, Craig
    14 Conway Road
    Knypersley
    ST8 7AL Stoke On Trent
    Staffordshire
    Secrétaire
    14 Conway Road
    Knypersley
    ST8 7AL Stoke On Trent
    Staffordshire
    British34704080001
    HOWIE, Philip Robert Sutherland
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Secrétaire
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British77939460004
    HAJCO SECRETARIES LIMITED
    Berkeley Court
    Borough Road
    ST5 1TT Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    Secrétaire désigné
    Berkeley Court
    Borough Road
    ST5 1TT Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    900006890001
    ALLEN, Christian Philip Quentin
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British123612980001
    BARTON, John Michael
    30 Deerings Drive
    HA5 2NZ Pinner
    Middlesex
    Administrateur
    30 Deerings Drive
    HA5 2NZ Pinner
    Middlesex
    British34831450001
    BENNETT, Craig
    14 Conway Road
    Knypersley
    ST8 7AL Stoke On Trent
    Staffordshire
    Administrateur
    14 Conway Road
    Knypersley
    ST8 7AL Stoke On Trent
    Staffordshire
    British34704080001
    BIRNEY, James Gary
    Three Acre Wood
    Bridgemere Lane
    CW5 7PL Nantwich
    Cheshire
    Administrateur
    Three Acre Wood
    Bridgemere Lane
    CW5 7PL Nantwich
    Cheshire
    British86869670001
    BROCKLEHURST, Nigel
    1 The Hollyhocks
    Reading Road, Harwell
    OX11 0LX Didcot
    Oxfordshire
    Administrateur
    1 The Hollyhocks
    Reading Road, Harwell
    OX11 0LX Didcot
    Oxfordshire
    British83126790001
    BROWN, Peter
    Hawthorne Cottage
    19 Station Road Barlaston
    ST12 9DH Stoke-On-Trent
    Staffordshire
    Administrateur
    Hawthorne Cottage
    19 Station Road Barlaston
    ST12 9DH Stoke-On-Trent
    Staffordshire
    British58317370001
    CAUDWELL, Brian
    Fradswell Hall Fradswell
    ST18 0EX Stafford
    Staffordshire
    England
    Administrateur
    Fradswell Hall Fradswell
    ST18 0EX Stafford
    Staffordshire
    England
    British15920410002
    CAUDWELL, John David
    Broughton Hall
    Broughton
    ST21 6NS Eccleshall
    Staffordshire
    Administrateur
    Broughton Hall
    Broughton
    ST21 6NS Eccleshall
    Staffordshire
    EnglandBritish21185880002
    CHESWORTH, Paul
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British99525280001
    DARBY, Gavin John
    Rodona House
    Rodona Road St Georges Hill
    KT13 0NP Weybridge
    Surrey
    Administrateur
    Rodona House
    Rodona Road St Georges Hill
    KT13 0NP Weybridge
    Surrey
    EnglandBritish99277850001
    DAVIES, Andrew Mark
    19 Burnside
    WA15 0SG Halebarns
    Cheshire
    Administrateur
    19 Burnside
    WA15 0SG Halebarns
    Cheshire
    British86869710001
    DOBSON, Philip
    The Holtridge
    Norbury Nr Cholmondeley
    SY13 4JA Whitchurch
    Shropshire
    Administrateur
    The Holtridge
    Norbury Nr Cholmondeley
    SY13 4JA Whitchurch
    Shropshire
    British95437530001
    EVANS, David Nigel
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish134975040001
    EVANS, Mark
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British127017870001
    FINCH, Joanne Sarah
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish158146620001
    HUMPHREYS, Christopher Andrew
    Bowden House
    Bowden Lane, Marple
    SK6 6ND Stockport
    Cheshire
    Administrateur
    Bowden House
    Bowden Lane, Marple
    SK6 6ND Stockport
    Cheshire
    British77737010001
    JACKSON, Stephen Paul
    11 Pollard Drive
    Stapeley
    CW5 7EQ Nantwich
    Cheshire
    Administrateur
    11 Pollard Drive
    Stapeley
    CW5 7EQ Nantwich
    Cheshire
    British74412960001
    KEAYS, Helen Margaret
    The Old Vicarage
    Temple Grafton
    B49 6NX Alcester
    Warwickshire
    Administrateur
    The Old Vicarage
    Temple Grafton
    B49 6NX Alcester
    Warwickshire
    United KingdomBritish81221470001
    LANGSTON, Edward
    23 Manilla Road
    Clifton
    BS8 4EB Bristol
    Avon
    Administrateur
    23 Manilla Road
    Clifton
    BS8 4EB Bristol
    Avon
    UkBritish24471140001
    LEE, Simon Christopher
    Moorlands
    Harrow Road West
    RH4 3BH Dorking
    Surrey
    Administrateur
    Moorlands
    Harrow Road West
    RH4 3BH Dorking
    Surrey
    United KingdomBritish86697870001
    MCINTYRE, Diane Josephine, Cfo
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish173703620001
    MORROW, William Thomas
    5415 Blackhawk Drive
    Danville
    California 94506
    Usa
    Administrateur
    5415 Blackhawk Drive
    Danville
    California 94506
    Usa
    American95677940001
    NOWAK, Thomas, Dr
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomGerman174443800001
    PHILLIPS, Thomas Adam
    The Old Stable House Sun Farm
    Fradswell
    ST18 0EY Stafford
    Administrateur
    The Old Stable House Sun Farm
    Fradswell
    ST18 0EY Stafford
    United KingdomBritish55928770001
    PURKESS, Martin John
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    EnglandBritish139360020001
    READ, Nicholas Jonathan
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish87149560001
    SCHÄFER, Richard Wolfgang Henry
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish158146600001
    STEWART, Gregory Kenneth
    1 The Grove
    CW6 0GB Tarporley
    Cheshire
    Administrateur
    1 The Grove
    CW6 0GB Tarporley
    Cheshire
    British80561450001
    TOURNON, Emanuele
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomItalian103542080002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SINGLEPOINT (4U) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleUnited Kingdom (England)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement2227940
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    SINGLEPOINT (4U) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 03 févr. 2003
    Livré le 14 févr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 14 févr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 mars 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of charge
    Créé le 26 mars 2002
    Livré le 03 avr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All claims choses in action intellectual property and goodwill of the company present and future in so far as the same are comprised in the subscriber base arising under the service provider agreement and any other rights benefits or interests now and in the future comprised in the subscriber base. All book debts now and in the future owing to the company. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bt Cellnet
    Transactions
    • 03 avr. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 juil. 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of charge
    Créé le 03 janv. 2002
    Livré le 16 janv. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of first floating charge its undertaking and assets both present and future.
    Personnes ayant droit
    • Vodafone Limited
    Transactions
    • 16 janv. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 déc. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 22 déc. 1997
    Livré le 29 déc. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 29 déc. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 déc. 2005Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 22 mars 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 07 déc. 1994
    Livré le 15 déc. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 15 déc. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 déc. 2005Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 22 mars 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 19 sept. 1994
    Livré le 23 sept. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transactions
    • 23 sept. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 mars 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of charge
    Créé le 22 juil. 1993
    Livré le 24 juil. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in respect of the service provider agreements or either of them or any subsequent agreement (as defined)
    Brèves mentions
    The interest of the company in its customers from time to time concerning or inrelation to telecommunications services provided in whole or part on the vodafone network and all goodwill associated therewith (the subscriber base), first fixed charge all goodwill and uncalled capital intellectual property rights all book debts and other debts and first floating charge charge the remainder of the subscriber base. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Vodafone Limited
    Transactions
    • 24 juil. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 déc. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0