CANON GARTH LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCANON GARTH LIMITED
    Statut de la sociétéEn administration
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02800454
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CANON GARTH LIMITED ?

    • Commerce de gros non spécialisé de produits alimentaires, de boissons et de tabac (46390) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles

    Où se situe CANON GARTH LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Centre Block 4th Floor Central Court
    Knoll Rise
    BR6 0JA Orpington
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CANON GARTH LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    FORMINCOME LIMITED17 mars 199317 mars 1993

    Quels sont les derniers comptes de CANON GARTH LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le30 juin 2022
    Date d'échéance des prochains comptes31 mars 2023
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2020

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour CANON GARTH LIMITED ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au15 déc. 2022
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation29 déc. 2022
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au15 déc. 2021
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour CANON GARTH LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    30 pagesAM10

    Cessation de la nomination de Teunis Snoek en tant que directeur le 30 oct. 2024

    1 pagesTM01

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    32 pagesAM10

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    3 pagesAM19

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    33 pagesAM10

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    35 pagesAM10

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    3 pagesAM19

    La totalité de la propriété ou de l'entreprise a été libérée et ne fait plus partie de la charge 028004540021

    5 pagesMR05

    Déclaration des affaires avec le formulaire AM02SOA

    12 pagesAM02

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    33 pagesAM10

    Déclaration des affaires avec le formulaire AM02SOC

    4 pagesAM02

    Déclaration des affaires avec le formulaire AM02SOC

    4 pagesAM02

    Déclaration des affaires avec le formulaire AM02SOC

    4 pagesAM02

    Déclaration des affaires avec le formulaire AM02SOA

    12 pagesAM02

    Avis d'approbation réputée des propositions

    3 pagesAM06

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    47 pagesAM03

    Changement d'adresse du siège social de Alexander House 31-39 London Road Sevenoaks Kent TN13 1AR à Centre Block 4th Floor Central Court Knoll Rise Orpington BR6 0JA le 31 août 2022

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    5 pagesAM01

    Cessation de la nomination de Maximo Doukkali en tant que directeur le 27 juil. 2022

    1 pagesTM01

    Période comptable actuelle prolongée du 31 déc. 2021 au 30 juin 2022

    1 pagesAA01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Teunis Snoek le 15 févr. 2022

    2 pagesCH01

    Modification des détails de Mr Teunis Snoek en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 15 févr. 2022

    2 pagesPSC04

    Déclaration de confirmation établie le 15 déc. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2020

    34 pagesAA

    Inscription de la charge 028004540022, créée le 26 mai 2021

    34 pagesMR01

    Qui sont les dirigeants de CANON GARTH LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    KELMAN, David James
    Central Court
    Knoll Rise
    BR6 0JA Orpington
    Centre Block 4th Floor
    Administrateur
    Central Court
    Knoll Rise
    BR6 0JA Orpington
    Centre Block 4th Floor
    United KingdomBritishCommercial Manager158426530001
    SNOEK, Jamie Oliver
    31-39 London Road
    TN13 1AR Sevenoaks
    Alexander House
    Kent
    England
    Administrateur
    31-39 London Road
    TN13 1AR Sevenoaks
    Alexander House
    Kent
    England
    EnglandDutchSales Trader157991850001
    SNOEK, Nicholas Aarjan
    Central Court
    Knoll Rise
    BR6 0JA Orpington
    Centre Block 4th Floor
    Administrateur
    Central Court
    Knoll Rise
    BR6 0JA Orpington
    Centre Block 4th Floor
    United KingdomBritishProject Manager270677670001
    BELLWOOD, David Dean
    Alexander House
    31-39 London Road
    TN13 1AR Sevenoaks
    Kent
    Secrétaire
    Alexander House
    31-39 London Road
    TN13 1AR Sevenoaks
    Kent
    BritishChartered Accountant51609320001
    CONNOR, John
    Rosslyn
    High Street
    TN5 7AS Tilehurst
    Secrétaire
    Rosslyn
    High Street
    TN5 7AS Tilehurst
    BritishFinance Director96761630002
    GILBERT, Richard
    Alexander House
    31-39 London Road
    TN13 1AR Sevenoaks
    Kent
    Secrétaire
    Alexander House
    31-39 London Road
    TN13 1AR Sevenoaks
    Kent
    181201690001
    JORDAN, Peter Christopher
    Alexander House
    31-39 London Road
    TN13 1AR Sevenoaks
    Kent
    Secrétaire
    Alexander House
    31-39 London Road
    TN13 1AR Sevenoaks
    Kent
    162436820001
    RHODES, Kevin John
    Alexander House
    31-39 London Road
    TN13 1AR Sevenoaks
    Kent
    Secrétaire
    Alexander House
    31-39 London Road
    TN13 1AR Sevenoaks
    Kent
    190135240001
    THORNTON, Richard
    Tree Tops
    Street End Lane Broad Oak
    TN21 8RX Heathfield
    East Sussex
    Secrétaire
    Tree Tops
    Street End Lane Broad Oak
    TN21 8RX Heathfield
    East Sussex
    BritishCompany Secretary100268930001
    WHITE, Gary Martin
    24 Lytchett Way
    Upton
    BH16 5LS Poole
    Dorset
    Secrétaire
    24 Lytchett Way
    Upton
    BH16 5LS Poole
    Dorset
    British34082910001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BELLWOOD, David Dean
    Alexander House
    31-39 London Road
    TN13 1AR Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    Alexander House
    31-39 London Road
    TN13 1AR Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritishNon Exec51609320001
    CALKIN, Peter Shand
    The Malthouse
    Donhead
    SP7 9DN Shaftesbury
    Dorset
    Administrateur
    The Malthouse
    Donhead
    SP7 9DN Shaftesbury
    Dorset
    BritishMerchant5789260001
    COMPTON, Christopher Michael
    107 The Highway
    Chelsfield
    BR6 9DQ Orpington
    Kent
    Administrateur
    107 The Highway
    Chelsfield
    BR6 9DQ Orpington
    Kent
    EnglandBritishCompany Director11552100001
    CONNOR, John
    Rosslyn
    High Street
    TN5 7AS Tilehurst
    Administrateur
    Rosslyn
    High Street
    TN5 7AS Tilehurst
    BritishFinance Director96761630002
    DOUKKALI, Maximo
    Alexander House
    31-39 London Road
    TN13 1AR Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    Alexander House
    31-39 London Road
    TN13 1AR Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritishProject Manager191551590001
    GILBERT, Richard
    Alexander House
    31-39 London Road
    TN13 1AR Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    Alexander House
    31-39 London Road
    TN13 1AR Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritishChartered Accountant86461880001
    GREEF, David
    84 Ridgeway Crescent
    BR6 9QP Orpington
    Kent
    Administrateur
    84 Ridgeway Crescent
    BR6 9QP Orpington
    Kent
    United KingdomBritishDirector107534040001
    HARRIS, Catherine Jane
    Alexander House
    31-39 London Road
    TN13 1AR Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    Alexander House
    31-39 London Road
    TN13 1AR Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritishLogistics Director190995710001
    JORDAN, Peter Christopher
    Alexander House
    31-39 London Road
    TN13 1AR Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    Alexander House
    31-39 London Road
    TN13 1AR Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritishFinance Director162435450001
    READ, Michael James
    122 London Road
    TN13 1BA Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    122 London Road
    TN13 1BA Sevenoaks
    Kent
    AustralianTechnical59081030002
    SNOEK, Teunis
    Central Court
    Knoll Rise
    BR6 0JA Orpington
    Centre Block 4th Floor
    Administrateur
    Central Court
    Knoll Rise
    BR6 0JA Orpington
    Centre Block 4th Floor
    United KingdomDutchCompany Director83274220007
    THORNTON, Richard
    Tree Tops
    Street End Lane Broad Oak
    TN21 8RX Heathfield
    East Sussex
    Administrateur
    Tree Tops
    Street End Lane Broad Oak
    TN21 8RX Heathfield
    East Sussex
    EnglandBritishCompany Director100268930001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur désigné
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CANON GARTH LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Continental Trade And Commodity Services Limited
    London Road
    TN13 1AR Sevenoaks
    Alexander House
    England
    06 avr. 2016
    London Road
    TN13 1AR Sevenoaks
    Alexander House
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementRegister Of Companies In England And Wales
    Numéro d'enregistrement01315953
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    Mr Teunis Snoek
    Central Court
    Knoll Rise
    BR6 0JA Orpington
    Centre Block 4th Floor
    06 avr. 2016
    Central Court
    Knoll Rise
    BR6 0JA Orpington
    Centre Block 4th Floor
    Non
    Nationalité: Dutch
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.

    CANON GARTH LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 26 mai 2021
    Livré le 27 mai 2021
    En cours
    Brève description
    None.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Kimura Commodity Trade Finance Fund Limited
    Transactions
    • 27 mai 2021Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 10 juil. 2018
    Livré le 30 juil. 2018
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Wyelands Bank PLC
    Transactions
    • 30 juil. 2018Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 18 juil. 2023L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré et ne fait plus partie de la charge (MR05)
    A registered charge
    Créé le 06 juil. 2018
    Livré le 10 juil. 2018
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Kimura Master Fund Limited
    Transactions
    • 10 juil. 2018Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 22 août 2013
    Livré le 11 sept. 2013
    En cours
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • British Arab Commercial Bank PLC
    Transactions
    • 11 sept. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 20 août 2013
    Livré le 09 sept. 2013
    En cours
    Brève description
    None.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • British Arab Commercial Bank PLC
    Transactions
    • 09 sept. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    Debenture
    Créé le 04 août 2010
    Livré le 06 août 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 06 août 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    First party charge over credit balances
    Créé le 16 juin 2010
    Livré le 23 juin 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All monies from time to time held to the credit of the mortgagor by the bank on any current deposit or other account or accounts or under any deposit receipt.
    Personnes ayant droit
    • Bank Leumi (UK) PLC
    Transactions
    • 23 juin 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 05 janv. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Trade finance security agreement
    Créé le 10 mars 2010
    Livré le 31 mars 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Floating charge over all moneys , other receivables policies and contracts of insurance, hypothecation of goods and documents see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bnp Paribas (Suisse Sa)
    Transactions
    • 31 mars 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 11 juin 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 13 janv. 2006
    Livré le 18 janv. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank Leumi (UK) PLC
    Transactions
    • 18 janv. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 janv. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Account charge
    Créé le 04 janv. 2006
    Livré le 23 janv. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The deposit and all right title and interest in the deposit. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Kbc Bank N.V. London Branch
    Transactions
    • 23 janv. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 juin 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 04 janv. 2006
    Livré le 21 janv. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 21 janv. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 mars 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignment of receivables
    Créé le 04 janv. 2006
    Livré le 20 janv. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All rights under any contracts any breach of any contract under any policy of insurance. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 20 janv. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 mars 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 21 déc. 2005
    Livré le 06 janv. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Kbc Bank N.V London Branch
    Transactions
    • 06 janv. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 juin 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 24 avr. 2003
    Livré le 13 mai 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill and uncalled capital, stocks, shares, copyrights, patents, fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Kbc Bank Nv, London Branch
    Transactions
    • 13 mai 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 juin 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Collection account charge
    Créé le 24 avr. 2003
    Livré le 13 mai 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The right, title and interest in the deposit.
    Personnes ayant droit
    • Kbc Bank N.V. London Branch
    Transactions
    • 13 mai 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 juin 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    General charge of receivables and contract rights
    Créé le 28 mars 2003
    Livré le 16 avr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The company's right title benefits and interest in and to all monies payable. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Absa Bank Limited
    Transactions
    • 16 avr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 mars 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 28 mars 2003
    Livré le 16 avr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Absa Bank Limited
    Transactions
    • 16 avr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 mars 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 11 oct. 2001
    Livré le 16 oct. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to a facility letter dated 19TH december 1997 and the debenture
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over all property assets and rights present and future including plant machinery and equipment debts goodwill uncalled capital intellectual property. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ing Bank N.V.
    Transactions
    • 16 oct. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 nov. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of general pledge, hypothecation and charge
    Créé le 28 sept. 2001
    Livré le 05 oct. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    1).All goods and produce delivered into the actual or constructive possession of ing bank N.V. london branch and all goods financed by the bank through documentary credit or other transaction 2). all bills of lading, receipts or other documents relating to the goods described in (1) above and which are delivered into the actual or constructive possession of the bank 3). the proceeds of sale of any of the goods or documents described in (1) or (2) above 4). all contracts entered into by the company with respect to any goods which have been financed by the bank (including all letter of credit guarantees and contracts of insurance opened or issued with respect to such goods).
    Personnes ayant droit
    • Ing Bank N.V. London Branch
    Transactions
    • 05 oct. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 nov. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 14 févr. 2000
    Livré le 15 févr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to a facility letter dated 19/12/97 and the debenture
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bhf-Bank Ag
    Transactions
    • 15 févr. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 nov. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 04 janv. 1999
    Livré le 09 janv. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the "$10,000,000 facility letter" dated 8TH december 1998 between the company and the borrower as amended varied novated supplemented or replaced and the debenture
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bayerische Hypo-Und-Vereinsbank Ag, London Branch
    Transactions
    • 09 janv. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 janv. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    General letter of pledge,hypothecation and charge
    Créé le 09 févr. 1998
    Livré le 16 févr. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All goods and produce delivered into the actual or constructive possession of the bank and all goods financed by the bank all bills receipts or other documents proceeds of sale all contracts. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bhf-Bank Ag
    Transactions
    • 16 févr. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 nov. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    CANON GARTH LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    16 août 2022Administration started
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Benjamin Stanyon
    Centre Block 4th Floor Central Court
    Knoll Rise
    BR6 0JA Orpington
    practitioner
    Centre Block 4th Floor Central Court
    Knoll Rise
    BR6 0JA Orpington
    Nedim Patrick Ailyan
    Centre Block 4th Floor Central Court
    Knoll Rise
    BR6 0JA Orpington
    practitioner
    Centre Block 4th Floor Central Court
    Knoll Rise
    BR6 0JA Orpington

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0