CA 2010 PLC

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCA 2010 PLC
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété anonyme cotée en bourse
    Numéro de société 02808331
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CA 2010 PLC ?

    • (7415) /

    Où se situe CA 2010 PLC ?

    Adresse du siège social
    The Valley
    Floyd Road
    SE7 8BL London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CA 2010 PLC ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CHARLTON ATHLETIC PLC06 janv. 199406 janv. 1994
    YPCS 25 P.L.C.13 avr. 199313 avr. 1993

    Quels sont les derniers comptes de CA 2010 PLC ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour CA 2010 PLC ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Cessation de la nomination de Richard Hatter en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de David White en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Sale of entire iss share cap/sec 190(1) 23/08/2010
    RES13
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10

    Certificat de changement de nom

    Company name changed charlton athletic PLC\certificate issued on 10/09/10
    2 pagesCERTNM
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Avis de changement de nom"

    2 pagesCONNOT

    Cessation de la nomination de Derek Chappell en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de David Hughes en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Robert Whitehand en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de David Sumners en tant que directeur

    2 pagesTM01

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    Nomination de Stephen Kavanagh en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    État du capital après une attribution d'actions au 05 août 2010

    • Capital: GBP 31,947,961.5
    8 pagesSH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 avr. 2010 avec liste étendue des actionnaires

    26 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Richard Alan Murray Obodynski le 15 janv. 2010

    3 pagesCH01

    legacy

    pagesANNOTATION

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10
    capital

    Résolutions

    Re section 560 ca 2006 30/12/2009
    RES13

    Qui sont les dirigeants de CA 2010 PLC ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    VERTEX LAW (CO SECRETARIAL) LIMITED
    Kings Hill Avenue
    Kings Hill
    ME19 4UD West Malling
    23
    Kent
    Secrétaire
    Kings Hill Avenue
    Kings Hill
    ME19 4UD West Malling
    23
    Kent
    102565320003
    BUTLER-GALLIE, Stuart
    Bethersden
    TN26 3EW Ashford
    Baylisden House
    Kent
    Administrateur
    Bethersden
    TN26 3EW Ashford
    Baylisden House
    Kent
    EnglandBritish96783000001
    KAVANAGH, Stephen Andrew
    Floyd Road
    SE7 8BL London
    The Valley
    Administrateur
    Floyd Road
    SE7 8BL London
    The Valley
    EnglandBritish153739440001
    MURRAY OBODYNSKI, Richard Alan
    66-70 Coombe Road
    KT3 4QW New Maldon
    Nunn Hayward
    Surrey
    Administrateur
    66-70 Coombe Road
    KT3 4QW New Maldon
    Nunn Hayward
    Surrey
    EnglandBritish46792500008
    FULLER, Jonathan Tom Telford
    Rose Cottage
    Twitton Lane
    TN14 5JS Otford
    Kent
    Secrétaire
    Rose Cottage
    Twitton Lane
    TN14 5JS Otford
    Kent
    British52304380001
    ROBINSON, Keith Marshall
    15 Green Lane
    Oxhey
    WD19 4NL Watford
    Secrétaire
    15 Green Lane
    Oxhey
    WD19 4NL Watford
    British8282250001
    BRACHERS LIMITED
    Somerfield House, 59 London Road
    ME16 8JH Maidstone
    Kent
    Secrétaire
    Somerfield House, 59 London Road
    ME16 8JH Maidstone
    Kent
    80957680001
    DAVIES LAVERY COMPANY SECRETARIAL LIMITED
    Victoria Court
    17-21 Ashford Road
    ME14 5FA Maidstone
    Kent
    Secrétaire
    Victoria Court
    17-21 Ashford Road
    ME14 5FA Maidstone
    Kent
    87634940001
    YORK PLACE COMPANY SECRETARIES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    Secrétaire désigné
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000880001
    ALWEN, Roger Norman
    11 Bywater Street
    Chelsea
    SW3 4XD London
    Administrateur
    11 Bywater Street
    Chelsea
    SW3 4XD London
    British14306470002
    BONE, Gregory Peter
    17 Brassey Hill
    Limpsfield
    RH8 0ES Oxted
    Surrey
    Administrateur
    17 Brassey Hill
    Limpsfield
    RH8 0ES Oxted
    Surrey
    British26854940002
    CHAPPELL, Derek Guy
    13 Walton Place
    SW3 1RJ London
    Administrateur
    13 Walton Place
    SW3 1RJ London
    EnglandBritish32697520004
    CLARKE, Stephen Thomas
    20 Porcupine Close
    Mottingham
    SE9 3AE London
    Administrateur
    20 Porcupine Close
    Mottingham
    SE9 3AE London
    United KingdomBritish33772930001
    COLLINS, Richard Denis
    33b Garden Road
    BR1 3LU Bromley
    Kent
    Administrateur
    33b Garden Road
    BR1 3LU Bromley
    Kent
    British1811300001
    FRANKLIN, Gideon Benjamin Cecil
    22 Ringmore Rise
    SE23 3DE London
    Administrateur
    22 Ringmore Rise
    SE23 3DE London
    United KingdomBritish69257060003
    GRADE, Michael Ian
    6 Westover Road
    SW18 2RG London
    Administrateur
    6 Westover Road
    SW18 2RG London
    EnglandBritish71289920004
    HALLETT, Brian James
    39 Old Garden Close
    Locks Heath
    SO31 6RN Southampton
    Hampshire
    Administrateur
    39 Old Garden Close
    Locks Heath
    SO31 6RN Southampton
    Hampshire
    United KingdomBritish9715270001
    HATTER, Maurice, Sir
    38 Queens Grove
    NW8 6HH London
    Administrateur
    38 Queens Grove
    NW8 6HH London
    EnglandBritish36506710001
    HATTER, Richard Mark
    Hamilton Terrace
    St John's Wood
    NW8 9UJ London
    54
    Administrateur
    Hamilton Terrace
    St John's Wood
    NW8 9UJ London
    54
    EnglandEnglish67030840002
    HUGHES, David John
    Sterling Street
    SW7 1HN London
    8
    Administrateur
    Sterling Street
    SW7 1HN London
    8
    EnglandBritish49400910005
    HUGHES, David John
    Vitol Sa
    Bowater House 68 Knightsbridge
    SW1X 7LT London
    Administrateur
    Vitol Sa
    Bowater House 68 Knightsbridge
    SW1X 7LT London
    British49400910001
    NORRIS, Craig Victor
    156 Humber Road
    Blackheath
    SE3 7EF London
    Administrateur
    156 Humber Road
    Blackheath
    SE3 7EF London
    British43819750002
    ROBINSON, Keith Marshall
    15 Green Lane
    Oxhey
    WD19 4NL Watford
    Administrateur
    15 Green Lane
    Oxhey
    WD19 4NL Watford
    United KingdomBritish8282250001
    SIMONS, Martin Alan
    48 Shooters Hill Road
    Blackheath
    SE3 7BG London
    Administrateur
    48 Shooters Hill Road
    Blackheath
    SE3 7BG London
    British15777410001
    STEVENS, Michael Clifford
    Northside 36 Southborough Road
    Bickley
    BR1 2EB Bromley
    Kent
    Administrateur
    Northside 36 Southborough Road
    Bickley
    BR1 2EB Bromley
    Kent
    British25614630001
    SUMNERS, David Colin, Dr
    The Old Vicarage
    2 Mountfort Crescent
    N1 1JW London
    Administrateur
    The Old Vicarage
    2 Mountfort Crescent
    N1 1JW London
    United KingdomBritish47150540002
    UFTON, Derek Gilbert
    88 Madeira Avenue
    BR1 4AS Bromley
    Kent
    Administrateur
    88 Madeira Avenue
    BR1 4AS Bromley
    Kent
    British15366180001
    WHITE, David
    Watts Lane
    BR7 5PJ Chislehurst
    The Briars
    Kent
    Administrateur
    Watts Lane
    BR7 5PJ Chislehurst
    The Briars
    Kent
    United KingdomBritish138647910001
    WHITEHAND, Robert Charles
    Dunstall Priory Shoreham Road
    Shoreham
    TN14 7UE Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    Dunstall Priory Shoreham Road
    Shoreham
    TN14 7UE Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritish54419430001
    YORK PLACE COMPANY NOMINEES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur désigné
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000870001
    YORK PLACE COMPANY SECRETARIES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur désigné
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000880001

    CA 2010 PLC a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 25 sept. 2009
    Livré le 29 sept. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • David Hughes
    Transactions
    • 29 sept. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 août 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 25 sept. 2009
    Livré le 29 sept. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • David Sumners
    Transactions
    • 29 sept. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 sept. 2009
    Debenture
    Créé le 25 sept. 2009
    Livré le 29 sept. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • David White
    Transactions
    • 29 sept. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 sept. 2009
    • 25 août 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 19 juin 2009
    Livré le 26 juin 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Sir Maurice Hatter
    Transactions
    • 26 juin 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 août 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 04 mars 2009
    Livré le 20 mars 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Richard Alan Murray
    Transactions
    • 20 mars 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 août 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 04 mars 2009
    Livré le 14 mars 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Derek Chappell
    Transactions
    • 14 mars 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 août 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 04 mars 2009
    Livré le 14 mars 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • 56 Developments LLP
    Transactions
    • 14 mars 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 août 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 19 mars 2008
    Livré le 08 avr. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the to the bondholders on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Richard Alan Murray and Derek Chappell
    Transactions
    • 08 avr. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 août 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 31 déc. 2007
    Livré le 10 janv. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Richard Alan Murray
    Transactions
    • 10 janv. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 mai 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 08 mai 2007
    Livré le 09 mai 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bolistrom Limited
    Transactions
    • 09 mai 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 mai 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 08 mai 2007
    Livré le 09 mai 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Sir Maurice Hatter
    Transactions
    • 09 mai 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 mai 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 08 mai 2007
    Livré le 09 mai 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • David Colin Sumners
    Transactions
    • 09 mai 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 mai 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 08 mai 2007
    Livré le 09 mai 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Robert Charles Whitehand
    Transactions
    • 09 mai 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 mai 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 08 mai 2007
    Livré le 09 mai 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Derek Chappell
    Transactions
    • 09 mai 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 mai 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 25 mai 1999
    Livré le 03 juin 1999
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 03 juin 1999Enregistrement d'une charge (395)
    Mortgage debenture
    Créé le 29 mars 1999
    Livré le 13 avr. 1999
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Legal mortgage over the property; fixed charge over f/h & l/h property both present and future together with all fixtures and its goodwill; a floating charge over the undertaking and all its (other) property and assets whatsoever.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lombard North Central PLC
    Transactions
    • 13 avr. 1999Enregistrement d'une charge (395)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0